MFI PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMFI PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01410500
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MFI PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich MFI PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MFI PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRUSHELFCO (NO. 205) LIMITED19. Jan. 197919. Jan. 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MFI PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis19. Mai 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für MFI PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    10 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Okt. 2013

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Apr. 2013

    13 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Apr. 2013

    18 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Okt. 2012

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Apr. 2012

    10 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Okt. 2011

    5 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB am 26. Mai 2011

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Apr. 2011

    6 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ am 11. März 2011

    2 SeitenAD01

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenF10.2

    Wer sind die Geschäftsführer von MFI PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Sekretär
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    FAVELL, Gary Alan
    Brickendon Lane
    Brickendon
    SG13 8NU Hertford
    Bourne Orchard
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brickendon Lane
    Brickendon
    SG13 8NU Hertford
    Bourne Orchard
    United Kingdom
    EnglandBritish107699240002
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Geschäftsführer
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    HUGHES, Gerard Maxwell
    39 Clonmel Road
    SW6 5BL London
    Sekretär
    39 Clonmel Road
    SW6 5BL London
    British70698270003
    OKAI, Maade
    3a Gainsborough Road
    N12 8AA Finchley
    London
    Sekretär
    3a Gainsborough Road
    N12 8AA Finchley
    London
    British84554260001
    THOMSON, Hamish Noel Michael
    Widmere Cottage
    Pheasants
    RG9 6NH Hambleden On Thames
    Oxfordshire
    Sekretär
    Widmere Cottage
    Pheasants
    RG9 6NH Hambleden On Thames
    Oxfordshire
    British21957690001
    BROCK, David Michael
    Windyridge
    44 Beechwood Avenue
    HP6 6PN Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Windyridge
    44 Beechwood Avenue
    HP6 6PN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish22121020001
    CLIFFORD-KING, Martin
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British77456620001
    HANCOCK, John Michael
    Mfi Furniture Group Plc
    333 The Hyde, Edgeware Road
    NW9 6TD London
    Geschäftsführer
    Mfi Furniture Group Plc
    333 The Hyde, Edgeware Road
    NW9 6TD London
    American,British63302170004
    HUNT, Derek Simpson
    Hunters Oak
    Asheridge
    HP5 2UV Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Hunters Oak
    Asheridge
    HP5 2UV Chesham
    Buckinghamshire
    British18973420001
    MACDONALD, Gordon
    2 Magnolia Dene
    Hazlemere
    HP15 7QE High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Magnolia Dene
    Hazlemere
    HP15 7QE High Wycombe
    Buckinghamshire
    British61899480001
    MCMANUS, James
    Riversmeet
    4 Amy Lane
    HP5 1NA Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Riversmeet
    4 Amy Lane
    HP5 1NA Chesham
    Buckinghamshire
    British33209620001
    MURPHY, Susan Margaret
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish49990470002
    O'CONNELL, John Joseph
    15 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    15 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    British21957700002
    RANDALL, John David
    335 The Hyde Edgware Road
    Colindale
    NW9 6TD London
    Geschäftsführer
    335 The Hyde Edgware Road
    Colindale
    NW9 6TD London
    British67962100001
    REGAN, Geoff
    176 Kings Hall Road
    BR3 1LJ Beckenham
    Kent
    Geschäftsführer
    176 Kings Hall Road
    BR3 1LJ Beckenham
    Kent
    British101040780001
    ROBSON, Mark Philip William
    14 Bathgate Road
    SW19 5PN London
    Geschäftsführer
    14 Bathgate Road
    SW19 5PN London
    United KingdomBritish63367580002
    WILKINSON, Christopher Robert
    112 Gregories Road
    HP9 1HT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    112 Gregories Road
    HP9 1HT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69562000001

    Hat MFI PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. März 2007
    Geliefert am 03. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 november 2006 and
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 02. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land extending in the parish of dunfermline and county of fife,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mep Mayflower Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 november 2006 and
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 02. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land extending in the parish of dunfermline and county of fife,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mep Mayflower (Holdings) Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 27. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mep Mayflower (Holdings) Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 27. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mep Mayflower Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First supplemental legal charge which is supplemental to a debenture dated 17 february 2006 and
    Erstellt am 04. Apr. 2006
    Geliefert am 13. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from mfi UK limited and howden joinery limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property at manchester road bolton, t/n's GM379092 GM956984,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited (As Security Trustee for the Pension Trustees)
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First supplemental legal charge
    Erstellt am 04. Apr. 2006
    Geliefert am 07. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H manchester road bolton t/nos GM379092 and GM956984 and land at concorde way eaglecliffe stockton on tees t/nos CE50479, CE160392 and CE117024. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 21/02/06 and
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 04. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the plot or area of ground extending to one acre and forty one decimal or one hundredth parts of an acre or thereby imperial standard measure at milesmark in the parish of dunfermline and county of fife together with fittings and fixtures, privileges and pertinents, whole right title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 21/02/06 and
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 03. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that plot or area of ground extending to one acre and forty one decimal or one hundreth parts of an acre or thereby imperial standard measure at milemark in the parish of dunfermline and county of fife. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 03. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of debenture
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 25. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from mfi UK limited and howden joinery limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the howdens shares being the issued share capital in howdens specified as belonging to orchardlight and all other stocks shares or securities the mortgaged properties being f/h land and buildings at the hyde edgware road london t/nos MX376998 NGL455590 f/h thorpe road howden t/nos HS263751 HS121975 and f/h unit 2 atlantic street altrincham broadheath t/no GM372952 (for details of further properties charged please refer to the form 395) and each floating charge property and all its other assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited (In Its Capacity as Security Trustee for the Pension Trustees)
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 21. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H southon house 333 the hyde edgware road london t/no mx 376998 and ngl 455590, f/h thorpe road howden t/nos hs 263751 and hs 121975 and f/h unit 2 atlantic street altrincham street altrincham broadheath t/no gm 372952. for details of further properties charged please refer to deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burndale Financial Limited (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 23. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 26. Okt. 1999
    Geliefert am 05. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 16. Apr. 1992
    Geliefert am 01. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The monies secured by a composite guarantee and debenture dated 16/11/87 due to the chargee as trustee for the beneficiaries
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 6 parc trostre llanelli dyfed (please see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 01. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Feb. 1992
    Geliefert am 03. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in a mortgage or charge dated 19/11/87.
    Kurze Angaben
    L/H property situated and k/a part of shannon corner new malden surry. And all buildings and fixtures (including trade fixtures).
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC(As Security Agent Acting as Trustee for the Beneficiaries as Defined).
    Transaktionen
    • 03. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 06. Jan. 1992
    Geliefert am 07. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company to the law debenture trust corporation PLC as security agent acting as trustee for the beneficiaries as defined under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    L/H property part of unit J1 liver ind est aintree,merseyside,liverpool t/no.ms 94166 and all buildings etc.
    Berechtigte Personen
    • See Form 395 for Details
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 01. Okt. 1991
    Geliefert am 02. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H unit A2 old brighton road, lowfield heath, crawley, west sussex, title no sgl 268833 & all buildings & fixtures (including trade fixtures).
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Security Agent Acting as Trustee Fotr the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 17. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 19. Aug. 1991
    Geliefert am 21. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent as trustee for the beneficianies (as defined).
    Kurze Angaben
    L/H part of unit a, 190/200 thornton road, croydon title no sgl 268833 & all buildings & fixtures (including trade fixtures).
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 26. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit agreement
    Erstellt am 09. Juli 1991
    Geliefert am 10. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 30/1/79
    Kurze Angaben
    The sum of £182,500 to be held by the landlord on deposit in a separte designated account at the bennet scotland.
    Berechtigte Personen
    • The Scottish Provident Institution
    Transaktionen
    • 10. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. Apr. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Mai 1991
    Geliefert am 05. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due to become due from mfi furniture group limited under the terms of a composite guarantee and debenture dated 16.11.87 and this charge. To the chargee.
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 138, 140 and 142 london road portsmouth hampshire (and all buildings & fixtures (including trade fixtures) from time to time on the property).
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trlist Corporation Plcas Trustee for the Beneficiaries (As Theriendefined)
    Transaktionen
    • 05. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Apr. 1991
    Geliefert am 18. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from mfi furniture group limited 1 to the chargee. As trustee for the beneficiaries (as defined) under the terms of the composite guarantee & debenture dated 16/11/87
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 2 london road, newbury & all buildings & fixtures (including trade fixtures) from time to time on the property (see form 395 or full details).
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 18. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Feb. 1991
    Geliefert am 02. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee the security agent as trustee for the beneficiaries (as defined) under the terms of the composite guarantee and debenture dated 16/11/87
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 4 retail park southend arterial road, basildon essex & all building and fixtures (including trade fixtures rom time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporationthe Security Agent as Trustee for the Beneficiaries (As Shown on Form 395)
    Transaktionen
    • 02. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Jan. 1991
    Geliefert am 23. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries as defined pursuant to a facility agreement dated 13.11.87 and under the terms of the debenture.
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 7 withybush retail park haverfordwest, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) (see form 395 for complete details).
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee debenture
    Erstellt am 20. Nov. 1990
    Geliefert am 28. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 2 chapel lane selly oak west midlands, together with all buildings fixtures (including trade fixtures) (see rom 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Okt. 1990
    Geliefert am 01. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the law debenture trust corppration PLC as trustee for the beneficiaries under the terms of a composite guarante dated 16/11/87
    Kurze Angaben
    Unit b portview road, avonmouth, bristol, avon and all buildings and fixtures (including trade fixtures) from time to time on the property. (See form 395, pages 5 and 6 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 1990
    Geliefert am 20. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as under the terms of a composite guarantee and debenture dated 16/11/87
    Kurze Angaben
    Unit knaves beech business centre high wycombe and all buildings at fixture including trade fixtures.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporatin Plcas Trustee for the Beneficicres
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MFI PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Apr. 2010Ende der Verwaltung
    06. Okt. 2008Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Fraser James Gray
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Praktiker
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Kroll
    3rd Floor
    LS1 4DL Wellington Plaza
    31 Wellington Street Leeds
    Praktiker
    Kroll
    3rd Floor
    LS1 4DL Wellington Plaza
    31 Wellington Street Leeds
    Simon Jonathan Appell
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    09. März 2014Aufgelöst am
    13. Apr. 2010Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Fraser James Gray
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Simon Jonathan Appell
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0