ABBEYCREST PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameABBEYCREST PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01411796
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ABBEYCREST PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich ABBEYCREST PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hollins Mount
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ABBEYCREST PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ABBEYCREST MANUFACTURING JEWELLERS LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980
    ABBEY CREST (WHOLESALE JEWELLERS) LIMITED26. Jan. 197926. Jan. 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABBEYCREST PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für ABBEYCREST PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Feb. 2013

    16 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 04. Feb. 2013

    16 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Aug. 2012

    15 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    29 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Elma House Beaconsfield Close Hatfield Hertfordshire AL10 8YG United Kingdom am 14. Feb. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    5 SeitenMG01

    Ernennung von Mark Birchall als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Simon Lazenby als Sekretär am 24. Dez. 2011

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Mark Birchall als Sekretär am 24. Dez. 2011

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Simon Lazenby als Geschäftsführer am 24. Dez. 2011

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Mark Birchall als Direktor am 24. Dez. 2011

    3 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 4100 Park Approach Thorpe Park Leeds West Yorkshire LS15 8GB am 25. Nov. 2011

    1 SeitenAD01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2011

    75 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    21 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Juni 2011

    Kapitalaufstellung am 17. Juni 2011

    • Kapital: GBP 3,370,735
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Simon Mark Ashton am 23. Mai 2011

    3 SeitenCH01

    legacy

    10 SeitenMG01

    Beendigung der Bestellung von Graham Partridge als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Graham Partridge als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Graham Partridge als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Hamley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Simon Lazenby als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von ABBEYCREST PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BIRCHALL, Mark
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Sekretär
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    165887370001
    ASHTON, Simon Mark
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    EnglandBritish49915710004
    BIRCHALL, Mark Jason
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    EnglandBritish70139540002
    CARPIN, Sarah Anne
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United KingdomBritish151677450001
    CHEESEBROUGH, Albert
    Arkendale House
    14 Rossett Gardens
    HG2 9PP Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Arkendale House
    14 Rossett Gardens
    HG2 9PP Harrogate
    North Yorkshire
    British25015550001
    DAVENPORT, Kathryn Anne
    Thorpe Park
    LS15 8GB Colton Leeds
    4100 Park Approach
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Thorpe Park
    LS15 8GB Colton Leeds
    4100 Park Approach
    West Yorkshire
    EnglandBritish104948570002
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Sekretär
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    British138964960001
    LAZENBY, Simon
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    154936310001
    PARTRIDGE, Graham Derek
    Rose Cottage
    Orchard Gardens Weaverham
    CW8 3GZ Northwich
    Cheshire
    Sekretär
    Rose Cottage
    Orchard Gardens Weaverham
    CW8 3GZ Northwich
    Cheshire
    British104567930001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Sekretär
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    British81186640001
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Sekretär
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    British190689780001
    BENSON, Kerry Michael
    81 High Ash Avenue
    LS17 8RX Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    81 High Ash Avenue
    LS17 8RX Leeds
    West Yorkshire
    British37167930005
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    British138964960001
    DEAR, Christopher Joseph
    946 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    946 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    British47542010001
    FEATHERSTONE, John Robson
    The Old Vicarage
    Bishop Monkton
    HG3 3QQ Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Bishop Monkton
    HG3 3QQ Harrogate
    North Yorkshire
    British2550160003
    HAMLEY, Nicholas Peter
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    EnglandBritish126433050002
    LAZENBY, Simon
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish138472720001
    LEVER, Michael Neville
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish12573190001
    MARCALL, Raymond George
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish3977340001
    PARTRIDGE, Graham Derek
    Rose Cottage
    Orchard Gardens Weaverham
    CW8 3GZ Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rose Cottage
    Orchard Gardens Weaverham
    CW8 3GZ Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish104567930001
    PETERSON, Carl Ian
    The Pound
    WV15 5JZ Worfield
    Shropshire
    Geschäftsführer
    The Pound
    WV15 5JZ Worfield
    Shropshire
    British46002060001
    STEVENSON, Paul
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish113293590001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    British81186640001
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish190689780001

    Hat ABBEYCREST PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 02. Feb. 2012
    Geliefert am 07. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chrysus Holdco Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Mai 2011
    Geliefert am 06. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Moorgarth Property Investments Limited (Moorgarth)
    Transaktionen
    • 06. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A share mortgage
    Erstellt am 02. Juli 2009
    Geliefert am 10. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present and future shares and new rights; the mortgage secures the due and punctual payment of the secured liabilities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Pledge and security agreement
    Erstellt am 22. Juni 2009
    Geliefert am 06. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledged securities together with all cash dividends, stock dividends, interests, profits, redemptions, warrants subscription rights pledgor's records and the proceeds of all pledged property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 06. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 13. März 2009
    Geliefert am 21. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Michael Neville Lever
    Transaktionen
    • 21. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 18. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the company's interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn from the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Moorgath Investments Limited
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 23. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a peter rosenberg house 11-15 wilmington grove leeds and all other interests in any f/h or l/h property all fixtures and fittings and fixed plant and machinery its goodwill and its uncalled capital its book debts by way of floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 23. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Mai 2004
    Geliefert am 04. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Peter rosenberg house 11/15 wilmington grove leeds t/n WYK585103 and ywe 66038,. with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Mai 2004
    Geliefert am 11. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 01. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Juni 2001
    Geliefert am 19. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Sept. 1995
    Geliefert am 11. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a land at site 4 sites 6 and 7 and site 11 barrack street light industrial estate sheepscar leeds west yorkshire together with any buildings erected thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Sept. 1995
    Geliefert am 03. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 17. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (See doc M678C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Juli 1990
    Geliefert am 24. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 30. Dez. 1986
    Geliefert am 12. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 ibm pc serial number BG5500038476 1 ibm proprieter xl serial number 580020825 (see form 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Okt. 1982
    Geliefert am 29. Okt. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H plot of land at sackville street and wilmington grove leeds 7, west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 1982Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Okt. 1979
    Geliefert am 26. Okt. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1979Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ABBEYCREST PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Feb. 2012Beginn der Verwaltung
    04. Feb. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Malcolm Titley
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Praktiker
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Andrew Poxon
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Praktiker
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0