INNOVEX HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | INNOVEX HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01413055 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INNOVEX HOLDINGS LIMITED?
- (7487) /
Wo befindet sich INNOVEX HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Aquarium 1-7 King Street RG1 2AN Reading Berkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INNOVEX HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
INNOVEX LIMITED | 03. Mai 1994 | 03. Mai 1994 |
INNOVEX HOLDINGS PLC | 22. Apr. 1985 | 22. Apr. 1985 |
EXECUQUEST HOLDINGS LIMITED | 04. März 1983 | 04. März 1983 |
EXECUQUEST LIMITED | 05. Feb. 1979 | 05. Feb. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INNOVEX HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INNOVEX HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Jan. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 244 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c |
Wer sind die Geschäftsführer von INNOVEX HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODACRE, John | Sekretär | 400 Deming Road Chapel Hill North Carolina 27514 Usa | British | Solicitor | 1874930004 | |||||
MACDONALD, Alasdair | Geschäftsführer | Flat 4 53 Millbank SW1P 4RL London | United Kingdom | British | Company Director | 70837160002 | ||||
WILSON, Michael Norman | Geschäftsführer | 8 High Mead HA1 2TX Harrow Middlesex | England | British | Company Director | 73384020002 | ||||
FREEMAN, Stella Dorothy | Sekretär | Chimneys Winter Hill SL6 9TN Cookham Dean Berkshire | British | 47544160001 | ||||||
KNOTT, Paul | Sekretär | The Gables Elvendon Road Goring-On-Thames RG8 0DT Reading Oxfordshire | British | Director | 3200150004 | |||||
PRICE, Phillip John | Sekretär | Home Meadow Terrace Road South RG42 4DS Binfield Berkshire | British | Finance Directr | 52534490001 | |||||
BETTS, John Alexander | Geschäftsführer | 70 Chesson Road W14 9QU London | British | Investment Banker | 38523590001 | |||||
BURKE, John Vernon | Geschäftsführer | Silver Copse 48 Linksway HA6 2XB Northwood Middlesex | British | Company Director | 36855100002 | |||||
FORRESTER, Peter Alan, Doctor | Geschäftsführer | 93 Rosa Maris 29 Ave Des Papalins FOREIGN Monaco Mc9800 Monaco | British | Director | 73870030001 | |||||
FREEMAN, Stella Dorothy | Geschäftsführer | Chimneys Winter Hill SL6 9TN Cookham Dean Berkshire | British | Director | 47544160001 | |||||
GLYNN-WILLIAMS, William Ifan | Geschäftsführer | Fleet View The Pound SL6 9QD Cookham Berkshire | British | Company Director | 45244950001 | |||||
GRIFFIN, Richard Philip | Geschäftsführer | 58 Goddington Road SL8 5TX Bourne End Buckinghamshire | British | Director | 4315230001 | |||||
HAIGH, Barrie Stevens | Geschäftsführer | Turville Court Turville Heath RG9 6JT Henley On Thames Oxfordshire | England | British | Director | 61547330001 | ||||
KNOTT, Paul | Geschäftsführer | The Gables Elvendon Road Goring-On-Thames RG8 0DT Reading Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 3200150004 | ||||
MACKANESS, Alexandra Antonia | Geschäftsführer | 156 Campden Hill Road W8 7AS London | British | Investment Banker | 39096000001 | |||||
MASTERSON, Christopher Mary | Geschäftsführer | 19 Tower Road TW14 4PD Twickenham Middlesex | British | Investment Director | 35526310001 | |||||
PRICE, Philip John | Geschäftsführer | 120 Shadow Ridge Place Chapel Hill North Carolina 27516 Usa | British | Finance Directr | 52534490002 | |||||
WHITE, David Findlay | Geschäftsführer | Little Barlows Frieth RG9 6PR Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 62316810001 |
Hat INNOVEX HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee & debenture | Erstellt am 03. Apr. 1996 Geliefert am 11. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or in respect of the loan stock and all other monies due to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 31. März 1993 Geliefert am 13. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 31. März 1993 Geliefert am 13. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 17. Juni 1988 Geliefert am 24. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H spring grove house reading road, henley on thames oxon. Title no on 18474 together with buildings fixtures & and assignment of goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 08. Mai 1987 Geliefert am 12. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold 70A bell street henley-on-thames oxon and assings the goodwill of the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Okt. 1986 Geliefert am 16. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 70, bell street henley-on-thames, oxfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 29. Juli 1983 Geliefert am 08. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat INNOVEX HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0