SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED

SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01414175
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Sca Packaging Finance Shared
    Service Centre Faverdale
    DL3 0PE Faverdale Industrial Estate
    Darlington Co Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KIRBY CARTONS LIMITED22. März 198922. März 1989
    COLIN KIRBY (HOLDINGS) LIMITED31. Dez. 197931. Dez. 1979
    YOOGALI LIMITED09. Feb. 197909. Feb. 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 28. Mai 2009

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    6 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    6 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EYLES, Melanie
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    Sekretär
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    British130563500001
    HEYS, Thomas David
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    Geschäftsführer
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    EnglandBritish133589280001
    HOVINGTON, Stphen Paul
    Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    9
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    9
    North Yorkshire
    British138340970001
    HOVINGTON, Stephen Paul
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    Sekretär
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    British60781190001
    STAPLES, Anthony John
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    Sekretär
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    British45838190001
    TOWERS, Joanne Sara
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British12355220002
    BROWN, John Keith
    Harvel Cottage 30 Hallatrow Road
    Paulton
    BS39 7LJ Bristol
    Geschäftsführer
    Harvel Cottage 30 Hallatrow Road
    Paulton
    BS39 7LJ Bristol
    EnglandBritish60781220001
    GIBBONS, Anthony
    8 Wells Green
    Barton
    DL10 6NH Richmond
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Wells Green
    Barton
    DL10 6NH Richmond
    North Yorkshire
    British60781120002
    HOVINGTON, Stephen Paul
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    EnglandBritish60781190001
    KIRBY, Colin Walter
    Apartment 28 Little Aston Hall
    Little Aston
    B74 3BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Apartment 28 Little Aston Hall
    Little Aston
    B74 3BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British5390460002
    KIRBY, Hilary June
    Apartment 28 Little Aston Hall
    Little Aston
    B74 3BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Apartment 28 Little Aston Hall
    Little Aston
    B74 3BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British6412080002
    KIRBY, Kerry Ann
    6 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    6 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish45081270001
    KIRBY, Nicholas Andrew
    200 Walsall Road
    B74 4QB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    200 Walsall Road
    B74 4QB Sutton Coldfield
    West Midlands
    British61556150001
    KIRBY, Simon Colin
    35 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    35 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British62605760002
    MANSELL, Philip Peter
    7 Stag Drive
    Woodhaven
    WS12 4UJ Huntington
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    7 Stag Drive
    Woodhaven
    WS12 4UJ Huntington
    Staffordshire
    United KingdomBritish264683610001
    MILLER, Brian Joseph
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    Geschäftsführer
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    British28463460001
    RICE, Thomas Anthony
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Geschäftsführer
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Irish108501020001
    STEAD, David Richard
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    EnglandBritish72400470001
    TOWERS, Joanne Sara
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish12355220002
    TOWERS, Richard John
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish58877370002
    WILLIAMS, John David
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    British74014480001

    Hat SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 09. Apr. 1997
    Geliefert am 22. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Apr. 1997
    Geliefert am 22. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land & buildings on the south side of lynn lane shenstone staffordshire t/n SF267170 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Apr. 1997
    Geliefert am 22. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land lying to the south of lynn lane shenstone staffordshire t/n SF161660 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 06. Okt. 1995
    Geliefert am 07. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a geest premises lynn lane shenstone staffs t/no.SF267170 and all buildings fixtures and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Feb. 1995
    Geliefert am 25. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £135,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Kirby Directors Pension Scheme
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 1991
    Geliefert am 05. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property of the company at lynn lane shenotone lichfield t/no:- sf 161660. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 05. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 28. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Apr. 1989
    Geliefert am 21. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property at lynn lane shenstone lichfield t/no sf 161660 model 4050 automatic litho sheet lamintor with straight through machines configuration and automatic base material feed.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 28. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal second mortgage
    Erstellt am 24. Dez. 1986
    Geliefert am 08. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H industrial premises & land at lynn lane shenstone, nr lichfield, staffs.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 24. Dez. 1986
    Geliefert am 08. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 28. Okt. 1983
    Geliefert am 04. Nov. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 28. Okt. 1982
    Geliefert am 10. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold factory premises and land at the south of lynn lane, shenstone, lichfield, staffordshire title number sf 161660.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1982Registrierung einer Belastung
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Apr. 1981
    Geliefert am 23. Apr. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or kirby containers limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital. Buildings fixtures, fixed plant and machinery (see doc m 15).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1981Registrierung einer Belastung
    Single debenture
    Erstellt am 21. Mai 1980
    Geliefert am 24. Mai 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future goodwill including uncalled capital. And all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 1980Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 09. Apr. 1980
    Geliefert am 14. Apr. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land situate near lynn lane, shenstone, staffordshire with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1980Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juni 1979
    Geliefert am 15. Juni 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital stock in trade work in progress, prepayments & investments together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 15. Juni 1979Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Apr. 2010Aufgelöst am
    28. Mai 2009Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0