R & M HAMPSON LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | R & M HAMPSON LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01414192 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von R & M HAMPSON LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich R & M HAMPSON LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Britannic House Stirling Way WD6 2BT Borehamwood Hertfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von R & M HAMPSON LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WHITE ACRES HOLIDAY PARK LIMITED | 31. Dez. 1980 | 31. Dez. 1980 |
| HASSOFIRM LIMITED | 09. Feb. 1979 | 09. Feb. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von R & M HAMPSON LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für R & M HAMPSON LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 19 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 014141920020 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Okt. 2016 bis 31. Okt. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 11 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Sam Ahmed als Sekretär am 29. Juli 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2017 bis 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Robert Elton als Geschäftsführer am 29. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Brian Jones als Direktor am 29. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Federico Vecchioli als Direktor am 29. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 014141920020, erstellt am 29. Juli 2016 | 66 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 17 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 18 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von R & M HAMPSON LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMED, Sam | Sekretär | Stirling Way WD6 2BT Borehamwood Britannic House Hertfordshire | 211752720001 | |||||||
| JONES, Andrew Brian | Geschäftsführer | Stirling Way WD6 2BT Borehamwood Britannic House Hertfordshire | England | English | 178066050001 | |||||
| VECCHIOLI, Federico | Geschäftsführer | Stirling Way WD6 2BT Borehamwood Britannic House Hertfordshire | England | French | 158800170002 | |||||
| HAMPSON, Marilyn Jean | Sekretär | 8 Bowbridge Lock GL5 2JZ Stroud Gloucestershire | British | 18744370001 | ||||||
| HICKS, David Milton | Sekretär | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 23 | American | 106159240001 | ||||||
| MACKLEY, Nicholas Andrew | Sekretär | 32 Byng Road EN5 4NR Barnet Hertfordshire | British | 41554610002 | ||||||
| CARTER, David Jason | Geschäftsführer | Whitepightle Wood Sauncey Wood Lane AL5 5DX Harpenden Hertfordshire | England | British | 86113590002 | |||||
| DAWSON, Andrew Laurence | Geschäftsführer | 62 Chiswick Staithe Chiswick W4 3TP London | United Kingdom | British | 81580750002 | |||||
| ELTON, James Robert | Geschäftsführer | 64 Great Suffolk Street SE1 0BL London 1st Floor United Kingdom | England | British | 174187110001 | |||||
| HAMPSON, Marilyn Jean | Geschäftsführer | 8 Bowbridge Lock GL5 2JZ Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 18744370001 | |||||
| HAMPSON, Robert | Geschäftsführer | 6 The Paragon Clifton BS8 4LA Bristol Avon | England | British | 18744380002 | |||||
| HICKS, David Milton | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 23 | United Kingdom | American | 106159240001 | |||||
| MCLACHLAN, Dougald Mcgregor | Geschäftsführer | 7 The Firs Ealing W5 2HG London | England | British | 68090830002 | |||||
| ROWLEY, Thomas John Lewis | Geschäftsführer | Queensdale Road W11 4SB London 27 | Australian | 133352330001 | ||||||
| WEBSTER, George Edward | Geschäftsführer | 25 Spencer Walk NW3 1QZ London | England | British | 87845070001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei R & M HAMPSON LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Maker Stores Limited | 30. Juni 2016 | Stirling Way WD6 2BT Borehamwood Brittanic House Hertfordshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat R & M HAMPSON LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 29. Juli 2016 Geliefert am 02. Aug. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Apr. 2010 Geliefert am 17. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from stores or any other obligor to any finance party and the parent lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Aug. 2007 Geliefert am 07. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land lying to the north west of ipswich road colchester t/n EX275383 l/h land lying to the north west of ipswich road colchester t/N280268 f/h land at battlebridge lane merstham redhill t/n SY678749 for further details of the properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 2007 Geliefert am 07. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any agreements contracts deeds leases any insurance policies the hedge documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Aug. 2006 Geliefert am 24. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Bournemouth self-storage wharfdale service road bournemouth t/no DT93500. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Aug. 2006 Geliefert am 24. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H bournenouth self storage heatherbank road bournemouth t/no ST174309. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Aug. 2006 Geliefert am 24. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rent deposit | Erstellt am 16. Okt. 1998 Geliefert am 16. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease dated 29TH january 1987 | |
Kurze Angaben The sum of £24,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Okt. 1998 Geliefert am 19. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The monkwell building 10-12 wharfdale road bournemouth dorset t/n DT93500. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rent deposit | Erstellt am 07. Okt. 1998 Geliefert am 16. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease dated 2ND july 1982 | |
Kurze Angaben The sum of £24,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rent deposit | Erstellt am 07. Okt. 1998 Geliefert am 16. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease dated 10TH august 1989 | |
Kurze Angaben The sun of £16,250. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Okt. 1997 Geliefert am 18. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company,douglas hampson,john ryan and jennifer ryan to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Lease of c bond warehouse clift house road southville bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Juni 1997 Geliefert am 25. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of white street bristol t/n av 647. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Juni 1994 Geliefert am 17. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The furniture depository heatherbank road westbourne bournemouth dorset t/no dt 174309. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Jan. 1994 Geliefert am 27. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Please see doc for further details,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Dez. 1987 Geliefert am 29. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or douglas hampson to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben 'C" bond, cliff house road southville, bristol, avon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1987 Geliefert am 29. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot of land situate in penruan lane st. Mawes cornwall. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Feb. 1981 Geliefert am 26. Feb. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H whiteacres caravan park whitecross newquay cornwall. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Jan. 1981 Geliefert am 27. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, and uncalled capital. With all buildings, fixtures (and trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Juni 1979 Geliefert am 26. Juni 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £5,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H premises, whiteacres holiday park, colon, cornwall with all buildings and fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat R & M HAMPSON LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0