LPC (PHARMACEUTICALS) LTD
Überblick
Unternehmensname | LPC (PHARMACEUTICALS) LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01414640 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LPC (PHARMACEUTICALS) LTD?
- Apotheken in spezialisierten Geschäften (47730) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LPC (PHARMACEUTICALS) LTD?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Snk Invesments Llp Unit 3 Nursery Court Kibworth Business Park LE8 0EX Kibworth Leics England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LPC (PHARMACEUTICALS) LTD?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LPC (PHARMACEUTICAL) LTD. | 09. Juni 1988 | 09. Juni 1988 |
S.S.D. TEJANI LIMITED | 13. Feb. 1979 | 13. Feb. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LPC (PHARMACEUTICALS) LTD?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LPC (PHARMACEUTICALS) LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Cessation of Lpc Pharma (Retail) Ltd as a person with significant control on 31. Okt. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2020 bis 30. Sept. 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Karim Sharif Dharamshi Tejani am 10. Feb. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2019 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Dez. 2019 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Ian Waring als Sekretär am 31. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||
Notification of Ll-Pharma Ltd as a person with significant control on 31. Okt. 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Selsdon House 1st Floor 212-220 Addington Road South Croydon Surrey CR2 8LD zum Snk Invesments Llp Unit 3 Nursery Court Kibworth Business Park Kibworth Leics LE8 0EX am 13. Nov. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Ernennung von Mr Shirazali Sharif Dharamshi als Direktor am 31. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Salim Sharif Dharamshi Tejani als Direktor am 31. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Karim Sharif Dharamshi am 31. Okt. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Mr Nazirali Sharif Dharamshi Tejani als Direktor am 31. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Karim Sharif Dharamshi als Direktor am 31. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Amirali Sharif Tejani als Direktor am 31. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Ian Power als Geschäftsführer am 31. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Salim Kassamali Esmail Jetha als Geschäftsführer am 31. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Nicholas James Clark als Geschäftsführer am 31. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Ian Power als Sekretär am 31. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mr Nicholas James Clark als Direktor am 18. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Jonathan Ian Power als Sekretär am 18. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Mr Jonathan Ian Power als Direktor am 18. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LPC (PHARMACEUTICALS) LTD?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARING, Ian | Sekretär | Unit 3 Nursery Court Kibworth Business Park LE8 0EX Kibworth Snk Invesments Llp Leics England | 264364090001 | |||||||
DHARAMSHI, Shirazali Sharif | Geschäftsführer | Unit 3 Nursery Court Kibworth Business Park LE8 0EX Kibworth Snk Invesments Llp Leics England | United Kingdom | British | Director | 13188390003 | ||||
TEJANI, Amirali Sharif | Geschäftsführer | Unit 3 Nursery Court Kibworth Business Park LE8 0EX Kibworth Snk Invesments Llp Leics England | United Kingdom | British | Director | 13188380003 | ||||
TEJANI, Karim Sharif | Geschäftsführer | Unit 3 Nursery Court Kibworth Business Park LE8 0EX Kibworth Snk Invesments Llp Leics England | United Kingdom | British | Director | 13188400003 | ||||
TEJANI, Nazirali Sharif Dharamshi | Geschäftsführer | Unit 3 Nursery Court Kibworth Business Park LE8 0EX Kibworth Snk Invesments Llp Leics England | United Kingdom | British | Director | 13386950005 | ||||
TEJANI, Salim Sharif Dharamshi | Geschäftsführer | Unit 3 Nursery Court Kibworth Business Park LE8 0EX Kibworth Snk Invesments Llp Leics England | United Kingdom | British | Director | 13188410005 | ||||
HARIA, Rajesh | Sekretär | 1st Floor 212-220 Addington Road CR2 8LD South Croydon Selsdon House Surrey England | 189496770001 | |||||||
MEHTA, Ashoni Kumar | Sekretär | 1st Floor 212-220 Addington Road CR2 8LD South Croydon Selsdon House Surrey | 202113360001 | |||||||
POWER, Jonathan Ian | Sekretär | 1st Floor 212-220 Addington Road CR2 8LD South Croydon Selsdon House Surrey | 262952840001 | |||||||
TEJANI, Salim Sharif Dharamshi | Sekretär | Manor Cottage Ampthill Road Beadlow SG17 5PJ Shefford Bedfordshire | British | 13188410001 | ||||||
WARING, Ian David | Sekretär | 2, Covent Garden Close LU4 8QB Luton Lpc (Pharmaceuticals) Ltd Beds United Kingdom | British | Accountant | 36785940001 | |||||
BUTTER, Satnam Singh | Geschäftsführer | 2, Covent Garden Close LU4 8QB Luton Lpc (Pharmaceuticals) Ltd Beds United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 39026510002 | ||||
CLARK, Nicholas James | Geschäftsführer | 1st Floor 212-220 Addington Road CR2 8LD South Croydon Selsdon House Surrey | Wales | British | Director (Chief Operating Officer) | 96329110001 | ||||
DHARAMSHI, Shirazali Sharif | Geschäftsführer | 2, Covent Garden Close LU4 8QB Luton Lpc (Pharmaceuticals) Ltd Beds United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 13188390003 | ||||
HARIA, Rajesh | Geschäftsführer | 1st Floor 212-220 Addington Road CR2 8LD South Croydon Selsdon House Surrey England | United Kingdom | British | Director | 137274520001 | ||||
JETHA, Salim Kassamali Esmail | Geschäftsführer | 1st Floor 212-220 Addington Road CR2 8LD South Croydon Selsdon House Surrey England | England | British | Pharmacist | 8007970002 | ||||
PATEL, Kirit Chimanbhai | Geschäftsführer | 1st Floor 212-220 Addington Road CR2 8LD South Croydon Selsdon House Surrey England | England | British | Director | 11545120001 | ||||
POWER, Jonathan Ian | Geschäftsführer | 1st Floor 212-220 Addington Road CR2 8LD South Croydon Selsdon House Surrey | United Kingdom | British | Cfo | 244568320001 | ||||
TEJANI, Amirali Sharif | Geschäftsführer | 2, Covent Garden Close LU4 8QB Luton Lpc (Pharmaceuticals) Ltd Beds United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 13188380003 | ||||
TEJANI, Karim Sharif | Geschäftsführer | 2, Covent Garden Close LU4 8QB Luton Lpc (Pharmaceuticals) Ltd Beds United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 13188400003 | ||||
TEJANI, Nazirali Sharif Dharamshi | Geschäftsführer | 2, Covent Garden Close LU4 8QB Luton Lpc (Pharmaceuticals) Ltd Beds United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 13386950005 | ||||
TEJANI, Nazirali Sharif Dharamshi | Geschäftsführer | Greyside 68 Manor Rd, Oadby LE2 2SA Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | Company Director | 13386950005 | ||||
TEJANI, Salim Sharif Dharamshi | Geschäftsführer | 2, Covent Garden Close LU4 8QB Luton Lpc (Pharmaceuticals) Ltd Beds United Kingdom | England | British | Company Director | 13188410003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LPC (PHARMACEUTICALS) LTD?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ll-Pharma Ltd | 31. Okt. 2019 | Unit 3 Nursery Court Kibworth Business Park LE8 0EX Leicester Snk Investments Llp Leics England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Lpc Pharma (Retail) Ltd | 06. Apr. 2016 | Addington Road CR2 8LD South Croydon Selsdon House, 212-220 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für LPC (PHARMACEUTICALS) LTD?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
24. Dez. 2016 | 21. Dez. 2018 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat LPC (PHARMACEUTICALS) LTD Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 05. Dez. 2014 Geliefert am 08. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The property known as 5 station parade belmont circle harrow registered at h m land registry with title number: NGL837952. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 22. Okt. 2014 Geliefert am 22. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The property known as 383 dunstable road luton registered at h m land registry with title number: BD271485. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 22. Okt. 2014 Geliefert am 22. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The property known as 361 dunstable road luton registered at h m land registry with title number: BD263308. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 21. Okt. 2014 Geliefert am 22. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The property known as 5-7 the green hockwell ring luton registered at h m land registry with title number: BD247373. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 23. Sept. 2014 Geliefert am 25. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold property known as 88 london road bedford. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 22. Sept. 2014 Geliefert am 23. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold property known as 56-56A birdsfoot lane luton bedfordshire and garages 1 & 2. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 22. Sept. 2014 Geliefert am 23. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold property known as 57-57A katherine drive dunstable registered at h m land registry with title number: BD237452. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 08. Sept. 2014 Geliefert am 10. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold property known as 213, 215 & 217 dunstable road luton. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 08. Sept. 2014 Geliefert am 10. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold property known as unit 9 bushmead shopping centre hancock drive bushmead luton registered at h m land registry with title number: BD164855. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 08. Sept. 2014 Geliefert am 10. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold property known as 138 dallow road luton registered at h m land registry with title number: BD268172. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 08. Sept. 2014 Geliefert am 10. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold property known as unit 2 covent garden close luton. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 08. Sept. 2014 Geliefert am 10. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All letters patent, trademarks, service marks, designs, utility models, copyrights, design rights, applications for registration of any of the them and the right to apply for them in any part of the world. In addition, moral rights, inventions, confidential information, know-how and rights of a similar nature arising or subsisting anywhere in the world in relation to all or any of the above (whether registered or unregistered) now or at any time afterwards belonging to the company (together with any of the same mentioned in the second schedule of the debenture, collectively called the "intellectual property"). Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 28. Juni 2013 Geliefert am 10. Juli 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 30 chaul end lane luton t/no BD232255. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 28. Juni 2013 Geliefert am 10. Juli 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 30 chaul end lane luton t/no BD232255. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment | Erstellt am 22. Juli 2011 Geliefert am 29. Juli 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Entire right, title and interest in and to the charge, the loan note documents, the spa. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of life policy | Erstellt am 03. Feb. 2006 Geliefert am 04. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben With full title guarantee all the sums secured against the policy: insurer: allied dunbar assurance PLC, number: 16440-210-dds, life assured: salim sharif dharamshi tejani,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of life policy | Erstellt am 03. Feb. 2006 Geliefert am 04. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben With full title guarantee all the sums secured against the policy: insurer: allied dunbar assurance PLC, number: 20321-210-dps, life assured: satnum singh butter,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 13. Okt. 2005 Geliefert am 28. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 88 london road bedford. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Juni 2003 Geliefert am 08. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property land lying to the west of chaul end lane the f/h is registered under t/n 33257, as demised and described in a lease dated 30 april 2003. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Juli 2002 Geliefert am 24. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 88 london road bedford. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Juni 2002 Geliefert am 17. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 17. Dez. 1991 Geliefert am 03. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 217 dunstable road luton bedfordshire t/n BD143963 together with all buildings and fixtures thereon assigns goodwiil of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. Feb. 1990 Geliefert am 13. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 57 & 57A katherine drive, dunstable bedfordshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 08. Aug. 1986 Geliefert am 21. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures) (see schedule attached to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 29. Juli 1982 Geliefert am 10. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 2 leagrave rd luton bedfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0