HEY (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HEY (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01414745 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HEY (UK) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HEY (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 33 Cavendish Square W1G 0PW London London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HEY (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HEY SOFT DRINKS (U.K.) COMPANY LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HEY (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HEY (UK) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für HEY (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sunita Kaushal als Sekretär am 29. Juli 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2013 | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 33 Cavendish Square London London W1B 0PW England* am 27. Aug. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Caldecott als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* am 01. Juli 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Colin Elliot als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Gareth Caldecott am 18. Dez. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gareth Caldecott am 05. Nov. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gareth Caldecott am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* am 05. Sept. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Maxwell Coppel am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sunita Kaushal am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 1 West Garden Place Kendal Street London W2 2AQ England* am 05. Dez. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HEY (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPEL, Andrew Maxwell | Geschäftsführer | Portland Place W1B 1PU London 17 London United Kingdom | England | British | 163106000001 | |||||
| ELLIOT, Colin David | Geschäftsführer | Portland Place W1B 1PU London 17 London England | United Kingdom | British | 178756480001 | |||||
| COPELAND, Francis Charles Stuart | Sekretär | 29 West House Court Broken Cross SK10 3NZ Macclesfield Cheshire | British | 15613380001 | ||||||
| EDWARDS, David Charles | Sekretär | Greenbanks Close Milford On Sea SO41 0SQ Lymington 7 Hampshire | British | 123440090026 | ||||||
| KAUSHAL, Sunita | Sekretär | Portland Place W1B 1PU London 17 London England | 158956040001 | |||||||
| RAMSBOTTOM, Peter | Sekretär | Flat 5 Netherleigh Court S40 3PR Chesterfield Derbyshire | British | 881150001 | ||||||
| FILEX SERVICES LIMITED | Sekretär | 179 Great Portland Street W1W 5LS London | 3620420001 | |||||||
| BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Geschäftsführer | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | 34251500001 | |||||
| BIBRING, Michael Albert | Geschäftsführer | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | 9320160002 | |||||
| BREARLEY, John Richard | Geschäftsführer | 206 Bramhall Lane Davenport SK3 8TX Stockport Cheshire | British | 1575980001 | ||||||
| CALDECOTT, David Gareth | Geschäftsführer | Portland Place W1B 1PU London 17 London England | England | British | 73603940004 | |||||
| CAVE, Ian Bruce | Geschäftsführer | 392 Woodstock Road OX2 8AF Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 102741680001 | |||||
| COPELAND, Francis Charles Stuart | Geschäftsführer | 29 West House Court Broken Cross SK10 3NZ Macclesfield Cheshire | British | 15613380001 | ||||||
| EDWARDS, David Charles | Geschäftsführer | Greenbanks Close Milford On Sea SO41 0SQ Lymington 7 Hampshire | United Kingdom | British | 123440090026 | |||||
| ENGLEFIELD, Edward Ashton | Geschäftsführer | 44 Carrwood Road Pownall Park SK9 5DN Wilmslow Cheshire | British | 35176020001 | ||||||
| FARQUHARSON, John Alan | Geschäftsführer | Oak Lodge Windmill Lane Appleton WA4 5JN Warrington Cheshire | England | British | 15541980001 | |||||
| LISTER, Steven Bernard Lewis | Geschäftsführer | Keepers Cottage Ashwith By Pilsley S45 8AN Chesterfield | British | 10137610001 | ||||||
| LONGDEN, John David | Geschäftsf ührer | Vicarage House Nidd HG3 3BN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 40890250001 | |||||
| MARTLAND, David James | Geschäftsführer | 73 Hall Lane Aspull WN2 2SF Wigan Greater Manchester | British | 35477380001 | ||||||
| MCEVOY, John James | Geschäftsführer | 17 Grangeway Handforth SK9 3HY Wilmslow Cheshire | United Kingdom | British | 48091070001 | |||||
| PARKINSON, Joseph Edward | Geschäftsführer | Spillway The Gardens Turton BL7 0RZ Bolton | United Kingdom | British | 4553470004 | |||||
| RAMSBOTTOM, Peter | Geschäftsführer | Flat 5 Netherleigh Court S40 3PR Chesterfield Derbyshire | British | 881150001 | ||||||
| SINGH, Jagtar | Geschäftsführer | West Garden Place W2 2AQ London 1 England | United Kingdom | British | 121710890001 | |||||
| SINGLETON, Paul James | Geschäftsführer | 15 Kingsway Avenue Broughton PR3 5JN Preston Lancashire | British | 79357110001 | ||||||
| SPIEGELBERG, Anthony William Assheton | Geschäftsführer | Oulton Park House CW6 9BL Tarporley Cheshire | England | British | 24626450001 | |||||
| WHITE, Christopher Geoffrey | Geschäftsführer | Woodbine Brown Heath Road Christleton CH3 7PN Chester Cheshire | British | 58547200001 |
Hat HEY (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Third supplemental trust deed | Erstellt am 16. Sept. 1998 Geliefert am 01. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee the principal of and interest on the stock, being £99,650,450 11 1/2 per cent. Debenture stock 2014 of the greenalls group PLC and any further debenture stock of the greenalls group PLC created or issued pursuant to clause 3 of the principal trust deed, and all other monies intended to be secured by the principal trust deed dated 5 june 1991, any deed expressed to be supplemental thereto and any other deed or instrument conferring rights on the chargee executed or entered into pursuant to the principal trust deed or any deed supplemental thereto | |
Kurze Angaben The undertaking and all the property and assets present and future wherever situated (including any uncalled capital) of the company by way of first floating charge.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental trust deed | Erstellt am 16. Sept. 1998 Geliefert am 24. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The guarantee by the company to the trustee of the payment by the greenalls group PLC of all sums on account of the principal of or interest on the £30,000,000 10 1/2 per cent.(formerly 10 1/4 per cent) debenture stock 2017 (repayable on 23RD june 2017 or such earlier date as the security constituted by the trust deed the supplemental trust deed and the second supplemental trust deed becomes enforceable and the trustee determines or becomes bound to enforce the same) and of any moneys intended to be secured by the second supplemental trust deed | |
Kurze Angaben First floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Aug. 1991 Geliefert am 08. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land k/as depot mangham road barbot hall industrial estate rotherham south yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Feb. 1990 Geliefert am 28. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold lands being depot,mangham road,barbot hall industrial,rotherham,south yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Nov. 1989 Geliefert am 07. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Estate right title or interest (if any) or in a plot of land situate on the east side of skinner lane pontefract west yorkshire including beneficial interest in the property or in the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Nov. 1989 Geliefert am 07. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings situate off bondgate,knottingley road and atkinson lane. Pontefract t/n wyk 339842 and plot of land situate off bondgate,knottingley road including interest in property or in the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juni 1989 Geliefert am 12. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land in barrys lane scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Mai 1989 Geliefert am 19. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Two freehold plots of land one situate between westfield road and holm flatt street in parkgate rotherham with the depot and offices erected thereon or on some part thereof and theother situate some short distance to the north east and also being in westgage with the buildings erected thereon or on some part thereof and used as a garage and store. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Apr. 1989 Geliefert am 17. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and building at spawd bone lane,knottingley,west yorkshire.t/no.wyk 21390 and part of t/no.wyk 427817. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Apr. 1989 Geliefert am 17. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings at carnaby road bridlington T.no. Hs 1667. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Apr. 1989 Geliefert am 17. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings off station road,ushaw moor,county durham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Apr. 1989 Geliefert am 17. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings situate at skinner lane pontefract west yorkshire T.no wyk 20616. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 27. Apr. 1989 Geliefert am 11. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Sept. 1988 Geliefert am 08. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings spawd bone lanes knottingley,west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Juni 1988 Geliefert am 10. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a on being land and buildings on the south side of lancaster road carnaby bridlington humberside t/n H.S. 1667 registered at H.M. land registry. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Nov. 1987 Geliefert am 01. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 1987 Geliefert am 20. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h land and buildings on the east side of skinner lane, pontefract, west yorkshire title no wyk 20616. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 1987 Geliefert am 20. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The right title or interest of hey soft drinks (UK) company limited of and in a plot of land situate on the east side ofskenner lane, pontefract, west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0