WQUAY LTD
Überblick
| Unternehmensname | WQUAY LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01417366 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WQUAY LTD?
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen
Wo befindet sich WQUAY LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Sovereign Quay Havannah Street CF10 5SF Cardiff |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WQUAY LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SILVERDELL (UK) LIMITED | 21. Dez. 1993 | 21. Dez. 1993 |
| SILVERDELL CONSTRUCTION LIMITED | 28. Feb. 1979 | 28. Feb. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WQUAY LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WQUAY LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung | 20 Seiten | WU15 | ||||||||||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 17 Seiten | WU07 | ||||||||||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 15 Seiten | WU07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adrian Malcolm Sutton Smoothey als Geschäftsführer am 27. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 12 Seiten | WU07 | ||||||||||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 11 Seiten | WU07 | ||||||||||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 02/09/2016 | 9 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 13. Juli 2016 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||||||||||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. Feb. 2016 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:re progress report 03/09/2014-02/09/2015 | 9 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. Feb. 2015 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 2 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 2 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 2 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Ernennung eines Liquidators | 1 Seiten | 4.31 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Loxley Manor Loxley Road Sheffield South Yorkshire S6 6RW zum 2 Sovereign Quay Havannah Street Cardiff CF10 5SF am 12. Sept. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tmf Corporate Administration Services Limited als Sekretär am 18. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Ernennung eines Receivers oder Managers | 4 Seiten | RM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WQUAY LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON, Ian Roderick | Geschäftsführer | Floor 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th United Kingdom | England | British | 132835810002 | |||||||||
| NUTLEY, Sean Edward Harrison | Geschäftsführer | 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th Floor United Kingdom | England | British | 71961890002 | |||||||||
| RHODES, David Anthony | Geschäftsführer | Old School Walk Church Langton LE16 7FW Leicester 7 United Kingdom | United Kingdom | British | 117336160002 | |||||||||
| ROBERTS, Mark William | Geschäftsführer | 8 Dorset Way Hillingdon UB10 0JR Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 45819430004 | |||||||||
| ROBERTS, Mark William | Sekretär | 8 Dorset Way Hillingdon UB10 0JR Uxbridge Middlesex | British | 45819430001 | ||||||||||
| SPICER, Daniel Joseph | Sekretär | Tuft Bressey Grove South Woodford E18 2PH London | British | 11790870001 | ||||||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 United Kingdom |
| 149604200001 | ||||||||||
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Sekretär | Floor 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
| BARKER, James Sidney | Geschäftsführer | 4 Montpelier Gardens East Ham E6 3JD London | British | 28170330001 | ||||||||||
| DONOVAN, Steven John | Geschäftsführer | 42 Roding Way Rainham RM13 9QD Essex | British | 20731690001 | ||||||||||
| FARMER, Wayne Richard | Geschäftsführer | 24 Bakersfield Mayland CM3 6GT Chelmsford Essex | British | 71961960002 | ||||||||||
| GRIFFITHS, Ashley Ross | Geschäftsführer | 21 Bury Way St Ives PE27 6SL Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | 142248990001 | |||||||||
| GUNN, Christopher Simon | Geschäftsführer | The Cottage Bodsham TN25 5JQ Ashford Kent | England | British | 163710160002 | |||||||||
| MILES, Simon Jeremy | Geschäftsführer | Goldsmith Drive Ettiley Heath CW11 3GR Sandbach 10 Cheshire | British | 131110210001 | ||||||||||
| REAVILL, Thomas Anthony John | Geschäftsführer | 51 Gravel Hill Terrace Boxmoor HP1 1RJ Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 20731700001 | |||||||||
| SIMS, Christopher John | Geschäftsführer | 21 Davis Close Barrs Court BS30 7BU Bristol | England | British | 71938490001 | |||||||||
| SMITH, Marc Edward | Geschäftsführer | 6 Alliance Way Paddock Wood TN12 6TY Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 125348680001 | |||||||||
| SMOOTHEY, Adrian Malcolm Sutton | Geschäftsführer | 5 Peartree Lane Doddinghurst CM15 0RR Brentwood Essex | United Kingdom | British | 74495010001 | |||||||||
| SPICER, Daniel Terence | Geschäftsführer | 14 Theydon Place CM16 4NH Epping Essex | United Kingdom | British | 83459600004 | |||||||||
| SPICER, Daniel Joseph | Geschäftsführer | Tuft Bressey Grove South Woodford E18 2PH London | United Kingdom | British | 11790870001 | |||||||||
| WRIGHT, Andrew Robert | Geschäftsführer | 27 Derby Close CM3 6TB Mayland Essex | United Kingdom | British | 78387280001 |
Hat WQUAY LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 18. Juni 2012 Geliefert am 04. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juni 2012 Geliefert am 04. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juni 2012 Geliefert am 20. Juni 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 2010 Geliefert am 08. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries and the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 15. Mai 2009 Geliefert am 22. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company related to the security trustee by way of legal mortgage its interest in the property and all rights relating to such property for details of properties please see form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rent deposit | Erstellt am 14. Jan. 2008 Geliefert am 16. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £9,500.00 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben All interest in the deposit account and in the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2006 Geliefert am 22. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 19. Juni 2003 Geliefert am 25. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 10008101 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Mai 2003 Geliefert am 30. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 25. Juni 2001 Geliefert am 10. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Business premium account number 10275786. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent security deposit deed | Erstellt am 18. Juni 1991 Geliefert am 28. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease even date. | |
Kurze Angaben &5,225 deposited by nottinghamshire county council with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Mai 1984 Geliefert am 05. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WQUAY LTD Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Receiver/Manager bestellt |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0