KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED

KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKEITH SHARP PHARMACIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01418891
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KEITH SHARP PHARMACY LIMITED05. Feb. 198205. Feb. 1982
    STAMPONEM LIMITED10. Mai 197910. Mai 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Increase of share capital from £100 to £69,082 25/11/2011
    RES13

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 25. Nov. 2011

    • Kapital: GBP 69,082
    4 SeitenSH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Ernennung von Mr William Shepherd als Direktor am 01. Aug. 2011

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Peter Smerdon als Geschäftsführer am 01. Aug. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Jennifer Anne Brierley am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    3 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Sekretär
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Geschäftsführer
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Geschäftsführer
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Sekretär
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Sekretär
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    SHARP, Lesley Joy
    Mayfield House
    Blissford
    SP6 2JH Fordingbridge
    Hampshire
    Sekretär
    Mayfield House
    Blissford
    SP6 2JH Fordingbridge
    Hampshire
    British62700930001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Sekretär
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    COUTURIER, Christophe
    4 Clopton House
    Clopton Road
    CV37 0QR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    4 Clopton House
    Clopton Road
    CV37 0QR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    French51642250003
    DUNBAR, Dawn Marcia
    41 Glenville Road
    BH10 5DD Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    41 Glenville Road
    BH10 5DD Bournemouth
    Dorset
    British15292220001
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Geschäftsführer
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    MAJOR, Michael Evelyn
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    British31230890001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Geschäftsführer
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    SANDERS, Alan Christopher
    17 Hollytrees
    GU13 0NL Church Crookham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    17 Hollytrees
    GU13 0NL Church Crookham
    Hampshire
    British46616760001
    SHARP, Keith Edward
    13 Alyth Road
    BH3 7DF Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    13 Alyth Road
    BH3 7DF Bournemouth
    Dorset
    British15292230001
    SHARP, Lesley Joy
    Mayfield House
    Blissford
    SP6 2JH Fordingbridge
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Mayfield House
    Blissford
    SP6 2JH Fordingbridge
    Hampshire
    British62700930001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Geschäftsführer
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    SMITH, Graham Richard
    6 Stour Road
    BH8 8SY Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    6 Stour Road
    BH8 8SY Bournemouth
    Dorset
    British15292210001
    SMITH, Graham Richard
    6 Stour Road
    BH8 8SY Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    6 Stour Road
    BH8 8SY Bournemouth
    Dorset
    British15292210001
    TROUGHTON, John Mervyn
    Frolic House Woodlands Court
    Watford Village
    NN6 7XW Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Frolic House Woodlands Court
    Watford Village
    NN6 7XW Northampton
    Northamptonshire
    British1192800003
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British122881190001

    Hat KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. Mai 1994
    Geliefert am 02. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Mai 1994
    Geliefert am 01. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 448 kinson road bournemouth dorset & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Mai 1994
    Geliefert am 01. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 446 kinson road bournemouth dorset & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Mai 1994
    Geliefert am 01. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 1555/7 wimborne road bournemouth dorset & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Mai 1994
    Geliefert am 01. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 444 kinson road bournemouth dorset t/no DT123746 & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Mai 1994
    Geliefert am 09. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 51 kinson road bournemouth dorset t/no DT147721 & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 1987
    Geliefert am 13. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    446, kinson road, bournemouth, dorset.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 04. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Okt. 1985
    Geliefert am 16. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    13, queens road, westbourne, bournemouth dorset.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    • 04. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 1984
    Geliefert am 19. Apr. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1984Registrierung einer Belastung
    • 04. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0