KEENPAC LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKEENPAC LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01418926
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KEENPAC LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich KEENPAC LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KEENPAC LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KEENPAC POLYTHENE SUPPLIES LIMITED31. Dez. 197931. Dez. 1979
    KEEPAC POLYTHENE SUPPLIES LIMITED10. Mai 197910. Mai 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KEENPAC LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für KEENPAC LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 26. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 23,776
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. März 2015

    Kapitalaufstellung am 04. März 2015

    • Kapital: GBP 23,776
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    2 SeitenAA

    Ernennung von Mr Paul Nicholas Hussey als Direktor am 03. Nov. 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Brian Michael May als Direktor am 03. Nov. 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Andrew James Ball als Direktor am 03. Nov. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Lindsay Alexander Wilkie als Geschäftsführer am 03. Nov. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Helen Ruth Cockerham als Geschäftsführer am 03. Nov. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    10 SeitenAA

    Verschiedenes

    Section 519
    3 SeitenMISC

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 14. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 23,776
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Mooney als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nancy Lester als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Helen Ruth Cockerham als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Lindsay Alexander Wilkie als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von KEENPAC LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Sekretär
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    British28010290009
    BALL, Andrew James
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish95118620004
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish28010290009
    MAY, Brian Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish49698960004
    BRADSHAW, Glynn Laurence
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    Sekretär
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    British131211250001
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Sekretär
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    British21883690003
    BRADSHAW, Glynn Laurence
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    British131211250001
    BUDGE, Charles Paul
    Chandlers
    Lower Ham Lane Elstead
    GU8 6HQ Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Chandlers
    Lower Ham Lane Elstead
    GU8 6HQ Godalming
    Surrey
    EnglandBritish49031660003
    COCKERHAM, Helen Ruth
    Centurion Way
    Meridian Business Park
    LE19 1WH Leicester
    Keenpac
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    Meridian Business Park
    LE19 1WH Leicester
    Keenpac
    United Kingdom
    EnglandBritish172707800001
    CUNNINGHAM, James Alan
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    Geschäftsführer
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    EnglandBritish51864840002
    JOHNSON, Alexander Kitson
    Lillington Road
    CV32 6LN Leamington Spa
    134
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Lillington Road
    CV32 6LN Leamington Spa
    134
    Warwickshire
    United KingdomEnglish216172110001
    LESTER, Nancy Emma Sophia
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish67008510002
    LOCKYER, Robert Peter
    26 Elm Tree Road
    Cosby
    LE9 1SR Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    26 Elm Tree Road
    Cosby
    LE9 1SR Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish109919510002
    MOONEY, Andrew John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish34345860002
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    UkBritish21883690003
    SLAVIN, Desmond
    259 Markfield Lane
    LE67 9PR Markfield
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    259 Markfield Lane
    LE67 9PR Markfield
    Leicestershire
    EnglandBritish45492620001
    THOMPSON, Darren
    9 Eastgate
    Hallaton
    LE16 8UB Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    9 Eastgate
    Hallaton
    LE16 8UB Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish109919520001
    WALTERS, Andrew
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    British118764310001
    WALTERS, Andrew
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    British118764310001
    WELLS, Anthony Bernard
    28 Forest Rise
    Oadby
    LE2 4FH Leicester
    Geschäftsführer
    28 Forest Rise
    Oadby
    LE2 4FH Leicester
    British44612560001
    WILKIE, Lindsay Alexander
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish300728840001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KEENPAC LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Yorse No. 2 Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    York House
    England
    06. Apr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    York House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited By Shares
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat KEENPAC LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Share pledge
    Erstellt am 21. Mai 2002
    Geliefert am 01. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the keenpac shares and all its rights, title, interests and benefits in and to the keenpac shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in It's Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 21. Mai 2002
    Geliefert am 01. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole of the shares (the "shares") in keenpac north america limited , a new york corporation owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Mai 2002
    Geliefert am 01. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The freehold property known as plot 28B phase ii meridian business park braunstone blaby leicestershire title number LT299854. The freehold property known as 127 scudamore road leicester title number LT229493. The leasehold property known as 24A meridian business park braunstone blaby leicestershire.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in It's Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Mai 2002
    Geliefert am 01. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in It's Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 12. Mai 1999
    Geliefert am 14. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £3,630,000 being the amount of a loan advanced to the company plus a maximum of £5,350,000 due or to become due from the company to the chargee under a multi option facility granted to the company and other companies within its group together with interest and costs for the benefit of the bank which are accepted by the company
    Kurze Angaben
    The whole of the shares (the "shares") in keenpac france sarl owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge of quotas to secure own liabilities
    Erstellt am 12. Mai 1999
    Geliefert am 14. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ordinary quotas to the par value of lit 50,000,000 in keenpac italia S.R.L. plus all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 10. Feb. 1999
    Geliefert am 03. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The life policy (policy taken by the company over the life of glynn laurence bradshaw in the sum of £1,000,000 with a period of cover 5 years) (the "policy"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 10. Feb. 1999
    Geliefert am 03. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The life policy (policy taken by the company over the life of andrew walters in the sum of £500,000 with a period of cover of 5 years) (the "policy"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of stocks and shares
    Erstellt am 10. Feb. 1999
    Geliefert am 03. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    110 common stock shares in keenpac north america limited and 7000 ordinary shares in keenpac hong kong limited (the "securities"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Feb. 1999
    Geliefert am 17. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Erstellt am 10. Feb. 1999
    Geliefert am 17. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    127 scudamore rd,leicestershire; t/no LT229493. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Erstellt am 10. Feb. 1999
    Geliefert am 17. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as plot 28 b phase ii meridian business park,braunstone,blaby,leicestershire; t/no LT299854. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Dez. 1997
    Geliefert am 31. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a plot 28B phase 2 meridian business park braunstone leicester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Jan. 1995
    Geliefert am 27. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee which have been advanced by way of loan credit or for the provision of letters of credit and the like included (but not limited to) advances made by virtue of a credit facility agreement dated 25 january 1995
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Overseas Sales Limited
    • British Markitex Limited
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 1995
    Geliefert am 27. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All principal sums at any time advanced to the company by the chargees pursuant to an agreement dated 25 january 1995
    Kurze Angaben
    All that f/h land and property k/as 127 scudamore road,leicester.t/no.LT229493.
    Berechtigte Personen
    • Overseas Sales Limited
    • British Markitex LTD
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 11. Aug. 1994
    Geliefert am 19. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture dated 25TH july 1994
    Kurze Angaben
    Fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring or discounting deed dated 11TH february 1994 and all book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Aug. 1994
    Geliefert am 17. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    127 scudamore road leicester leicestershire title no LT229493.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juli 1994
    Geliefert am 02. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 15. Apr. 1991
    Geliefert am 18. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any monies standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC (please see form 395. reg m 519.C.).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 14. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 11. Mai 1990
    Geliefert am 15. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 127 scudamore road leicester and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 31. Jan. 1989
    Geliefert am 02. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    First fixed charge on book and other debts present & future & proceeds thereof (see 395 M595C for details).
    Berechtigte Personen
    • Alex Lawre Receuable Financing Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 27. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 07. Juli 1988
    Geliefert am 19. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including heritable property & assts in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 17. Jan. 1985
    Geliefert am 02. Feb. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Book debts.
    Berechtigte Personen
    • H & H Factors Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1985Registrierung einer Belastung
    • 13. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Nov. 1983
    Geliefert am 08. Nov. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/hand l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book and other debts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1983Registrierung einer Belastung
    • 13. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 08. Juli 1981
    Geliefert am 23. Juli 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys from time to time held to thecredit of the company by national westminster bank on any current deposit and/or other account which the company may now and/or hereafter have with that west bank or held by that west bank on an account earmarked re the company and/or underany deposit receipt.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Juli 1981Registrierung einer Belastung
    • 13. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0