MCSA GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MCSA GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01421913 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MCSA GROUP LIMITED?
- Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
- Betrieb von Rechenzentren (62030) / Information und Kommunikation
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich MCSA GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Greenwich 6 Mitre Passage Greenwich Peninsula SE10 0ER London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MCSA GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MAINDEC COMPUTER SOLUTIONS LIMITED | 13. Mai 2002 | 13. Mai 2002 |
| MAINDEC COMPUTER ENGINEERING LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
| MAINDEC COMPUTERS LIMITED | 22. Mai 1979 | 22. Mai 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MCSA GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MCSA GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. Dez. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 40 Seiten | AA | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Reynolds Porter Chamberlain Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1AA verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Reynolds Porter Chamberlain Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1AA geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Maindec House Holtspur Lane Wooburn Green Bucks, HP10 0AB zum Greenwich 6 Mitre Passage Greenwich Peninsula London SE10 0ER am 12. Sept. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 27 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 29. März 2019
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Robert Timms als Geschäftsführer am 29. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roger Jeffrey Timms als Geschäftsführer am 29. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Roger Timms als Geschäftsführer am 29. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Jeffrey Timms als Geschäftsführer am 29. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Stella May am 29. März 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Cessation of Roger Jeffrey Timms as a person with significant control on 29. März 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Cessation of Brenda Joyce Timms as a person with significant control on 29. März 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Notification of Park Place Technologies Limited as a person with significant control on 29. März 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Reginald Hodge als Geschäftsführer am 29. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MCSA GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLINGER, Elizabeth Ann | Geschäftsführer | Landerbrook Drive Mayfield Heights 5910 Ohio 44124 United States | United States | American | 276704390001 | |||||
| MAY, Stella Rachelle, Ms. | Geschäftsführer | Stanier Road SN11 9PX Calne 6 England | United States | American | 257114710001 | |||||
| DARRAUGH, Peter Anthony | Sekretär | Holtspur Lane Wooburn Green HP10 0AB High Wycombe Maindec House Buckinghamshire England | 202629460001 | |||||||
| PATEMAN, Alan Leslie Charles | Sekretär | 59 Kimpton Close HP2 7PW Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 82718160001 | ||||||
| TIMMS, Roger Jeffrey | Sekretär | Felden Lane Felden HP3 0BB Hemel Hempstead High Gables Hertfordshire United Kingdom | British | 2274480001 | ||||||
| BROOKE-WILLIAMS, Sasha Louise | Geschäftsführer | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | England | British | 244019070001 | |||||
| CLARE, Brian | Geschäftsführer | 12 Crabtree Lane HP3 9EG Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 22784430001 | ||||||
| DARRAUGH, Peter Anthony | Geschäftsführer | 77 Grove Road HP23 5PB Tring Hertfordshire | England | British | 82678530001 | |||||
| HODGE, Mark Reginald | Geschäftsführer | 38 Chesterfield Crescent Wing LU7 0TW Buckinghamshire | United Kingdom | British | 9536030003 | |||||
| PATEMAN, Alan Leslie Charles | Geschäftsführer | 59 Kimpton Close HP2 7PW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 82718160001 | |||||
| TIMMS, Brenda Joyce | Geschäftsführer | High Gables Felden Lane Felden HP3 0BB Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 40499630001 | |||||
| TIMMS, Christopher Jeffrey | Geschäftsführer | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | England | British | 244018980001 | |||||
| TIMMS, Paul Roger | Geschäftsführer | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | United Kingdom | British | 150237780001 | |||||
| TIMMS, Roger Jeffrey | Geschäftsführer | High Gables Felden Lane Felden HP3 0BB Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 2274480001 | |||||
| TIMMS, Scott Robert | Geschäftsführer | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | England | British | 244018950001 | |||||
| WHITE, Cherry Olive | Geschäftsführer | Kimble House Southend Common RG9 6JP Henley On Thames Oxfordshire | British | 40499660001 | ||||||
| WHITE, Richard | Geschäftsführer | Garden Cottage Winkfield Lane Maidens Green SL4 4QS Windsor | England | British | 19513930004 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MCSA GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Place Technologies Limited | 29. März 2019 | Stanier Road SN11 9PX Calne 6 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mrs Brenda Joyce Timms | 08. März 2019 | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Roger Jeffrey Timms | 06. Apr. 2016 | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MCSA GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Dez. 1997 Geliefert am 07. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Apr. 1989 Geliefert am 13. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben And heritable property & assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 14. Dez. 1987 Geliefert am 29. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a maindee house, abbey barn rd, high wycombe inc. Goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Aug. 1984 Geliefert am 17. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property mayfield house kingsmead business centre abbeybarn road wycombe marsh high wycombe buckinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Juli 1984 Geliefert am 20. Juli 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Please see doc M29. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Apr. 1982 Geliefert am 30. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital tog. With all fixtures incl trade fixtures fixed plant & machinery. (See doc M28). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0