ENODICOM NUMBER 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ENODICOM NUMBER 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01422689 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Ann'S Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TEMP-RITE INTERNATIONAL LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 2 Seiten | DS02 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Juni 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Kachmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Graham Philip Brisley Veal als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Blades als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Maurice Delon Jones am 14. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Prima Secretary Limited am 14. März 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Doerr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Geschäftsführer | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Geschäftsführer | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| HOOPER, David Ross | Sekretär | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Sekretär | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
| SISEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||||||
| AIREY, Andrew Robert | Geschäftsführer | Heywood House Mark Way GU7 2BB Godalming Surrey | England | British | 54515590004 | |||||||||
| ALLEN, Michael Philip | Geschäftsführer | 6341 Bresslyn Road Nashville Tennessee 37205 Usa | American | 33460270001 | ||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| CUTHBERTSON, George Brian | Geschäftsführer | 39 The Gardens WD1 3DN Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | 6996370001 | |||||||||
| DOERR, Thomas | Geschäftsführer | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| FINDLER, Jonathan Paul | Geschäftsführer | Westwood House Heathfield Avenue SL5 0AL Ascot Berkshire | British | 45532880003 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| KACHMER, Michael James | Geschäftsführer | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| LE CLERCQ, Michael Charles Antoine Gerard | Geschäftsführer | Strijbeekseweg 34b 2328 Meerle - Hoogstraten Provincie Antwerpen Belgium | Dutchsh | 57828370001 | ||||||||||
| MULHALL, Denis Joseph | Geschäftsführer | Fitzgeorge House Fitzgeorge Avenue KT3 4SH New Malden Surrey | England | British,Irish | 32235150003 | |||||||||
| NICORVO, Richard Eugene | Geschäftsführer | 101 Harvest Court Franklin Tennessee 37064 Usa | American | 33460290001 | ||||||||||
| OAKES, Roger Kent | Geschäftsführer | 5112 Hillsboro Road Nashville Tennessee 37215 Usa | American | 33460300001 | ||||||||||
| WISCHHUSEN, Heiner | Geschäftsführer | Osterhoizer Landstr 82b 2800 Bremen 44 Germany | German | 33460310001 | ||||||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
Hat ENODICOM NUMBER 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 08. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Erstellt am 20. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 06. Juni 1995 Geliefert am 13. Juni 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit being... Barclays bank PLC re temp-rire international limited business premium account number 30793108. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0