SHIELDTECH PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSHIELDTECH PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01423125
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SHIELDTECH PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich SHIELDTECH PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SHIELDTECH PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BASE GROUP PLC27. Juni 200227. Juni 2002
    DIGITAL SPORT PLC29. Nov. 200029. Nov. 2000
    FERRUM HOLDINGS PLC24. Nov. 198924. Nov. 1989
    FLOYD ENERGY PLC16. Mai 198816. Mai 1988
    FLOYD OIL PARTICIPATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY25. Mai 197925. Mai 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHIELDTECH PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für SHIELDTECH PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Apr. 2011

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 20. Apr. 2011

    17 Seiten2.35B

    Beendigung der Bestellung von Pommy Sarwal als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Grundy als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Paul Grundy als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B/2.14B

    9 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    2 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    42 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 5 Chesford Grange Woolston Warrington WA1 4RQ United Kingdom am 04. Nov. 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2010 mit umfangreicher Liste der Aktionäre

    18 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Aug. 2010

    Kapitalaufstellung am 09. Aug. 2010

    • Kapital: GBP 9,009,694
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Robert Denton als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    46 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Robert Denton als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Paul Grundy als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Paul Grundy als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Denton als Sekretär

    1 SeitenTM02

    legacy

    1 Seiten288a

    Beschlüsse

    Resolutions
    68 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Appointing as a director/investment the circular 22/06/2009
    RES13
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    7 Seiten395

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von SHIELDTECH PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    O`NEILL, Anthony Arthur
    12 Aran Heights
    HP8 4DZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    12 Aran Heights
    HP8 4DZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British58776190001
    POVEY, Keith, Sir
    Rufford House
    5 High Street
    LN5 0QX Brant Broughton
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Rufford House
    5 High Street
    LN5 0QX Brant Broughton
    Lincolnshire
    British123375790001
    WIGHTMAN, Timothy Redmayne
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish8610650001
    DENTON, Robert William
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    Sekretär
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    British250279270001
    GRUNDY, Paul
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    Sekretär
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    145996590001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Sekretär
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    British128648070001
    KITTOE, Stephen Maurice
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Sekretär
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British692590009
    CITY GROUP PLC
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    Sekretär
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    35794270001
    AITKEN, Robin Douglas
    Uphill
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Uphill
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    British62740310002
    AKERS, John Michael Anthony
    White Walls Farley Lane
    Romsley
    B62 0LG Halesowen
    West Midlands
    Geschäftsführer
    White Walls Farley Lane
    Romsley
    B62 0LG Halesowen
    West Midlands
    United KingdomBritish17792380001
    ANGEL, Leon
    2 Laurimel Close
    HA7 2SU Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Laurimel Close
    HA7 2SU Stanmore
    Middlesex
    British14283520001
    BAARTMANS, Kees-Jan
    Brasschaatselei 10
    FOREIGN 2950 Kapellen
    Belgium
    Geschäftsführer
    Brasschaatselei 10
    FOREIGN 2950 Kapellen
    Belgium
    Dutch28166930001
    BARKER, Crispin Jonathan
    Socknersh Manor Fontridge Lane
    TN19 7DE Etchingham
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Socknersh Manor Fontridge Lane
    TN19 7DE Etchingham
    East Sussex
    British23728980001
    BRADSHAW, Adrian Effland
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish74991310001
    BRIDGE, Peter John
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    Geschäftsführer
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    United KingdomBritish54098960002
    CARTER, John Henry
    The Chantry 51 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Chantry 51 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    British15186400001
    COOK, Peter George
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    British36768870001
    DENTON, Robert William
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish250279270001
    FRIER, Gavin Austin
    Ceadr Grove House
    Dirleton
    EH39 5DR North Berwick
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Ceadr Grove House
    Dirleton
    EH39 5DR North Berwick
    East Lothian
    British692610004
    GARNER, Marshall Kenneth
    3 Woodside Drive
    Barnt Green
    B45 8XT Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 Woodside Drive
    Barnt Green
    B45 8XT Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish52313820002
    GOURLAY, John Malcolm
    Great Gables
    Bosbury
    HR8 1QA Ledbury
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Great Gables
    Bosbury
    HR8 1QA Ledbury
    Herefordshire
    British574590001
    GRUNDY, Paul
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    EnglandBritish17333220001
    HATTON, John Leonard
    7 Merricks Close
    DY12 2PF Bewdley
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    7 Merricks Close
    DY12 2PF Bewdley
    Worcestershire
    British17792410001
    HOPKINSON, Glenn
    10 Walnut Grove
    SO22 5HR Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    10 Walnut Grove
    SO22 5HR Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish76865910002
    HORNER, Rupert Howard Milton
    Home Farm House 33 High Street
    Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Home Farm House 33 High Street
    Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish42919770001
    HUME, James Douglas Howden
    Drimard 22 East Lennox Drive
    G84 9JD Helensburgh
    Dunbartonshire
    Geschäftsführer
    Drimard 22 East Lennox Drive
    G84 9JD Helensburgh
    Dunbartonshire
    British738610001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    United KingdomBritish128648070001
    KENNEDY, Simon Mark
    106 Warwick Road Alkrington
    Middleton
    M24 1HL Manchester
    Geschäftsführer
    106 Warwick Road Alkrington
    Middleton
    M24 1HL Manchester
    British60141130001
    KITTOE, Stephen Maurice
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British692590009
    LENSEN, John
    Basaltdyk 51
    4706DR Roosendaal
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Basaltdyk 51
    4706DR Roosendaal
    The Netherlands
    Dutch38326960001
    MCCAUGHEY, Paul Trevor
    Flat 14 Tiffany Heights
    59 Standen Road
    SW18 5TF London
    Geschäftsführer
    Flat 14 Tiffany Heights
    59 Standen Road
    SW18 5TF London
    British76385200002
    MILLER, Simon Edward Callum
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    Geschäftsführer
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    ScotlandBritish176036600001
    ROUND, Richard Calvin
    5 Craigowmill
    Milnathort
    KY13 0RT Kinross Perth
    Geschäftsführer
    5 Craigowmill
    Milnathort
    KY13 0RT Kinross Perth
    British108158250001
    SARWAL, Pommy Prodaman Kumar
    28 Atwood Avenue
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    28 Atwood Avenue
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    EnglandBritish103609350001
    SMITH, Gary
    10 Farquhar Road
    Edgbaston
    B15 3RB Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Farquhar Road
    Edgbaston
    B15 3RB Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish94244890001

    Hat SHIELDTECH PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 2009
    Geliefert am 01. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bruce Gordan Stephen Jenkins and Derek James
    Transaktionen
    • 01. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 2009
    Geliefert am 25. Juni 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 08. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Juli 1997
    Geliefert am 13. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as mech tool housemains works whessoe road darlington county durham title number DU14506 and DU18947. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Juli 1997
    Geliefert am 07. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property as fabrication shop situate at riverview industrial estate off dodsworth street darlington durham title numbers DU160790 DU160904 DU181997 and DU126993. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 25. Juli 1997
    Geliefert am 06. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 24. Dez. 1993
    Geliefert am 08. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/12/93 and a mortgage debenture dated 3/12/93 as amended
    Kurze Angaben
    The tenants interest uder a lease between london & edinburgh trust (scotland) limited and the cmpany dated 13/3/and 29/4/92. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 24. Dez. 1993
    Geliefert am 08. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/12/93 and a mortgage debenture dated 3/12/93 as may be amended
    Kurze Angaben
    The tenants interest in a lease between the city of aberdeen district council and offshore drilling supplies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Dez. 1993
    Geliefert am 09. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the east side of hoylake road bottesford humberside glanford t/no HS185215 with the assigns the goodwill of the business to the bank the full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Dez. 1993
    Geliefert am 09. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a west side of rotherham road rotherham south yorkshire t/no syk 251481 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Dez. 1993
    Geliefert am 09. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of park lane basford nottingham nottinghamshire t/nos NT285394 and NT211704 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank the full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 03. Dez. 1993
    Geliefert am 09. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Dez. 1993
    Geliefert am 09. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of whessoe road darlington durham t/no DU14506 DU18947 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business the full benefitof all licences and together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Dez. 1993
    Geliefert am 09. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a river view industrial estate dodsworth street darlington durham t/no's du 181997 DU160904 DU160790 DU126993 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank full benefit f all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 30. Nov. 1993
    Geliefert am 13. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 30/11/93
    Kurze Angaben
    All and whole that area of ground lying to the north west of melville street edinburgh county of midlothian together with the buildings and other erections thereon k/a 57 melville street. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 30. Nov. 1993
    Geliefert am 13. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under theterms of a guarantee and debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 30/11/93
    Kurze Angaben
    All and whole that area of ground lying to the north west of melville street edinburgh county of midlothian. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 24. Nov. 1993
    Geliefert am 09. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1/7/93 as amended from time to time in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/11/93
    Kurze Angaben
    All and whole the area of ground lying on the south east side of greenbank crescent east tullos industrial aberdeen in the city of aberdeen extending to 3.45 acres or thereby.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 27. Mai 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 24. Nov. 1993
    Geliefert am 09. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/11/93
    Kurze Angaben
    All and whole the area of ground lying on the south east side of greenbank crescnt east tullos industrial estate aberdeen in the city of aberdeen and county foresaid extending to 3.45 acres or thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 27. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 1993
    Geliefert am 17. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property on north east side of dodsworth street darlington durham part of riverview industrial estate t/nsdu 160790,du 160904,du 181997.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juli 1993
    Geliefert am 10. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 01/07/93
    Kurze Angaben
    F/H land on west of park lane new basford nottingham part t/n nt 285394.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juli 1993
    Geliefert am 10. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 01/07/93
    Kurze Angaben
    F/H land on north east of dodsworth street darlington durham part of riverview industrial estate t/nsdu 160790,du 160904,du 181997.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 01. Juli 1993
    Geliefert am 15. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 28. Sept. 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juli 1993
    Geliefert am 15. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 28. Sept. 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SHIELDTECH PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Okt. 2010Beginn der Verwaltung
    20. Apr. 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Ellison
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Praktiker
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Gareth Wyn Roberts
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Praktiker
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0