J.B.D. PLASTICS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | J.B.D. PLASTICS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01424901 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von J.B.D. PLASTICS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich J.B.D. PLASTICS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Colson Castors Ltd Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich West Midlands |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von J.B.D. PLASTICS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CRITALION LIMITED | 01. Juni 1979 | 01. Juni 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J.B.D. PLASTICS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für J.B.D. PLASTICS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard William White als Geschäftsführer am 18. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Hinds als Geschäftsführer am 01. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Derrick James Towell als Geschäftsführer am 01. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr John Andrew Smithies als Direktor am 04. Aug. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr John Andrew Smithies als Sekretär am 04. Aug. 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Derrick James Towell als Sekretär am 04. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr John Hinds als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Lilly als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Richard William White als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Thomas William Blashill als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von J.B.D. PLASTICS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITHIES, John Andrew | Sekretär | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands | 190475700001 | |||||||
BLASHILL, Thomas William | Geschäftsführer | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands England | United States | American | Ceo | 181117260001 | ||||
SMITHIES, John Andrew | Geschäftsführer | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands | England | British | Accountant | 153425220003 | ||||
ALLEN, Paul David | Sekretär | Blakenall Lane Leamore WS31HH Walsall 70 West Midlands United Kingdom | British | Finance Director | 129651850001 | |||||
DAVIES, Margaret Ann | Sekretär | 22 Meadowside Ashford EX31 4BS Barnstaple Devon | British | 2874520001 | ||||||
DODDS, Caroline | Sekretär | Harperley Penn Lane Tanworth In Arden B94 5HH Solihull West Midlands | British | Company Executive | 51615270002 | |||||
PARTRIDGE, Nigel Keith | Sekretär | Camelot Barbican Lane EX32 8LB Barnstaple Devon | British | Director | 9988090001 | |||||
PRENTICE, Hamish Murray | Sekretär | 12 Rose Gate Aglionby CA4 8AJ Carlisle Cumbria | British | Company Executive | 23060180001 | |||||
TOWELL, Derrick James | Sekretär | 110 Kineton Green Road B92 7EE Solihull West Midlands | British | Company Director | 107375020001 | |||||
WEBB, Karl | Sekretär | 28 Rumbush Lane Dickens Heath B90 1RA Solihull | British | Financial Director | 83233170002 | |||||
ALLEN, Paul David | Geschäftsführer | Blakenall Lane Leamore WS31HH Walsall 70 West Midlands United Kingdom | British | Company Executive | 129651850001 | |||||
ALLEN, Paul David | Geschäftsführer | Blakenall Lane Leamore WS31HH Walsall 70 West Midlands United Kingdom | British | Finance Director | 129651850001 | |||||
CHAHALIS, Scott Christian | Geschäftsführer | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands England | Usa | United States | Company Director | 157829560001 | ||||
DAVIES, John Roger | Geschäftsführer | 8 The Grange Kings Bromley DE13 7HT Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 29214160002 | |||||
DAVIES, John Bernard | Geschäftsführer | 22 Meadowside Ashford EX31 4BS Barnstaple Devon | British | Managing Director | 2874530001 | |||||
DAVIES, Margaret Ann | Geschäftsführer | 22 Meadowside Ashford EX31 4BS Barnstaple Devon | British | Secretary | 2874520001 | |||||
DODDS, Caroline | Geschäftsführer | Harperley Penn Lane Tanworth In Arden B94 5HH Solihull West Midlands | England | British | Company Executive | 51615270002 | ||||
HARRINGTON, Ronald | Geschäftsführer | 7 Catherine Drive B73 6AX Sutton Coldfield | British | Company Director | 51572040002 | |||||
HINDS, John | Geschäftsführer | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands | Usa | American | Chief Financial Officer | 185679720001 | ||||
LILLY, Robert | Geschäftsführer | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands England | England | British | Company Director | 97998580001 | ||||
LILLY, Robert | Geschäftsführer | 28 Doran Close B63 1JZ Halesowen West Midlands | England | British | General Manager | 97998580001 | ||||
PARTRIDGE, Nigel Keith | Geschäftsführer | Camelot Barbican Lane EX32 8LB Barnstaple Devon | United Kingdom | British | Director | 9988090001 | ||||
PRENTICE, Hamish Murray | Geschäftsführer | 12 Rose Gate Aglionby CA4 8AJ Carlisle Cumbria | British | Company Executive | 23060180001 | |||||
PRITZKER, Robert Alan | Geschäftsführer | 1n Franklin Ste 2420 FOREIGN Chicago Illinois 60606 Usa | United States | American | Director | 47230840001 | ||||
SHIPLEY, Robert | Geschäftsführer | The Cottage Chapel Lane Ombersley WR9 0DT Worcester | British | Company Director | 43762210001 | |||||
SMITH, Christopher Joseph | Geschäftsführer | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands England | Usa | American | Company Director | 157830370001 | ||||
TOWELL, Derrick James | Geschäftsführer | 110 Kineton Green Road B92 7EE Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 107375020001 | ||||
TUCKER, Louhon | Geschäftsführer | 1161 Johnson Street Naperville 60540 Illinois Usa | United States | American | Vice President Finance | 98409710001 | ||||
VRESICS, John J | Geschäftsführer | 22 Riderwood Road Barrington Illinois 60010 Usa | United States | Usa | Company President | 152264500001 | ||||
WEBB, Karl | Geschäftsführer | 28 Rumbush Lane Dickens Heath B90 1RA Solihull | British | Financial Director | 83233170002 | |||||
WHITE, Richard William | Geschäftsführer | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands England | England | British | Managing Director | 184103760001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei J.B.D. PLASTICS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castors International Ltd | 06. Apr. 2016 | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich Bagnall Street England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat J.B.D. PLASTICS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Letter of charge | Erstellt am 03. Okt. 1995 Geliefert am 07. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from global castors limited and/or the castor company limited and/or british castors limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies to the credit of any accounts in the books of the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Juli 1995 Geliefert am 28. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
Kurze Angaben Unit 5 mullacott cros industrial estate mullacott cross ilfracombe north devon t/n-DN301631. L/h- unit 1 mullacott cross industrial estate aforesaid. L/h-unit 2 mullacott cross industrial estate aforesaid. L/h-unit 3 mullacott cross industrial estate aforesaid. L/h-unit 4 mullacott cross industrial estate aforesaid.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Juli 1995 Geliefert am 21. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or the castor company limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 20. März 1991 Geliefert am 25. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Factory premises at mullacott cross industrial estate ilfracombe north devon, & the proceeds of sale together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 06. Feb. 1989 Geliefert am 13. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 1, mullacott cross, ilfracombe devon and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 06. Feb. 1989 Geliefert am 13. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 4, mullacott cross, ilfracombe, devon and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 06. Feb. 1989 Geliefert am 13. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 3 mullacott cross, ilfracombe, devon and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 06. Feb. 1989 Geliefert am 13. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 2, mullacott cross, ilfracombe devon and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 06. Jan. 1989 Geliefert am 11. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Corporate mortgage | Erstellt am 19. Nov. 1986 Geliefert am 28. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 8/10/86. | |
Kurze Angaben (1) the goods (herein after described) (2) the benefit of all contract conditions warranties and agreements pertaining thereto (3) all logbooks maintenance records, record books manuals handbooks & other documents relating to the goods (4) the benefit of all insurances from time to time inforce to the property (5) any moneys payable to the company in connection with a sale or proposed sale of any of the goods:- 1250 ton sandretto moulding machine, serial no S7/250 no 788. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Corporate mortgage | Erstellt am 28. Apr. 1982 Geliefert am 05. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 29-10-81. | |
Kurze Angaben (1) the goods (hereinafter described) (2) the benefit of all contract conditions warranties and agreements pertaining thereto. (3) all logbooks maintenance record record books manuals handbooks & other documents relating to the goods. (4) the benefit of all insurances from time to time in force in relation to the mortgaged property. (5) any moneys payable to the company for or in connection with a sale or proposed sale of any of the goods:- one seven 250 sandretto injection moulding machine serial no. UK 331. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 13. Jan. 1982 Geliefert am 19. Jan. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H industrial unit 1 mullacott cross ilfracombe north devon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Feb. 1981 Geliefert am 19. Feb. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill and bookdebts uncalled capital. Together with all fixtures, plant and machinery (please see doc M21). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Juni 1980 Geliefert am 12. Juni 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (1) l/h property known as unit 1 mullacott cross, ifracombe industrial estate. (2) specific equitable charge over all estates or interest in any f/h or l/h property(except the legally mortgaged property) all stocks shares or other securities assignment of goodwill floating charge over the undertaking & all other property assets and rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Dez. 1979 Geliefert am 02. Jan. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £30,000 | |
Kurze Angaben Floating charge (see doc M19). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0