J.B.D. PLASTICS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJ.B.D. PLASTICS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01424901
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von J.B.D. PLASTICS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich J.B.D. PLASTICS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Colson Castors Ltd Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von J.B.D. PLASTICS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CRITALION LIMITED01. Juni 197901. Juni 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J.B.D. PLASTICS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für J.B.D. PLASTICS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Richard William White als Geschäftsführer am 18. Apr. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 22. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation o capital redemption reservef 16/12/2015
    RES13

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von John Hinds als Geschäftsführer am 01. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Derrick James Towell als Geschäftsführer am 01. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 27. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    6 SeitenAA

    Ernennung von Mr John Andrew Smithies als Direktor am 04. Aug. 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr John Andrew Smithies als Sekretär am 04. Aug. 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Derrick James Towell als Sekretär am 04. Aug. 2014

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr John Hinds als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Robert Lilly als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Richard William White als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Thomas William Blashill als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von J.B.D. PLASTICS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMITHIES, John Andrew
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Sekretär
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    190475700001
    BLASHILL, Thomas William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    United StatesAmericanCeo181117260001
    SMITHIES, John Andrew
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant153425220003
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Sekretär
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    BritishFinance Director129651850001
    DAVIES, Margaret Ann
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    Sekretär
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    British2874520001
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Executive51615270002
    PARTRIDGE, Nigel Keith
    Camelot Barbican Lane
    EX32 8LB Barnstaple
    Devon
    Sekretär
    Camelot Barbican Lane
    EX32 8LB Barnstaple
    Devon
    BritishDirector9988090001
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Sekretär
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    BritishCompany Executive23060180001
    TOWELL, Derrick James
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director107375020001
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Sekretär
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    BritishFinancial Director83233170002
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    BritishCompany Executive129651850001
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    BritishFinance Director129651850001
    CHAHALIS, Scott Christian
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    UsaUnited StatesCompany Director157829560001
    DAVIES, John Roger
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director29214160002
    DAVIES, John Bernard
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    Geschäftsführer
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    BritishManaging Director2874530001
    DAVIES, Margaret Ann
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    Geschäftsführer
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    BritishSecretary2874520001
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Executive51615270002
    HARRINGTON, Ronald
    7 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    Geschäftsführer
    7 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    BritishCompany Director51572040002
    HINDS, John
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    UsaAmericanChief Financial Officer185679720001
    LILLY, Robert
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    EnglandBritishCompany Director97998580001
    LILLY, Robert
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    Geschäftsführer
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritishGeneral Manager97998580001
    PARTRIDGE, Nigel Keith
    Camelot Barbican Lane
    EX32 8LB Barnstaple
    Devon
    Geschäftsführer
    Camelot Barbican Lane
    EX32 8LB Barnstaple
    Devon
    United KingdomBritishDirector9988090001
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Geschäftsführer
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    BritishCompany Executive23060180001
    PRITZKER, Robert Alan
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    Geschäftsführer
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    United StatesAmericanDirector47230840001
    SHIPLEY, Robert
    The Cottage Chapel Lane
    Ombersley
    WR9 0DT Worcester
    Geschäftsführer
    The Cottage Chapel Lane
    Ombersley
    WR9 0DT Worcester
    BritishCompany Director43762210001
    SMITH, Christopher Joseph
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    UsaAmericanCompany Director157830370001
    TOWELL, Derrick James
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director107375020001
    TUCKER, Louhon
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    Geschäftsführer
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    United StatesAmericanVice President Finance98409710001
    VRESICS, John J
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    Geschäftsführer
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    United StatesUsaCompany President152264500001
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Geschäftsführer
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    BritishFinancial Director83233170002
    WHITE, Richard William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    EnglandBritishManaging Director184103760001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei J.B.D. PLASTICS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Bagnall Street
    England
    06. Apr. 2016
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Bagnall Street
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageUk
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer02879952
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat J.B.D. PLASTICS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Letter of charge
    Erstellt am 03. Okt. 1995
    Geliefert am 07. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from global castors limited and/or the castor company limited and/or british castors limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies to the credit of any accounts in the books of the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 1995
    Geliefert am 28. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    Unit 5 mullacott cros industrial estate mullacott cross ilfracombe north devon t/n-DN301631. L/h- unit 1 mullacott cross industrial estate aforesaid. L/h-unit 2 mullacott cross industrial estate aforesaid. L/h-unit 3 mullacott cross industrial estate aforesaid. L/h-unit 4 mullacott cross industrial estate aforesaid.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Ban Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 1995
    Geliefert am 21. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the castor company limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 21. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. März 1991
    Geliefert am 25. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Factory premises at mullacott cross industrial estate ilfracombe north devon, & the proceeds of sale together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 21. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 1989
    Geliefert am 13. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 1, mullacott cross, ilfracombe devon and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 28. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 1989
    Geliefert am 13. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 4, mullacott cross, ilfracombe, devon and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 28. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 1989
    Geliefert am 13. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 3 mullacott cross, ilfracombe, devon and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 28. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 1989
    Geliefert am 13. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 2, mullacott cross, ilfracombe devon and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 28. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 06. Jan. 1989
    Geliefert am 11. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 28. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Corporate mortgage
    Erstellt am 19. Nov. 1986
    Geliefert am 28. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 8/10/86.
    Kurze Angaben
    (1) the goods (herein after described) (2) the benefit of all contract conditions warranties and agreements pertaining thereto (3) all logbooks maintenance records, record books manuals handbooks & other documents relating to the goods (4) the benefit of all insurances from time to time inforce to the property (5) any moneys payable to the company in connection with a sale or proposed sale of any of the goods:- 1250 ton sandretto moulding machine, serial no S7/250 no 788.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    Corporate mortgage
    Erstellt am 28. Apr. 1982
    Geliefert am 05. Mai 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 29-10-81.
    Kurze Angaben
    (1) the goods (hereinafter described) (2) the benefit of all contract conditions warranties and agreements pertaining thereto. (3) all logbooks maintenance record record books manuals handbooks & other documents relating to the goods. (4) the benefit of all insurances from time to time in force in relation to the mortgaged property. (5) any moneys payable to the company for or in connection with a sale or proposed sale of any of the goods:- one seven 250 sandretto injection moulding machine serial no. UK 331.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Jan. 1982
    Geliefert am 19. Jan. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H industrial unit 1 mullacott cross ilfracombe north devon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1982Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 06. Feb. 1981
    Geliefert am 19. Feb. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill and bookdebts uncalled capital. Together with all fixtures, plant and machinery (please see doc M21).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1981Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 09. Juni 1980
    Geliefert am 12. Juni 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (1) l/h property known as unit 1 mullacott cross, ifracombe industrial estate. (2) specific equitable charge over all estates or interest in any f/h or l/h property(except the legally mortgaged property) all stocks shares or other securities assignment of goodwill floating charge over the undertaking & all other property assets and rights.
    Berechtigte Personen
    • Dartington & Co. Limited
    Transaktionen
    • 12. Juni 1980Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 1979
    Geliefert am 02. Jan. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £30,000
    Kurze Angaben
    Floating charge (see doc M19). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Council for Small Industries in Rural Areas
    Transaktionen
    • 02. Jan. 1980Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0