ISAW REALISATIONS PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameISAW REALISATIONS PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01431689
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ISAW REALISATIONS PLC?

    • (7487) /

    Wo befindet sich ISAW REALISATIONS PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ISAW REALISATIONS PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ISA WHOLESALE PLC29. Jan. 199629. Jan. 1996
    INTERNATIONAL SYSTEMS & APPLICATIONS GROUP LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISAW REALISATIONS PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2001

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ISAW REALISATIONS PLC?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ISAW REALISATIONS PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Mitteilung über die Aufhebung des Verwaltungsbeschlusses

    4 Seiten2.19

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    6 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    4 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    4 Seiten2.15

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    Mitteilung über das Ergebnis der Gläubigerversammlung

    5 Seiten2.23

    Vorschlag des Administrators

    32 Seiten2.21

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed isa wholesale PLC\certificate issued on 29/05/03
    2 SeitenCERTNM

    Verwaltungsbeschluss

    5 Seiten2.7

    Mitteilung über den Verwaltungsbeschluss

    1 Seiten2.6

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von ISAW REALISATIONS PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    British64514410001
    MURPHY, Michael Joseph
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    British31259900002
    ROBINSON, Bruce
    2 Invicta Cottages
    Roestock Lane, Colney Heath
    AL4 0QW St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Invicta Cottages
    Roestock Lane, Colney Heath
    AL4 0QW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147379870001
    LINDLEY, Richard Malcolm
    Yew Bank Skipton Road
    Utley
    BD20 6HJ Keighley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Yew Bank Skipton Road
    Utley
    BD20 6HJ Keighley
    West Yorkshire
    British11133540001
    WHITE, Paul Gerard
    10 Pinfold Rise
    Aberford
    LS25 3EN Leeds
    Sekretär
    10 Pinfold Rise
    Aberford
    LS25 3EN Leeds
    British45623460001
    BETTS, Terence David
    63 Folds Crescent
    Beauchief
    S8 0EP Sheffield
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    63 Folds Crescent
    Beauchief
    S8 0EP Sheffield
    Yorkshire
    British82961420001
    HEAP, David Anthony
    Chapel House Farm
    Langbar
    LS29 0EN Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Chapel House Farm
    Langbar
    LS29 0EN Ilkley
    West Yorkshire
    British92787940001
    HEAP, John Andrew
    Harden Grange
    Harden
    BD16 4AX Bingley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Harden Grange
    Harden
    BD16 4AX Bingley
    West Yorkshire
    Great BritainBritish11336090001
    LINDLEY, Richard Malcolm
    Yew Bank Skipton Road
    Utley
    BD20 6HJ Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Yew Bank Skipton Road
    Utley
    BD20 6HJ Keighley
    West Yorkshire
    British11133540001
    SCANNELL, Michael
    Heatherleigh Moor Lane
    LS29 7AF Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Heatherleigh Moor Lane
    LS29 7AF Ilkley
    West Yorkshire
    British62795010001
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish57380020001
    WHITE, Paul Gerard
    10 Pinfold Rise
    Aberford
    LS25 3EN Leeds
    Geschäftsführer
    10 Pinfold Rise
    Aberford
    LS25 3EN Leeds
    United KingdomBritish45623460001

    Hat ISAW REALISATIONS PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Cross guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Feb. 2003
    Geliefert am 13. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Feb. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each and any obligor to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of credit insurance policy
    Erstellt am 05. Feb. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each or any obligor to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy all sums assured by it and all bonuses and benefits and the assignors whole rights title and interest in the policy please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Erstellt am 09. März 1998
    Geliefert am 18. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined),or any of them to any of the beneficiaries (as defined) under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 02. Okt. 1986
    Geliefert am 17. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 13. März 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Sept. 1985
    Geliefert am 27. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Sept. 1980
    Geliefert am 02. Okt. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank LTD
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1980Registrierung einer Belastung

    Hat ISAW REALISATIONS PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Mai 2003Beginn der Verwaltung
    30. März 2007Verwaltung entlassen
    Verwaltungsordnung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian David Green
    Pricewaterhouse Coopers
    9 Bond Court
    LS1 2SN Leeds
    Praktiker
    Pricewaterhouse Coopers
    9 Bond Court
    LS1 2SN Leeds
    Edward Klempka
    9 Bond Court
    Leeds
    LS1 2SN
    Praktiker
    9 Bond Court
    Leeds
    LS1 2SN
    Stephen Jonathan Taylor
    9 Bond Court
    Leeds
    Ls1 2sn
    Praktiker
    9 Bond Court
    Leeds
    Ls1 2sn
    2
    DatumTyp
    30. März 2007Beginn der Liquidation
    08. Okt. 2014Aufgelöst am
    06. Jan. 2012Abschluss der Liquidation
    30. März 2007Antragsdatum
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Edward Klempka
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praktiker
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Gillian Eleanor Bruce
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0