KUNICK (109) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKUNICK (109) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01434201
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KUNICK (109) LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich KUNICK (109) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KUNICK (109) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GAMESTEC LEISURE LIMITED02. Dez. 200202. Dez. 2002
    KUNICK LEISURE LIMITED09. Feb. 199609. Feb. 1996
    MUSIC HIRE GROUP LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KUNICK (109) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis01. Okt. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KUNICK (109) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für KUNICK (109) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    27 Seiten4.72

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Apr. 2013

    29 Seiten2.24B

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Vorschlag des Verwalters

    25 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom* am 15. Nov. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    4 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Aug. 2012

    Kapitalaufstellung am 20. Aug. 2012

    • Kapital: GBP 90,496,864.88
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Butler als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Brown als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Leisure Connection Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom* am 20. Aug. 2012

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Horsforth Mills Low Lane Horsforth LS18 4ER* am 03. Aug. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Okt. 2011

    31 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Christopher Butler als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Brown als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed gamestec leisure LIMITED\certificate issued on 25/07/12
    2 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name25. Juli 2012

    Beschluss zur Änderung der Firma am 19. Juli 2012

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    legacy

    5 SeitenMG01

    legacy

    6 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von KUNICK (109) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    British71581460002
    NICHOLLS, Julian Frederick
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish95086050001
    STILL, Richard Matthew
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71581460002
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    BAILEY, Geoffrey Raw
    5 Norgarth Close
    Soothill
    WF17 6HF Batley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Norgarth Close
    Soothill
    WF17 6HF Batley
    West Yorkshire
    British49609920001
    BROWN, Andrew Paul
    56 Bank Crest
    BD17 5HB Baildon
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    56 Bank Crest
    BD17 5HB Baildon
    West Yorkshire
    United KingdomBritish126397230001
    BUTLER, Christopher Michael
    Weaverlake Drive
    Yoxall
    DE13 8AD Burton-On-Trent
    Byron House
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Weaverlake Drive
    Yoxall
    DE13 8AD Burton-On-Trent
    Byron House
    Staffordshire
    EnglandBritish146447120001
    COPPIN, Alan Charles
    Briar Hedge
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Briar Hedge
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish82808900001
    DANIELS, Colin
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    British1278190001
    EVANS, Wayne David
    4 Arncliffe Way
    HU16 5DH Cottingham
    North Humberside
    Geschäftsführer
    4 Arncliffe Way
    HU16 5DH Cottingham
    North Humberside
    United KingdomBritish118359700001
    HODKIN, David Arthur
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    Geschäftsführer
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    United KingdomBritish40702370002
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Geschäftsführer
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritish26032950002
    JOHNSON, Alex
    40 Moorway
    Guiseley
    LS20 8LD Leeds
    Geschäftsführer
    40 Moorway
    Guiseley
    LS20 8LD Leeds
    EnglandBritish213648130001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish71715970001
    LLOYD, Derek Thomas
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    EnglandEnglish98695040001
    MEEHAN, Paul Alan
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish130608590001
    MELLOR, David Glynn
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    EnglandBritish57198790001
    NIELSEN, Rolf
    7 Autumn Crescent
    LS18 4HT Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 Autumn Crescent
    LS18 4HT Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish50980130003
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    SMITH, Richard Stephen
    26 Lascelles Hall Road
    Lascelles Hall
    HD5 0AU Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    26 Lascelles Hall Road
    Lascelles Hall
    HD5 0AU Huddersfield
    West Yorkshire
    British54147940001
    SMITH, Russell Stansfield
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    Geschäftsführer
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    British809230004
    WALTERS, Philip Donald
    Flat 5
    16 Mount Row
    W1K 3SE London
    Geschäftsführer
    Flat 5
    16 Mount Row
    W1K 3SE London
    United KingdomBritish78370620002
    WOOD, Russell Stephen
    Yew Tree House
    29 Yew Tree Road
    HD3 3QT Bichencliffe Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Yew Tree House
    29 Yew Tree Road
    HD3 3QT Bichencliffe Huddersfield
    West Yorkshire
    British64853900002

    Hat KUNICK (109) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 13. März 2012
    Geliefert am 21. März 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £43,750 plus vat.. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Computacenter (UK) Limited
    Transaktionen
    • 21. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge of deposit
    Erstellt am 18. Nov. 2011
    Geliefert am 24. Nov. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit of £23,000 and all amounts in the future credited to account number 46214410 with the bank.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge of deposit
    Erstellt am 07. Apr. 2011
    Geliefert am 12. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit of £177,255 and all amounts in the future credited to account number 46040943 with the bank. Note: the charge contains a covenant by the company that the company will not permit or create any mortgage charge or lien on the deposit or dispose of or assign the deposit.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 29. Okt. 2009
    Geliefert am 06. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £70793.75 and all sums paid to the landlord under the terms of the rent deposit deed see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Computacenter (UK) Limited
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 31. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Bank account charge and receivables assignment
    Erstellt am 20. Aug. 2009
    Geliefert am 21. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the charged accounts and the bank balances, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse, London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over shares
    Erstellt am 19. Aug. 2008
    Geliefert am 22. Aug. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and the derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse the Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 19. Aug. 2008
    Geliefert am 21. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse, London Branch (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 22 may 2002
    Erstellt am 09. Feb. 2004
    Geliefert am 25. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the newly acquired properties together with all buildings fixtures fixed plany and machinery, being all that f/h property known as the maltings wetmore road burton on trent t/n SF47581,the f/h property known as the old granary wetmore road burton on trent t/n SF4757750, the f/h property known as unit 51 hutton close, crowther industrial estate washington sunderland tyne & wear t/n TY202817.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 22 may 2002 and
    Erstellt am 13. Aug. 2002
    Geliefert am 22. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee and/or the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK588050 and f/h property k/a miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK48128. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 13. Aug. 2002
    Geliefert am 21. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the security trustee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all that freehold property known as main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK588050. All that freehold property known as miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK48128, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Nov. 1992
    Geliefert am 18. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a composite guarantee and debenture dated 12/10/92
    Kurze Angaben
    F/H property near the railway station pewsey wilts.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Banks
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Okt. 1992
    Geliefert am 21. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the "debenture"
    Kurze Angaben
    Land at automat house aqueduct road,blackburn,lancashire title number LA404853 see doc ref M554C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plcand Each of the Banksin Its Capacity as Agent and Trustee for Itself
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & trust debenture
    Erstellt am 06. März 1991
    Geliefert am 20. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the floating documents
    Kurze Angaben
    Various properties as specified in from 395 reg: m 76.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plce Governor and Company of the Bank of Scotland).(For Itself National Westminster Bank PLC and Th
    Transaktionen
    • 20. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 14. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 17. Dez. 1990
    Geliefert am 21. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 20. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 22. Jan. 1986
    Geliefert am 04. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and singular the items of equipment described in the schedule attached to the charge (see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 22. Jan. 1986
    Geliefert am 28. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Second fixed charge on all bookdebts & other debts. (See doc M57 for full details,).
    Berechtigte Personen
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Floating charbge
    Erstellt am 22. Jan. 1986
    Geliefert am 28. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over the undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 1986
    Geliefert am 23. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (1) l/h premises company a warehouse at yeadon near leeds. T/no - 227594 (2) l/h unit 1, the perivale new business centre, perivale, middx (see doc M54 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Release and debenture mortgage
    Erstellt am 22. Jan. 1986
    Geliefert am 23. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge supplemental to a chattel mortgage dated 9-3-82
    Kurze Angaben
    All and singular us item or items of equipment described in the schedule to the charge which are described as the additional items in the charge.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 1986
    Geliefert am 28. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/hold & l/hold properties as more fully described in doc M55 and continuation sheet attached. (See doc M55 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Release and further mortgage
    Erstellt am 25. Juli 1985
    Geliefert am 29. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a chattel mortgage dated 9/3/82 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    All and singular the items of equipment as listed in the schedule to the deed together with any other item or items of equipment as may be designated by midland bank PLC.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    Release and further charge
    Erstellt am 29. März 1985
    Geliefert am 02. Apr. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a chattel mortgage dated 9/3/82.
    Kurze Angaben
    All the singular items of equipment listed on the schedule to the release and further mortgage together with any other item or items of equipment as may be designated) by midland bank bank PLC ("the chattel") (see schedule for details.).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1985Registrierung einer Belastung
    Release and further mortgage
    Erstellt am 26. Okt. 1984
    Geliefert am 31. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due under a chattel mortgage 9.3.82 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    All and singular the items of equipment as listed in the schedule together with any other items or equipment as may be designated by midland bank PLC.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 1984Registrierung einer Belastung
    Release and further mortgage
    Erstellt am 29. Juni 1984
    Geliefert am 04. Juli 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all moneys due or to become due (defined in the chattel mortgage dated 9/3/82) due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All and singular the items of equipment listed on the schedule attached to the release and further mortgage together with any other items or item of equipment as may be designated by midland bank PLC ("the chattel").
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 1984Registrierung einer Belastung
    Release and further mortgage
    Erstellt am 15. März 1984
    Geliefert am 16. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due (defined in the chattel mortgage dated 9/3/82) from the company to the chargee or any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and singular the items of equipment listed on the schedule attached to the release and further mortgage together with any other item or items of equipment as may be designated by midland bank PLC (the chattel).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 1984Registrierung einer Belastung

    Hat KUNICK (109) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Nov. 2012Beginn der Verwaltung
    03. Apr. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DatumTyp
    03. Apr. 2013Beginn der Liquidation
    04. Mai 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0