AUTOTEQ LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AUTOTEQ LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01434750 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AUTOTEQ LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich AUTOTEQ LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Rsm Restructuring Advisory Llp 9th Floor M3 3HF 3 Hardman Street Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AUTOTEQ LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WALON AUTOTEC LIMITED | 06. Jan. 1992 | 06. Jan. 1992 |
| ARRIVAL FREIGHT LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
| BRONPLAN LIMITED | 04. Juli 1979 | 04. Juli 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AUTOTEQ LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AUTOTEQ LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 9 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Mai 2022 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Corrway als Geschäftsführer am 01. Juli 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Stretton Green Distribution Park Langford Way Appleton Warrington Cheshire WA4 4TQ England zum C/O Rsm Restructuring Advisory Llp 9th Floor 3 Hardman Street Manchester M3 3HF am 14. Juni 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2020 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Brian Corrway als Direktor am 30. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elaine Williams als Sekretär am 23. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sebastien Robert Desreumaux als Geschäftsführer am 16. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sebastien Robert Desreumaux als Direktor am 20. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Keith Meir als Geschäftsführer am 06. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Elaine Williams als Sekretär am 25. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rupert Henry Conquest Nichols als Sekretär am 25. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Stobart als Geschäftsführer am 20. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AUTOTEQ LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKERING, David Brian | Geschäftsführer | Stretton Green Distribution Park, Langford Way Appleton WA4 4TQ Warrington Stretton Green Distribution Centre England | England | British | 188604620002 | |||||
| ARMSTRONG, Colin | Sekretär | 200 Worle Parkway Worle BS22 6WA Weston Super Mare Somerset | British | 77327430003 | ||||||
| ARMSTRONG, Philippa | Sekretär | 162 Muller Road Horfield BS7 9QX Bristol Avon | British | 108400480001 | ||||||
| BROWN, Ian | Sekretär | 15 Cashford Gate TA2 8QA Taunton Somerset | British | 82268300001 | ||||||
| HARRIS, David Francis | Sekretär | Stretton Green Distribution Park, Langford Way Appleton WA4 4TQ Warrington Stretton Green Distribution Centre England | British | 130075020001 | ||||||
| LIGHT, John Michael Heathcote | Sekretär | Mambury Manor East Putford EX22 7UH Holsworthy Devon | British | 50795850001 | ||||||
| NICHOLS, Rupert Henry Conquest | Sekretär | Stretton Green Distribution Park, Langford Way Appleton WA4 4TQ Warrington Stretton Green Distribution Park England | 194165260001 | |||||||
| NUTTALL, Philip James | Sekretär | 19 Lingwood Park PE3 6RX Peterborough Cambridgeshire | British | 63716970001 | ||||||
| WILLIAMS, Elaine | Sekretär | Langford Way Appleton WA4 4TQ Warrington Stretton Green Distribution Park Cheshire England | 239783560001 | |||||||
| BARBER, Timothy Ray | Geschäftsführer | Sycamores New Street TA11 7NT Somerton Somerset | United Kingdom | British | 50795310003 | |||||
| BOWES, David John | Geschäftsführer | Crossway Mead Chilthorne Domer BA22 8RA Yeovil Somerset | Uk | British | 24879990002 | |||||
| BROWN, Ian | Geschäftsführer | 15 Cashford Gate TA2 8QA Taunton Somerset | British | 82268300001 | ||||||
| BROWN, Russell Stephen | Geschäftsführer | Staplehay Trull TA3 7EZ Taunton Westways House Somerset | England | British | 132668460001 | |||||
| BROWN, Russell Stephen | Geschäftsführer | Staplehay Trull TA3 7EZ Taunton Westways House Somerset | England | British | 132668460001 | |||||
| CORRWAY, Brian | Geschäftsführer | Langford Way Appleton WA4 4TQ Warrington Stretton Green Distribution Park England England | Scotland | Irish | 269114460001 | |||||
| DESREUMAUX, Sebastien Robert | Geschäftsführer | Langford Way Appleton WA4 4TQ Warrington Stretton Green Distribution Park Cheshire England | England | French | 210537940002 | |||||
| GRIFFIN, Brian Victor | Geschäftsführer | Stowe Cottage Great Comberton WR10 3DU Pershore Worcestershire | British | 32809210002 | ||||||
| HARRIS, David Francis | Geschäftsführer | Boundary Way Lufton BA22 8HZ Yeovil Stobart Automotive Somerset England | England | British | 130075020001 | |||||
| LAMPERT, Timothy Giles | Geschäftsführer | 5 Grange Park Roman Way NN4 5EA Northampton Autologic House Hampshire United Kingdom | England | British | 74811520007 | |||||
| LIGHT, John Michael Heathcote | Geschäftsführer | 5 Grange Park Roman Way NN4 5EA Northampton Autologic House | England | British | 50795850001 | |||||
| MEIR, David Keith | Geschäftsführer | Stretton Green Distribution Park, Langford Way Appleton WA4 4TQ Warrington Stretton Green Distribution Park England | United Kingdom | British | 194147640001 | |||||
| MERRY, John Charles | Geschäftsführer | Walon Boundary Way Lufton BA22 8HZ Yeovil Somerset | British | 9807640012 | ||||||
| NUTTALL, Philip James | Geschäftsführer | 5 Upper St Martins Lane WC2H 9EA London | British | 63716970003 | ||||||
| PALMER-BAUNACK, Avril | Geschäftsführer | 5 Grange Park Roman Way NN4 5EA Northampton Autologic House United Kingdom | England | British | 196667380002 | |||||
| SOMERVILLE, Andy Forbes | Geschäftsführer | 5 Grange Park Roman Way NN4 5EA Northampton Autologic House | England | British | 200512970001 | |||||
| STOBART, William | Geschäftsführer | Stretton Green Distribution Park Langford Way WA4 4TQ Appleton Stobart Group Warrington England | United Kingdom | British | 153344800001 | |||||
| WOLLASTON, Roger John | Geschäftsführer | 6 Danielsfield Road BA20 2LR Yeovil Somerset | British | 74811420001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AUTOTEQ LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahl Anglia Limited | 06. Apr. 2016 | Stretton Green Distribution Park, Langford Way Appleton WA4 4TQ Warrington C/O Eddie Stobart Limited England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat AUTOTEQ LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite all assets guarantee and debenture | Erstellt am 28. Apr. 2006 Geliefert am 12. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 27. Apr. 2006 Geliefert am 08. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture (as defined) | Erstellt am 30. Okt. 1996 Geliefert am 04. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined) and this guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Okt. 1996 Geliefert am 06. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement of even date or otherwise | |
Kurze Angaben The l/h property k/a land on the north east side of royal portbury dock road easton in gordano t/n AV216732, the l/h land on the north east side of royal portbury dock road portbury t/n AV216685 and l/h land comprising rooms 5,6,7 and 8 south office royal portbury dock t/n ST132533 and fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Juli 1981 Geliefert am 21. Juli 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equiatable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Jan. 1980 Geliefert am 25. Jan. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & beookdebts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat AUTOTEQ LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0