HEALTHCALL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HEALTHCALL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01437517 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HEALTHCALL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HEALTHCALL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HEALTHCALL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
AIR CALL (HOLDINGS) LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
GNOMECROFT LIMITED | 16. Juli 1979 | 16. Juli 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HEALTHCALL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HEALTHCALL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carl Michael Brown als Geschäftsführer am 29. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Collison als Sekretär am 29. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Notification of Hcms Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Henry Whitehead als Geschäftsführer am 12. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Carl Michael Brown als Direktor am 12. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 20 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Mark Preece als Geschäftsführer am 16. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Richard Mark Preece als Direktor am 14. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr David Collison als Sekretär am 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2016 bis 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Mark Pethick als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Victoria Haynes als Sekretär am 01. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE zum Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX am 04. Dez. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HEALTHCALL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLISON, David | Sekretär | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | 204255070001 | |||||||
COLLISON, David | Sekretär | 44 Lowther Road SW13 9NU London England | British | 34835160001 | ||||||
DAVIES, John | Sekretär | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 158562750001 | |||||||
HAYNES, Victoria | Sekretär | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
HOWARD, Nigel Peter | Sekretär | 86 Rewley Road OX1 2RQ Oxford | British | 124147420001 | ||||||
NGONDONGA, Taguma | Sekretär | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 171613130001 | |||||||
ROBERTS THOMAS, Caroline Emma | Sekretär | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | Company Secretary | 76032450005 | |||||
SPINK, David | Sekretär | 2 Monkswood West End Silverstone NN12 8TG Towcester Northamptonshire | British | 34518140003 | ||||||
BOOTY, Stephen Martin | Geschäftsführer | South Lodge Guildford Road KT24 5QE Effingham Surrey | England | British | Director | 147928010001 | ||||
BROWN, Carl Michael | Geschäftsführer | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | Accountant | 232841280001 | ||||
BURNS, Robert Ian | Geschäftsführer | 6 Netherfield Road AL5 2AG Harpenden Hertfordshire | England | British | Director | 36584260002 | ||||
ELLIS, Martyn Anthony | Geschäftsführer | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire | England | British | Group Finance Director | 95749550002 | ||||
GIBSON, Darryn Stanley | Geschäftsführer | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | Company Director | 177930490001 | ||||
HENCHEY, Maurice David | Geschäftsführer | Hamels Mead Braughing SG9 9ND Buntingford Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 17815290002 | ||||
HOWARD, Nigel Peter | Geschäftsführer | 86 Rewley Road OX1 2RQ Oxford | British | Company Director | 124147420001 | |||||
HOWARD, Stuart Michael | Geschäftsführer | Enbrook Park CT20 3SE Folkestone 2 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 160271430001 | ||||
IVERS, John Joseph | Geschäftsführer | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 77692980002 | ||||
JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor | Geschäftsführer | The Stables 89 Aston End Road Aston SG2 7EY Stevenage Hertfordshire | England | British | Group Chief Executive | 39701670001 | ||||
LYON, David Oliver | Geschäftsführer | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | England | British | Group Finance Director | 51084280003 | ||||
PAGE, Stephen Robert | Geschäftsführer | Oak Tree House Berry Lane WD3 5EY Chorleywood Hertfordshire | England | British | Managing Director | 257896700001 | ||||
PETHICK, Timothy Mark | Geschäftsführer | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 172197670001 | ||||
PREECE, Richard Mark | Geschäftsführer | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | Company Director | 97531900001 | ||||
ROBERTS THOMAS, Caroline Emma | Geschäftsführer | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | Company Secretary | 76032450005 | |||||
SPINK, David | Geschäftsführer | 2 Monkswood West End Silverstone NN12 8TG Towcester Northamptonshire | British | Company Director | 34518140003 | |||||
STEVENS, Geoffrey Robert | Geschäftsführer | Beech House 3 Millhouses Court S11 9HZ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 57380020001 | ||||
WHITEHEAD, John Henry | Geschäftsführer | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 182872850002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HEALTHCALL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcms Limited | 06. Apr. 2016 | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für HEALTHCALL LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
13. Nov. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat HEALTHCALL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Supplemental deed | Erstellt am 29. Juli 1998 Geliefert am 06. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. März 1998 Geliefert am 17. Apr. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys and obligations and liabilities due or to become due from the company and each group company (as defined) to hcms limited ("the parent") under or pursuant to the secured documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed | Erstellt am 30. März 1998 Geliefert am 15. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) or on account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Mai 1994 Geliefert am 15. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee & debenture | Erstellt am 02. März 1990 Geliefert am 08. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from healthcall group PLC. To the chargee under the terms of the facility agreement dated 20/12/89 and this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee & debenture | Erstellt am 23. Feb. 1990 Geliefert am 07. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from healthcall group PLC. To the chargee, under the terms of the mezzanine loan agreement and the "security documents" as defined | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 31. Okt. 1986 Geliefert am 05. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Sept. 1985 Geliefert am 14. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | ||
Transaktionen
| ||||
Series of debentures | Erstellt am 17. Juli 1985 Geliefert am 24. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0