CONNILL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CONNILL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01437973 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CONNILL LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich CONNILL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CONNILL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LINCOLN HANNAH LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| SWANPEARL LIMITED | 18. Juli 1979 | 18. Juli 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONNILL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CONNILL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Number One Southwark Bridge London SE1 9HL am 29. Juli 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Giovanni Stoppiello am 15. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Alison Mary Fortescue am 15. Mai 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(288) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CONNILL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTESCUE, Alison Mary | Sekretär | Baker Street W1U 7EU London 55 | British | 74955570002 | ||||||
| STOPPIELLO, Giovanni | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 105330200001 | |||||
| BLACKNELL, David | Sekretär | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | 7332320001 | ||||||
| BOSSEY, Kelvin Charles | Sekretär | Kerala 38 Ashley Road KT12 1HS Walton On Thames Surrey | British | 12989220003 | ||||||
| GORDON, John | Sekretär | 54 Brunswick Gardens W8 4AN London | British | 32801950001 | ||||||
| ROBINSON, Sarah Nicole | Sekretär | 27 Culverden Road SW12 9LT London | British | 11406070001 | ||||||
| BEATTIE, James Elliot | Geschäftsführer | Fir Trees High Street TN15 0AG Sevenoaks Kent | British | 70885370001 | ||||||
| BOSSEY, Kelvin Charles | Geschäftsführer | Kerala 38 Ashley Road KT12 1HS Walton On Thames Surrey | England | British | 12989220003 | |||||
| BROOKES, Nicholas George | Geschäftsführer | 53 Wildcroft Manor Putney SW15 3TT London | British | 64264520004 | ||||||
| GIBSON, William Knatchbull, The Honourable | Geschäftsführer | 46 Victoria Road W8 5RQ London | United Kingdom | British | 9970260002 | |||||
| GORDON, John | Geschäftsführer | 54 Brunswick Gardens W8 4AN London | British | 32801950001 | ||||||
| HALL, David James | Geschäftsführer | 33 Cheyne Avenue South Woodford E18 2DP London | British | 9806710001 | ||||||
| KING, John | Geschäftsführer | 22 Park Road TW10 6NS Richmond Surrey | Usa | 60883340001 | ||||||
| LEACH, Graham | Geschäftsführer | Chester House 237 Upper Chobham Road GU15 1HB Camberley Surrey | British | 55922930001 | ||||||
| LEVIN, Dan | Geschäftsführer | 11 St Johns Wood Terrace NW8 6JJ London | British | 6481680001 | ||||||
| MILLER, Alan Charles | Geschäftsführer | 39 Russell Road Moor Park HA6 2LP Northwood Middlesex | England | British | 9806700005 | |||||
| REYNOLDS, Stephen Paul | Geschäftsführer | 1 Flatwood Noble Tree Road TW11 8ND Hildenborough Kent | United Kingdom | British | 54899660001 | |||||
| RUBIN, Mark Elliot | Geschäftsführer | 9 The Heath WD7 7DF Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 95475630001 |
Hat CONNILL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 13. Mai 1993 Geliefert am 25. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee (as custodian for apax 1V and apax ventures 1V international partners LP) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1992 Geliefert am 02. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 1992 Geliefert am 16. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Juni 1989 Geliefert am 23. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 89 worship street l/b of hackney. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Apr. 1984 Geliefert am 30. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (See doc M27). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CONNILL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0