BEPCO AGRI LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BEPCO AGRI LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01440643 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BEPCO AGRI LIMITED?
- Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Betriebsmitteln (46610) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich BEPCO AGRI LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bepco House 316 Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Worcestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BEPCO AGRI LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BEPCO (UK) LIMITED | 05. Apr. 1991 | 05. Apr. 1991 |
| MIFFLIN TRADING LIMITED | 30. Juli 1979 | 30. Juli 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BEPCO AGRI LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BEPCO AGRI LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für BEPCO AGRI LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Dez. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed bepco (uk) LIMITED\certificate issued on 01/02/13 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Palmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Amanda Wood als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Palmer als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2012 bis 30. Sept. 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Salter als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Salvo Mazzotta als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Giorgio Fioranelli als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Pascal Vanhalst als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Bernard De Meester als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BEPCO AGRI LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOD, Amanda | Sekretär | Bepco House 316 Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Worcestershire | 174129600001 | |||||||
| DE MEESTER, Bernard Stephan | Geschäftsführer | Bepco House 316 Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Worcestershire | Belgium | Belgian | 168959600001 | |||||
| VANHALST, Pascal | Geschäftsführer | Bepco House 316 Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Worcestershire | Belgium | Belgian | 168959780001 | |||||
| BAINTON, Adrian Richard | Sekretär | 2 Oak Drive Burghfield Common RG7 3JF Reading Berkshire | British | 14830800001 | ||||||
| FRY, Wendy Kristina | Sekretär | 14 Comfrey Close RG40 5YN Wokingham Berkshire | British | 51725180001 | ||||||
| HOW, David Alfred George | Sekretär | Michaelmas Fair Ashdon CB10 2JE Saffron Walden Essex | British | 36176510001 | ||||||
| MIFFLIN, Marion Geraldine | Sekretär | The Arles 16 Greenfield Drive HR5 3AD Kington Herefordshire | British | 14318020001 | ||||||
| PALMER, Keith | Sekretär | Bute House Hill Lane WR10 3HU Elmley Castle Worcestershire | British | 79386550001 | ||||||
| STREATFIELD, Paul Richard | Sekretär | 45 Castle Lane Chandlers Ford SO53 4AH Eastleigh Hampshire | British | 49339260001 | ||||||
| ANGEL, Jeremy | Geschäftsführer | 50 Meole Rise SY3 9JF Shrewsbury Salop | British | 71195330001 | ||||||
| ASKHAM, Francis Guy Lewis | Geschäftsführer | Spinney Corner Church Lane Braishfield SO51 0QH Romsey Hampshire | United Kingdom | British | 15237500001 | |||||
| BAINTON, Adrian Richard | Geschäftsführer | 2 Oak Drive Burghfield Common RG7 3JF Reading Berkshire | England | British | 14830800001 | |||||
| BENCE, John Albert | Geschäftsführer | 25 Oakdene SL5 0BU Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 69524150001 | |||||
| BLACK, Stephen | Geschäftsführer | Les Vielles Terres Havelet GY1 1AZ St Peter Port Guernsey | British | 73554610001 | ||||||
| BRENTNALL, Trevor Alan | Geschäftsführer | Dolloways House Howbourne Lane TN22 4DR Buxted East Sussex | British | 39686000001 | ||||||
| BRETT, Jamie | Geschäftsführer | Cwmma Green Cottage Brilley HR3 6JP Whitney On Wye Herefordshire | British | 77234080001 | ||||||
| BREWIN, Peter Ronald | Geschäftsführer | Nutwood House The Street TN15 0QE Plaxtol Sevenoaks Kent | British | 45850380001 | ||||||
| BROWN, Robert Martin | Geschäftsführer | 81 Browning Road Grantley Park Church Crookham GU52 0YY Fleet Hampshire | British | 75375360001 | ||||||
| FIORANELLI, Giorgio | Geschäftsführer | Bepco House 316 Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Worcestershire | Italy | Italian | 163032950001 | |||||
| GIORDANO, Amanda Jayne | Geschäftsführer | Maesmellan New Radnor LD8 2TN Presteigne Powys | British | 14318030001 | ||||||
| HEYNEKER, Gerardus James | Geschäftsführer | 24 Fox Lane Oakley RG23 7BB Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 16423710001 | |||||
| HOW, David Alfred George, Mr. | Geschäftsführer | Michaelmas Fair Ashdon CB10 2JE Saffron Walden Essex | England | British | 21860001 | |||||
| HOWAT, James Anthony | Geschäftsführer | Lea Farmhouse Bishops Offley ST21 6EU Stafford | Uk | British | 41852290001 | |||||
| LITWINOWICZ, Leszek Richard | Geschäftsführer | 72 Rosemary Hill Road Streetly B74 4HJ Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 70815770002 | |||||
| MAZZOTTA, Salvo | Geschäftsführer | Bepco House 316 Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Worcestershire | Usa | Italian | 163043060001 | |||||
| MIDDLETON, Trevor | Geschäftsführer | High House Old Warwick Road CV35 7AA Rowington Warwickshire | England | British | 221486370001 | |||||
| MIFFLIN, Marion Geraldine | Geschäftsführer | The Arles 16 Greenfield Drive HR5 3AD Kington Herefordshire | British | 14318020001 | ||||||
| MIFFLIN, Philip George Thomas | Geschäftsführer | The Arles 16 Greenfield Drive HR5 3AD Kington Herefordshire | British | 14318070001 | ||||||
| PALMER, Keith | Geschäftsführer | Bute House Hill Lane WR10 3HU Elmley Castle Worcestershire | England | British | 79386550001 | |||||
| SALTER, Edward John | Geschäftsführer | Devon Road WV1 4BE Wolverhampton 14 West Midlands United Kingdom | England | British | 87426020002 | |||||
| STREATFIELD, Paul Richard | Geschäftsführer | 45 Castle Lane Chandlers Ford SO53 4AH Eastleigh Hampshire | British | 49339260001 | ||||||
| WILLIAMS, Ian Ralph | Geschäftsführer | Littledown Cottage Vernham Dean SP11 0EF Andover Hampshire | British | 19140250001 |
Hat BEPCO AGRI LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 19. Feb. 2007 Geliefert am 22. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Okt. 2002 Geliefert am 29. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a or being unit 2 hatton gardens industrial estate kington herefordshire HR5 3RB. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Okt. 2002 Geliefert am 29. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust debenture | Erstellt am 17. Okt. 2002 Geliefert am 23. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company as an obligor to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 12. Jan. 1998 Geliefert am 27. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to midland bank PLC including all monies, obligations and liabilities, due owing or incurred under or pursuant to the secured documents (as defined) and irrevocably and unconditionally guarantees the due performance by each other company of all it's obligations under or pursuant to the secured documents to which it is a party | |
Kurze Angaben For full details of all charged assets please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 05. Apr. 1991 Geliefert am 09. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding uncalled capital. Those mentioned above). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 26. Jan. 1989 Geliefert am 03. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on book debts | Erstellt am 21. Aug. 1986 Geliefert am 28. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Sept. 1984 Geliefert am 05. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a facility letter dated 9/7/84 and the guarantee dated 17/8/84 | |
Kurze Angaben F/H land comprising of 0.59 an acre (0.238 hectares) or thereabouts together with the premises erected thereon unit 2,hatton garden industrial estate, kington in the county of hereford & worcester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0