CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01448409 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?
- Werbeagenturen (73110) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Mazars Llp, 30 Old Bailey EC4M 7AU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SCORE OUTDOOR (MIDLANDS) LIMITED | 06. Sept. 1999 | 06. Sept. 1999 |
| VISION POSTERS LIMITED | 13. Sept. 1979 | 13. Sept. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Ver öffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 9 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Sept. 2022 | 11 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD zum C/O Mazars Llp, 30 Old Bailey London EC4M 7AU am 11. Mai 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 33 Golden Square London W1F 9JT geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 33 Golden Square London W1F 9JT zum Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD am 05. Okt. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Notification of Clear Channel Overseas Limited as a person with significant control on 03. März 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation of Clear Channel Uk Limited as a person with significant control on 03. März 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Dez. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Byron Kee Chye Hoo als Geschäftsführer am 04. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Adam Paul Raymond Tow als Direktor am 04. Mai 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Notification of Clear Channel Uk Limited as a person with significant control on 12. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCHRANE, Justin Malcolm Brian | Geschäftsführer | Old Bailey EC4M 7AU London C/O Mazars Llp, 30 | England | English | 110390650002 | |||||
| TOW, Adam Paul Raymond | Geschäftsführer | Old Bailey EC4M 7AU London C/O Mazars Llp, 30 | England | British | 66766420004 | |||||
| ANDREWS, Nick | Sekretär | 33 Golden Square London W1F 9JT | British | 109746840001 | ||||||
| BEW, Gerard Francis | Sekretär | Park House Tong Near Shifnal TF11 8PW Shifnal Shropshire | British | 11996520001 | ||||||
| EMBREY, Jacqueline Gaylor | Sekretär | 18 Crown Lane Four Oaks B74 4SU Sutton Coldfield West Midlands | British | 46477960001 | ||||||
| EMENY, Selina Holliday | Sekretär | 16 Priory Road Kew TW9 3DF Richmond Surrey | British | 76404320002 | ||||||
| TERRY, Philip | Sekretär | 2 Bluebird Close WS14 9YL Lichfield Staffordshire | British | 76924060001 | ||||||
| ANDREWS, Nicholas James | Geschäftsführer | 33 Golden Square London W1F 9JT | United Kingdom | British | 168572900001 | |||||
| ATKINSON, Robert Nigel | Geschäftsführer | 33 Golden Square London W1F 9JT | United Kingdom | British | 128922360001 | |||||
| BEVAN, Jonathan David | Geschäftsführer | 15 Denning Road Hampstead NW3 1ST London | United Kingdom | British | 110358490001 | |||||
| BEW, Gerard Francis | Geschäftsführer | Park House Tong Near Shifnal TF11 8PW Shifnal Shropshire | England | British | 11996520001 | |||||
| BOWMAN, John Reid | Geschäftsführer | 5 Hamilton Road BA1 5SB Bath Bath And North East Somerset | England | British | 79292840001 | |||||
| FINDLAY, Richard | Geschäftsführer | Woodville 20 Laverockbank Road EH5 3DE Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 35695630001 | |||||
| FRANCE, Julie | Geschäftsführer | 10 Park Avenue SW14 8AT London | England | British | 110526070001 | |||||
| GEORGE, Stephen Terence | Geschäftsführer | 5 Wood Lane Streetly B74 3LP Sutton Coldfield West Midlands | British | 24649850001 | ||||||
| HOO, Byron Kee Chye | Geschäftsführer | 33 Golden Square London W1F 9JT | England | British | 214640470001 | |||||
| O'HARA, Henry John | Geschäftsführer | 9 Croftdown Road B17 8RA Birmingham West Midlands | British | 11996550003 | ||||||
| OLIVER, David Henry Maxwell | Geschäftsführer | 33 Golden Square London W1F 9JT | United Kingdom | British | 67052550001 | |||||
| SPRING, Stephanie | Geschäftsführer | Courtnell Street W2 5BX London 34 | England | British | 102849950001 | |||||
| WILSON, Alan Raeburn | Geschäftsführer | 11 Inchcolm Terrace EH30 9NA South Queensferry West Lothian | British | 33799400001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Channel Overseas Limited | 03. März 2021 | Golden Square W1F 9JT London 33 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Clear Channel Uk Limited | 12. Feb. 2018 | Golden Square W1F 9JT London 33 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Clear Channel Central Limited | 31. Jan. 2017 | Deerdykes View Cumbernauld G68 9HN Glasgow 119 Scotland | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 61 charlotte street,birmingham,west midlands t/n WM394463 and proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 60 charlotte street,birmingham,west midlands t/n WM379419 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 3/4/5 water court,36 water street,birmingham west midlands t/n WM473698 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 10. Dez. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 02. Juli 1993 Geliefert am 16. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Nov. 1992 Geliefert am 11. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. März 1991 Geliefert am 13. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 61 charlotte street birmingham west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. März 1991 Geliefert am 13. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 3, 4 and 5 lansdowne house, (otherwise known as water court) water street, birmingham, west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. März 1991 Geliefert am 13. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 60 charlotte street birmingham west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 05. Juli 1990 Geliefert am 11. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 06. März 1990 Geliefert am 08. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property 60 and 61 charlotte street, birmingham west midlands t/ns wm 379419 and wm 394463 together with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 19. Juli 1989 Geliefert am 01. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H units 3, 4 & 5 lansdowne house, water street birmingham W. midlands & goods & goodwill (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Nov. 1986 Geliefert am 25. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £80,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben F/H three stoney office premises known as 61 charlotte street, birmingham west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Apr. 1986 Geliefert am 06. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property being part of 57/61 charlotte street, birmingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 06. Juni 1985 Geliefert am 12. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Stocks, shares & other securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0