WXYZ CORPORATION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WXYZ CORPORATION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01455007 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WXYZ CORPORATION LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich WXYZ CORPORATION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central Square 8th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WXYZ CORPORATION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ASTRACAST LIMITED | 25. Jan. 2013 | 25. Jan. 2013 |
| ASTRACAST PLC | 25. Jan. 2013 | 25. Jan. 2013 |
| JACUZZI UK GROUP PLC | 02. Okt. 2000 | 02. Okt. 2000 |
| SPRING RAM HOLDINGS PLC | 16. Apr. 1993 | 16. Apr. 1993 |
| RAM BATHROOMS PLC | 18. Okt. 1979 | 18. Okt. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WXYZ CORPORATION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 01. Okt. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WXYZ CORPORATION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 31 Seiten | LIQ14 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Mai 2022 | 31 Seiten | LIQ03 | ||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:Secretary of state's release of liquidator. | 1 Seiten | LIQ MISC | ||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 13 Seiten | LIQ10 | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 15 Seiten | 600 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Mai 2021 | 32 Seiten | LIQ03 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Mai 2020 | 23 Seiten | LIQ03 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Mai 2020 | 23 Seiten | LIQ03 | ||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:Secretary of State's Certificate of Release of Liquidator | 3 Seiten | LIQ MISC | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Mai 2019 | 25 Seiten | LIQ03 | ||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 17 Seiten | LIQ10 | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | Seiten | 2.34B | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 17 Seiten | LIQ10 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Mai 2018 | 24 Seiten | LIQ03 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Mai 2017 | 24 Seiten | LIQ03 | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:court order - removal/replacement of liquidator | 10 Seiten | LIQ MISC OC | ||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Benson House 33 Wellington Street Leeds LS1 4JP zum Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 14. Okt. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. Mai 2016 | 3 Seiten | 3.6 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 17. Dez. 2015 | 3 Seiten | 3.6 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von WXYZ CORPORATION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SPRING RAM CORPORATION LIMITED | Geschäftsführer | Roydsdale Way Euroway Industrial Estate 572 BD4 6SE Bradford 21 West Yorkshire England |
| 174629640002 | ||||||||||
| BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Sekretär | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 27825440001 | ||||||||||
| EDWARDS, John | Sekretär | Rectory View Pinfold Lane WF14 9JA Mirfield West Yorkshire | British | 3313700002 | ||||||||||
| MACKINNON, David Stuart | Sekretär | 4 Meadow Fold Uppermill OL3 6EZ Oldham Lancashire | British | 64869460001 | ||||||||||
| WEAVER, Paul | Sekretär | 34 High Street Farsley LS28 5LH Pudsey West Yorkshire | British | 45193280001 | ||||||||||
| BARRE, Steven Craig | Geschäftsführer | 777 South Flagler Drive Suite 1100 West Palm Beach Florida Fl33401 6102 Usa | American | 44233790001 | ||||||||||
| BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Geschäftsführer | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 27825440001 | ||||||||||
| BELL, Alan Wilfred | Geschäftsführer | 14 Avenue Clamart DN15 8EQ Scunthorpe South Humberside | England | British | 10874670001 | |||||||||
| BROWN, Stephen John | Geschäftsführer | Wharferise 111 Weston Lane LS21 2DF Otley West Yorkshire | British | 70149030001 | ||||||||||
| CLARKE, Noel Christopher | Geschäftsführer | 7 Packwood Court Bucknell Close B91 3SZ Solihull West Midlands | British | 58258900001 | ||||||||||
| COLVER, Erica Ann | Geschäftsführer | 73 Mount Pleasant Drive DE56 2TQ Belper Derbyshire | British | 41870240002 | ||||||||||
| COX, Stephen John | Geschäftsführer | 27 Briksdal Way Lostock BL6 4PQ Bolton Lancashire | United Kingdom | British | 36679080002 | |||||||||
| DEVINE, Donald Charles | Geschäftsführer | 777 South Flagler Drive Suite 1100 West Palm Beach Florida Fl33401-6102 Usa | American | 84975190004 | ||||||||||
| EDWARDS, John | Geschäftsführer | Rectory View Pinfold Lane WF14 9JA Mirfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 3313700002 | |||||||||
| ELLA, George Henry | Geschäftsführer | 4 Moss Close East Bridgford NG13 8LG Nottingham Nottinghamshire | British | 28100100001 | ||||||||||
| ELLA, George Henry | Geschäftsführer | 4 Moss Close East Bridgford NG13 8LG Nottingham Nottinghamshire | British | 28100100001 | ||||||||||
| FARR, Ronald | Geschäftsführer | Greenways 7 Breary Lane East Bramhope LS16 9BH Leeds West Yorkshire | British | 38053260001 | ||||||||||
| FARRELL, William Anthony Augustine | Geschäftsführer | 245 Whitechapel Road Scholes BD19 6HN Cleckheaton West Yorkshire | Irish | 30086570001 | ||||||||||
| FLANNERY, Lisa | Geschäftsführer | 28 Lee Lane East Horsforth LS18 5RE Leeds West Yorkshire | England | British | 69964220001 | |||||||||
| HASSELL, Harold Robert | Geschäftsführer | Whitecroft Browgate Baildon BD17 6NQ Bradford West Yorkshire | British | 44943970001 | ||||||||||
| HERRMANN, Paul Alan | Geschäftsführer | 5336 Stonehurst Drive Martinez California Ca 94553 Usa | American | 72635630002 | ||||||||||
| JACUZZI, Roy A | Geschäftsführer | 142 Silver Oak Terrace 94563 Orinda California | American | 38833370001 | ||||||||||
| KOOS, Thomas David | Geschäftsführer | Falconridge Drive CA 92679 Coto De Caza 8 California | Usa | United States | 135688380001 | |||||||||
| LEAMAN, Peter Harry | Geschäftsführer | Snug House 1 Snug Lane Hepworth HD9 1RP Huddersfield | United Kingdom | British | 76423940001 | |||||||||
| LOVALLO, Anthony | Geschäftsführer | 21 Cobtail Way Simsbury Ct 06070 United States | United States | American | 134693600001 | |||||||||
| MACKENZIE, Andrew Macgregor | Geschäftsführer | Stridings 33 Hazel Grove Greave OL13 9XT Bacup Lancashire | British | 38695210001 | ||||||||||
| MACKINNON, David Stuart | Geschäftsführer | 4 Meadow Fold Uppermill OL3 6EZ Oldham Lancashire | England | British | 64869460001 | |||||||||
| MACLEAN, George Hobart | Geschäftsführer | 16 Canterbury Lane Summit Nj 07901 FOREIGN Usa | American | 56303290001 | ||||||||||
| MARINI, Alex Paul | Geschäftsführer | 1801 Pittsburgh Avenue Erie Pennsylvania 16502 America | American | 109722500001 | ||||||||||
| MOYES, Hartley Richard | Geschäftsführer | Ashridge Green Lane Linton LS22 4HT Wetherby West Yorkshire | British | 36515820004 | ||||||||||
| MUNK, Peter | Geschäftsführer | 21 Roydsdale Way Euroway Industrial Estate BD4 6SE Bradford Woodlands West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Danish | 112581070001 | |||||||||
| PARK, Jeffrey Bryan | Geschäftsführer | 777 South Flagler Drive Suite 1100 West Palm Beach Florida Fl33401-6102 Usa | American | 84975330003 | ||||||||||
| PEARSON, Christopher | Geschäftsführer | Wellington Street LS1 4JP Leeds Benson House 33 | England | British | 174624400001 | |||||||||
| PRINCE, Mark Bramley | Geschäftsführer | Oak Cottage Leas Gardens Jackson Bridge HD9 1UG Huddersfield West Yorkshire | Wales | Welsh | 50891570001 | |||||||||
| PROCTOR, John Peter Frederick | Geschäftsführer | Fylde House Frilsham Park Yattendon RG16 0XT Newbury Berkshire | British | 43761010001 |
Hat WXYZ CORPORATION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 19. Juli 2013 Geliefert am 23. Juli 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2012 Geliefert am 28. Dez. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 11. Dez. 2012 Geliefert am 17. Dez. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit of £60,000 and all amounts in the future credit to account number 46976507 with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Feb. 2007 Geliefert am 23. Feb. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings at number one holden ing way birstall west yorkshire t/no's WYK423063,WYK423980 and WYK590022,f/h land and buildings at roysdale way euroway trading estate bradford west yorkshire t/no's WYK214956 and WYK158634 and f/h property k/a land and building at silverdale road newcastle under lyme staffordshire t/no SF151966 and all benefits in respect of all contracts or policies of insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Feb. 2007 Geliefert am 23. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property,all licences,rental income,all fixed and other plant and machinery,computers,vehicles,office equipment and other chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 11. März 1996 Geliefert am 26. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 1993 Geliefert am 22. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 15. Juli 1986 Geliefert am 18. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold wharedale road euroway industrialestate bradford west yorkshire. Title nowyk 317452 and wyk 309056. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 23. Nov. 1981 Geliefert am 02. Dez. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land with buildings on the north easternly and south westernly sides of walton street, sowerby bridge, west yorkshire. Title no wyk 185112. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 21. Jan. 1980 Geliefert am 30. Jan. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WXYZ CORPORATION LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Receiver/Manager bestellt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Receiver/Manager bestellt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Receiver/Manager bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0