CHIEFTAIN GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHIEFTAIN GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01455149 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
- Herstellung von anderen Metallwaren (25990) / Verarbeitendes Gewerbe
- Sonstige Bauinstallationen (43290) / Bauwesen
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen
Wo befindet sich CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o C/O REDHALL GROUP PLC Unit 3 Calder Close WF4 3BA Wakefield West Yorkshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CHIEFTAIN GROUP P.L.C. | 11. Aug. 1987 | 11. Aug. 1987 |
| CHIEFTAIN INSULATION LIMITED | 18. Okt. 1979 | 18. Okt. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2018 bis 31. März 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 014551490013, erstellt am 24. Jan. 2019 | 46 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 014551490012, erstellt am 24. Jan. 2019 | 45 Seiten | MR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Russell David Haworth am 10. Jan. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Wayne Pearson als Geschäftsführer am 03. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Russell David Haworth als Direktor am 03. Nov. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Philip Comer am 09. Aug. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher John Kelly als Sekretär am 01. Juli 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Philip Comer als Sekretär am 02. Juli 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher John Kelly als Geschäftsführer am 29. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Philip Comer als Direktor am 02. Juli 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Brierley als Geschäftsführer am 31. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Wayne Pearson als Direktor am 19. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN zum C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA am 05. Aug. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMER, Simon Philip | Sekretär | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 248241940001 | |||||||
| COMER, Simon Philip | Geschäftsführer | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 206088760003 | |||||
| HAWORTH, Russell David | Geschäftsführer | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 201533400002 | |||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Sekretär | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| KELLY, Christopher John | Sekretär | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 187596050001 | |||||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Sekretär | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | British | 134974090001 | ||||||
| ADAMS, Laurence George | Geschäftsführer | 15 Rolley Way Castlefields NE42 5FH Prudhoe Northumberland | England | British | 87979230002 | |||||
| BRIERLEY, Philip | Geschäftsführer | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 54808010002 | |||||
| CORBISHLEY, Michael | Geschäftsführer | Overidge Farm Beckside Cartmel LA11 7SP Grange-Over-Sands Cumbria | England | British | 101553180002 | |||||
| COULSON, William Andrew | Geschäftsführer | 40 Holly Avenue Jesmond NE2 2PY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 36723860001 | |||||
| CUTCHIE, Anthony William | Geschäftsführer | 68 Davison Avenue NE26 3SU Whitley Bay Tyne & Wear | United Kingdom | British | 45955990001 | |||||
| DAWSON, John Frederic | Geschäftsführer | Park Dale LS29 6LW Menston 1 West Yorkshire | British | 8366360002 | ||||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Geschäftsführer | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| FLEETWOOD, Christopher John | Geschäftsführer | 4 The Meadows DL10 7DU Richmond North Yorkshire | United Kingdom | British | 1718030001 | |||||
| FOSTER, Robert Simon | Geschäftsführer | Aish TQ10 9JG South Brent Stamford Devon | England | British | 134973970001 | |||||
| GOODENOUGH, Anthony | Geschäftsführer | Bakery Drive Grange Park TS19 0SN Stockton-On-Tees 1 Cleveland | England | British | 139196050001 | |||||
| IREDALE, George Henry Cecil | Geschäftsführer | Redmays 14 North Lodge Lambton Park DH3 4AZ Chester Le Street County Durham | British | 141871680001 | ||||||
| JACKSON, David James | Geschäftsführer | 10 Stone Rings Close HG2 9HZ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 62867720010 | |||||
| JESTER, Tony | Geschäftsführer | 6 Cranbourne Drive TS10 2SP Redcar Cleveland | England | British | 107694130001 | |||||
| JOHNSON, Raymond | Geschäftsführer | 1 Colville Court DH9 6UW East Stanley County Durham | England | British | 266049760001 | |||||
| KELLY, Christopher John | Geschäftsführer | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 188444350001 | |||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Geschäftsführer | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | England | British | 134974090001 | |||||
| MARTINDALE, Stephen Richard | Geschäftsführer | Am Waldeck 14 FOREIGN 34537 Bad Wildungen Germany | Germany | British | 77194110002 | |||||
| O'KANE, John Peter | Geschäftsführer | Station Lane Burton Leonard HG3 3RU Harrogate Holly Cottage North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 106172200001 | |||||
| OLIVER, Malcolm William | Geschäftsführer | 12c Burtree Lane DL3 0XQ Darlington County Durham | England | British | 143300760001 | |||||
| PEARSON, Wayne | Geschäftsführer | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 212154420001 | |||||
| PENDLETON, Alan George | Geschäftsführer | 12 Harrop Road Hale WA15 9BX Altrincham Cheshire | British | 30248370001 | ||||||
| PRICE, Anthony Hall | Geschäftsführer | Irton CA19 1UZ Holmrook Mecklin Cumbria | England | British | 134973860001 | |||||
| SHIPPEN, Kenneth | Geschäftsführer | 14 Rectory Park NE61 2SZ Morpeth Northumberland | British | 67917400001 | ||||||
| SHUTTLEWORTH, Richard Peter | Geschäftsführer | c/o C/O Redhall Group Plc Red Hall Court WF1 2UN Wakefield 1 West Yorkshire England | England | British | 58727820002 | |||||
| TAYLOR, William Platt | Geschäftsführer | Ryton House Mainsforth DL17 9AA Ferryhill County Durham | British | 7203810001 | ||||||
| WARDLE, Peter | Geschäftsführer | 14 Brandling Park Jesmond NE2 4RR Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 73518260002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redhall Group Plc | 06. Apr. 2016 | Calder Close Durkar WF4 3BA Wakefield Unit 3 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CHIEFTAIN GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 24. Jan. 2019 Geliefert am 29. Jan. 2019 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 24. Jan. 2019 Geliefert am 29. Jan. 2019 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 24. Dez. 2015 Geliefert am 02. Jan. 2016 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Jan. 2011 Geliefert am 28. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Apr. 2009 Geliefert am 09. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Mai 2004 Geliefert am 17. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 09. Sept. 1996 Geliefert am 12. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Dean smith & grace model 20SB surfacing and boring lathe 29IN swing serial no 28803 richards model PR2N horizontal facing and boring machine serial no 28803 atlas copco model GA708 packaged rotary screw air compressor serial no 753329 and 753330 for further details please see form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Aug. 1996 Geliefert am 13. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises at bath street walker newcastle upon tyne tyne and wear t/no:- ty 7137. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 02. Nov. 1994 Geliefert am 11. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 26. Aug. 1992 Geliefert am 09. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See doc ref M593C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Jan. 1988 Geliefert am 05. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Juni 1985 Geliefert am 11. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that land at arrow close, killingwood north tyneside, tyne & wear with the factory premises t/n ty 157748. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 21. Sept. 1984 Geliefert am 28. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or sheaffer fabrications limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0