B.V.S. WATFORD LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameB.V.S. WATFORD LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01460220
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von B.V.S. WATFORD LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich B.V.S. WATFORD LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von B.V.S. WATFORD LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für B.V.S. WATFORD LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Matthew Jowett als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Philip Harrison als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    5 SeitenAA

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Jan. 2010

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Vt House, Grange Drive Hedge End Southampton Hampshire SO30 2DQ am 16. Feb. 2010

    2 SeitenAD01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Matthew Paul Jowett am 15. Dez. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Matthew Paul Jowett am 15. Dez. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Philip James Harrison am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Richard Davies am 13. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Okt. 2009

    Kapitalaufstellung am 27. Okt. 2009

    • Kapital: GBP 1,250,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von B.V.S. WATFORD LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, John Richard
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritishManaging Director128289970002
    COKER, Peter John
    12 Crispin Field
    Pitstone
    LU7 9BG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Sekretär
    12 Crispin Field
    Pitstone
    LU7 9BG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British20675290001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Sekretär
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Sekretär
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    GOWER, Angela
    53 Chipping Vale
    Emerson Valley
    MK4 2HT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    53 Chipping Vale
    Emerson Valley
    MK4 2HT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British31041710002
    HODGES, Andrew William
    Flat 202
    7 Garden Walk
    EC2A 3EW London
    Sekretär
    Flat 202
    7 Garden Walk
    EC2A 3EW London
    BritishChartered Secretary77527910003
    IVES, Deborah Ann
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    Sekretär
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    British61720060001
    JONSSON, Elizabeth Irvine Reid
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British71376550001
    JOWETT, Matthew Paul
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Sekretär
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    British205867540001
    NICHOLLS, Elizabeth Ann
    150 Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SJ London
    Sekretär
    150 Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SJ London
    BritishManager - Share Schemes123981610001
    RICHARDSON, Elaine
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    British36633090001
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Sekretär
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary70326980001
    COSGROVE, Peter
    36 Grove Road
    LE10 2AD Burbage
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    36 Grove Road
    LE10 2AD Burbage
    Leicestershire
    BritishManaging Director33464380002
    CUNDY, Christopher John
    74 Downscroft Gardens
    Hedge End
    SO30 4RS Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    74 Downscroft Gardens
    Hedge End
    SO30 4RS Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant61210490001
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Geschäftsführer
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritishInsurance Company Official105999210001
    GREEN, Tresham Edward David
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    Geschäftsführer
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    BritishDirector20695790001
    HARRIS, Peter Robert
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritishFinance Director50619920001
    HARRISON, Philip James
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritishAccountant126366670001
    ILIC, Kosovka
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    Geschäftsführer
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    BritishDirector20675310001
    JONSSON, Elizabeth Irvine Reid
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishAssistant Secretary71376550001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official145338560001
    PRICE, David John
    Wykham Helmdon Road
    Sulgrave
    OX17 2SQ Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Wykham Helmdon Road
    Sulgrave
    OX17 2SQ Banbury
    Oxfordshire
    BritishAccountant45828440002
    SIMPSON, Alan Keith
    Watchbury Hill Hareway Lane
    Barford
    CV35 8DD Warwick
    Geschäftsführer
    Watchbury Hill Hareway Lane
    Barford
    CV35 8DD Warwick
    BritishManaging Director35940110003
    SMALE, Sarah Anne Margaret
    2 The Green
    Longwick
    HP27 9QY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 The Green
    Longwick
    HP27 9QY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretarial Assistant37137790002
    SMITH, David Michael
    Woodlands
    Main Drive
    CV35 9BT Moreton Paddox
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Woodlands
    Main Drive
    CV35 9BT Moreton Paddox
    Warwickshire
    BritishCompany Director47361390001
    SNOWBALL, Patrick Joseph Robert
    The Old Rectory
    Longham
    NR19 2RG East Dereham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Longham
    NR19 2RG East Dereham
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official145338520001
    TARRANT, Simon Edward
    Redlands Farm
    Duncton
    GU28 0JY Petworth
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Redlands Farm
    Duncton
    GU28 0JY Petworth
    West Sussex
    BritishEngineer35197570012
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Geschäftsführer
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    AVIVA DIRECTOR SERVICES LIMITED
    St. Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Geschäftsführer
    St. Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    60496090003

    Hat B.V.S. WATFORD LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge
    Erstellt am 26. März 1996
    Geliefert am 27. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and conditional sale agreements
    Kurze Angaben
    Sub hiring agreements made in respect of the goods briefly described in the schedule to form 395 all monies payable under the sub-hiring agreements the benefit of all guarantees and insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 27. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary charge
    Erstellt am 16. Jan. 1996
    Geliefert am 17. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a master agreement dated 6TH july 1993
    Kurze Angaben
    All the company's rights title and interest in the sub-hire agreements as described in the schedule to form 395 for this charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 18. Okt. 1995
    Geliefert am 03. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £220,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All right title benefit & interest in & to moneys payable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Woodchester Finance Limited
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 21. Juli 1995
    Geliefert am 08. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 21 july 1995
    Kurze Angaben
    All the right,title and interest in relation to:-sub-lease agreement no:M468/77WIM between the company and O.C.summers LTD in respect of vehicles as follows:-10XFORD/iveco 190 2.5 vans reg nos.M468 wim.M469 wim.M474 wim.M475 wim.M473 wim.M472 wim.M470 wim.M471 wim.M476 wim.M477 wim.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eft Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule pursuant to a master agreement dated 6TH july 1993
    Erstellt am 04. Nov. 1994
    Geliefert am 05. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company`s right title and interest in the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 1994
    Geliefert am 22. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hitachi Credit (U.K.) PLC,
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 01. Juli 1994
    Geliefert am 04. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 1ST july 1994
    Kurze Angaben
    Fixed charge over assets each sub-lease agreement all rights interests and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eft Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule pursuant to a master agreement dated 6TH july 1993
    Erstellt am 28. Apr. 1994
    Geliefert am 29. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment.
    Erstellt am 25. März 1994
    Geliefert am 06. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest of whatever nature in and to all the sub hire agreements including without limitation ,the right to receive the sub hire debts,.please see doc for further details,.
    Berechtigte Personen
    • Internationale Nederlanden Lease (U.K.) Limited,
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge.
    Erstellt am 02. Feb. 1994
    Geliefert am 08. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at mark road, hemel hempstead, hertfordshire,.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC,.
    Transaktionen
    • 08. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule.
    Erstellt am 02. Sept. 1993
    Geliefert am 03. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and under the sub hire agreements as described in the schedule attached to form 395.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC,
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master agreement
    Erstellt am 06. Juli 1993
    Geliefert am 13. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the companys roghts title and interest in the sub-hire agreements for full details see form 395 ref M64C.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC, Royscot Leasing Limited, Royscot Industrial Leasing Limited, Royscot Commercial Leasing Limited, Royscot Spa Leasing Limited
    Transaktionen
    • 13. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental schedule
    Erstellt am 26. Feb. 1993
    Geliefert am 27. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights title interest in the sub hire agreements .see schedule attached.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule
    Erstellt am 01. Dez. 1992
    Geliefert am 05. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a master agreement dated 18/07/89
    Kurze Angaben
    All rights title interest in and to the agreements .see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over sub lease agreements
    Erstellt am 30. Jan. 1992
    Geliefert am 18. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements (as defined)
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all sub lease agreements entered into at any time by the company for full details see form 395 m/143/c.
    Berechtigte Personen
    • Mercedes-Benz Finance Limited
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Schedule
    Erstellt am 11. Dez. 1991
    Geliefert am 12. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 18/07/89
    Kurze Angaben
    See form 395 for schedule.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 01. Okt. 1991
    Geliefert am 17. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a leasing agreement
    Kurze Angaben
    Sub leases, hiring agreements and the monies payable thereunder see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Lease Plan UK Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 01. Okt. 1991
    Geliefert am 17. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a leasing agreement
    Kurze Angaben
    Sub leases, hiring agreements and the monies payable thereunder see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Lease Plan UK Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 01. Okt. 1991
    Geliefert am 17. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a leasing agreement
    Kurze Angaben
    Sub leases, hiring agreements and the monies payable thereunder see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Lease Plan UK Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule
    Erstellt am 27. Aug. 1991
    Geliefert am 28. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a master agreement dated 18 july 1989
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in the finance agreements and specific contracts. First fixed charge over goods (defined) see form 395 ref. M93C for further details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 28. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule
    Erstellt am 21. Aug. 1991
    Geliefert am 23. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a master block mortgage agreement dated 18/7/89
    Kurze Angaben
    All right, title & interest in the finance agreements and specific contracts described in the schedule see form 395/m/215/c for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule
    Erstellt am 18. Juni 1991
    Geliefert am 18. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master block mortgage agreement dated
    Kurze Angaben
    All the companys right title and interest in the finance agreements and specific contracts (if any) relating to such finance agreements by way of first charge, the goods.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule
    Erstellt am 18. Apr. 1991
    Geliefert am 19. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master block mortgage agreement dated 18.7.89.
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in the finance agreement and specific contracts (if any) see form 395 and schedule (ref 110) for details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 09. Apr. 1991
    Geliefert am 11. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All rights title benefit interests on and to the sub leases see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Baltic Industrial Supply Company Limited
    Transaktionen
    • 11. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 06. Feb. 1991
    Geliefert am 22. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal agreement as defined.
    Kurze Angaben
    All rights, monies, guarantee and insurance pursuant to all hire or lease agreements.
    Berechtigte Personen
    • General Guarantee Corporation Limited
    Transaktionen
    • 22. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat B.V.S. WATFORD LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Jan. 2010Beginn der Liquidation
    04. Aug. 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0