LEMACROWN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEMACROWN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01462555
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEMACROWN LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LEMACROWN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Warwick House PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LEMACROWN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ARLINGTON RETAIL DEVELOPMENTS LIMITED18. Jan. 198818. Jan. 1988
    ARLINGTON PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED13. Apr. 198713. Apr. 1987
    SOLUSCROWN LIMITED22. Nov. 197922. Nov. 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEMACROWN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEMACROWN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. März 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr David John Cave als Direktor am 01. Okt. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Andrew Reason als Geschäftsführer am 30. Sept. 2022

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    8 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Alexander Green am 24. Sept. 2019

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2018 mit Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von David Stanley Parkes als Geschäftsführer am 30. Juni 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ann-Louise Holding als Geschäftsführer am 30. Juni 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Andrew Reason als Direktor am 30. Juni 2017

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Alexander Green als Direktor am 30. Juni 2017

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. März 2016

    Kapitalaufstellung am 16. März 2016

    • Kapital: GBP 44,341,187
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von LEMACROWN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Sekretär
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    British25179240002
    CAVE, David John
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish92438280003
    GREEN, David Alexander
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    United KingdomBritish170339810004
    BLACKWELL, Anne Christine
    18 Bettespol Meadows
    Redbourn
    AL3 7EW St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    18 Bettespol Meadows
    Redbourn
    AL3 7EW St Albans
    Hertfordshire
    British1216410001
    CHITTICK, Gavin William
    19 Kitson Road
    SW13 9HJ Barnes
    London
    Sekretär
    19 Kitson Road
    SW13 9HJ Barnes
    London
    British4524080002
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Sekretär
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    British10297860001
    LYNE, Sarah Jane
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    Sekretär
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    British49635520003
    ASPIN, David William
    Southover
    Spring Lane Burwash
    TN19 7JB Etchingham
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Southover
    Spring Lane Burwash
    TN19 7JB Etchingham
    East Sussex
    British41679550002
    BLACK, Terence Robert William
    4 Old Dock Close
    TW9 3BL Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Old Dock Close
    TW9 3BL Richmond
    Surrey
    British62461270001
    CARROLL, Stuart Paul
    Kings Farmhouse
    Binsted
    GU34 4PB Alton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Kings Farmhouse
    Binsted
    GU34 4PB Alton
    Hampshire
    British50363920002
    CHITTICK, Gavin William
    19 Kitson Road
    SW13 9HJ Barnes
    London
    Geschäftsführer
    19 Kitson Road
    SW13 9HJ Barnes
    London
    EnglandBritish4524080002
    DEIGMAN, Patrick
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish37099910001
    DEIGMAN, Patrick
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish37099910001
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10297860001
    HOLDING, Ann-Louise
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish73464490003
    MOULD, Harold Raymond
    Guiting Grange
    Guiting Power
    GL54 5UD Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Guiting Grange
    Guiting Power
    GL54 5UD Cheltenham
    Gloucestershire
    British35576350001
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish25179240002
    REASON, Mark Andrew
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish108053930002
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish73972350001
    WINSLOW, Timothy Simon
    The Dial House
    24 Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Dial House
    24 Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritish76547740001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LEMACROWN LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    Warwick House
    Hampshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    Warwick House
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer2863702
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat LEMACROWN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Letter of charge
    Erstellt am 28. Feb. 1995
    Geliefert am 03. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 13. Apr. 1993
    Geliefert am 14. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 14. Jan. 1993
    Geliefert am 26. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or port solent marina limited to the chargee under the terms of the debenture dated 18TH september 1992 and this charge
    Kurze Angaben
    Freehold land and buildings k/a gallowtree gate leicester. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Sept. 1992
    Geliefert am 01. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or port solent marina limited on any account whatsoever under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    See form 395 ref m*386C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 19. Juli 1991
    Geliefert am 26. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from and/or abacus developments limited. The company to the chargee. Under a debenture dated 11TH august 1988.
    Kurze Angaben
    1). f/h land and buildings k/a lawis' department store humberstone gate, leicester. T/n:- lt 21292. 2). land formerly k/a leicester (free lane) telephone exchange. Free lane, leicester t/n:- lt 187861 3). land and buildings k/a 39, humberstone gate, leicester. T/n:- lt 179674. 4). land and buildings k/a jubilee buildings. Charles street, leicester and all sums from time to time standing to the credit of the colleteral accounts. (See form 395-ref M78 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation.
    Transaktionen
    • 26. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Leter of charge
    Erstellt am 25. Juni 1991
    Geliefert am 03. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All monies due or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 21. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 28. Sept. 1990
    Geliefert am 04. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 11/8/88
    Kurze Angaben
    L/H land & buildings k/a 1-17 (odd no's only) charles street, leicester title no lt 32689.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 09. Nov. 1989
    Geliefert am 16. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 11/8/88
    Kurze Angaben
    F/H land & building k/a 21-35 (incl.) charles street, leicester title no lt 12855.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 12. Mai 1989
    Geliefert am 18. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or abacus developments limited to the chargee, secured by a debenture dated 11/8/88.
    Kurze Angaben
    F/H 47 & 49 belgrowe gate. Leicester (city of) and all buildings, fixtures & fittings, all other chattels, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 18. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 12. Aug. 1988
    Geliefert am 23. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from arlington property investments limited to the chargee for itself and as agent for the banks under the terms of a facility agreement dated 6/5/88 and the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the eastgate shopping centre and 22 southgate street, gloucester title no:- gr 55970 (see form 395 for full property details).
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel & Co. Limited
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 21. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Aug. 1988
    Geliefert am 15. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Benti Corporation
    Transaktionen
    • 15. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Mai 1988
    Geliefert am 25. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    1) all that cinema restaurant offices kiosk & premises situate and known as the arts cinema and no 8 market passage, cambridge 2) all that shop premises and yard adjoining the property first described. (See form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Warden and Fellows of Robinson College in the University of Cambridge.
    Transaktionen
    • 25. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    • 21. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 1987
    Geliefert am 19. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £500,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the cams hall estate, fareham, in the county of hampshire (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Lazard Brothers & Co. Limited.
    Transaktionen
    • 19. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    • 11. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Feb. 1986
    Geliefert am 03. März 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the enterprise developments (london) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All interest of whatever nature both present and future of the company in f/h property at 36, 37 and 38 whitefiars street london E.C.4.
    Berechtigte Personen
    • Postipankk (U.K) Limited.
    Transaktionen
    • 03. März 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 31. Jan. 1984
    Geliefert am 03. Feb. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from arlington securities limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H. units 3, 4, 5, and 6 church trading estate slade green erith title no. Sgl 283014.
    Berechtigte Personen
    • The Govemor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 16. Jan. 1984
    Geliefert am 31. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H. gowvings tower market street brocknell berkshire title no. Bk 205113.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 30. Dez. 1983
    Geliefert am 07. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 36, 37 & 38 whitefriars street, london EC4 title no. 85433. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Honry Ansbacher & Co Limited.
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Sub mortgage
    Erstellt am 29. Juli 1983
    Geliefert am 02. Aug. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 1 church trading estate, slade green road, london borough of bexley. (See doc M13 for further details).
    Berechtigte Personen
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1983Registrierung einer Belastung
    • 11. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Mai 1981
    Geliefert am 15. Mai 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or arlington securities limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H arlington trade estate slade green road, erith bexley title no. Sgl 283014.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1981Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 1980
    Geliefert am 12. Aug. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property:- land on the north side of salde green road erith kent title no. Sgl 283014 together with land and buildings erected thereon.
    Berechtigte Personen
    • Didamia Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1980Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 16. Mai 1980
    Geliefert am 16. Mai 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    201 slade green road erith kent.
    Berechtigte Personen
    • Ganeheath Securities Limited
    Transaktionen
    • 16. Mai 1980Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0