CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED

CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01471805
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    80 Cheapside
    EC2V 6EE London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HILLINGS INVESTMENTS LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980
    SLICKBOROUGH LIMITED08. Jan. 198008. Jan. 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Timothy Saunders als Geschäftsführer am 12. Aug. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 26. Mai 2016

    • Kapital: GBP 442
    SH01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse The White House 10 Clifton York YO30 6AE verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf The White House 10 Clifton York YO30 6AE geändert

    1 SeitenAD02

    Beendigung der Bestellung von Christopher Robin Leslie Phillips als Geschäftsführer am 14. März 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 18. Mai 2015

    • Kapital: GBP 442
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Robin Leslie Phillips am 16. Mai 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 21. Mai 2014

    • Kapital: GBP 442
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Christopher Paul Martin am 16. Mai 2014

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Sekretärs für Christopher Paul Martin am 16. Mai 2014

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , 305 Grays Inn Road, London, WC1X 8QR, United Kingdom am 16. Mai 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    7 SeitenAA

    Ernennung von Christopher Paul Martin als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MARTIN, Christopher Paul
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Sekretär
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    British178775380001
    COWANS, David
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    EnglandBritishCompany Director108543490005
    BUSTIN, Desmond John
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    Sekretär
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    British31260040002
    BUSTIN, Desmond John
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    Sekretär
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    British31260040002
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary157947720001
    SANDERS, Karen Lesley
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    Sekretär
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    British15772130001
    SAUNDERS, Timothy
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Sekretär
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    BritishCompany Director47952140001
    REID & CO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    41052090008
    ROXBURGH MILKINS LLP
    Merchants House North
    Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    Sekretär
    Merchants House North
    Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    114974370003
    BUSTIN, Desmond John
    Woodacre
    West Goheldon
    SP4 3OG Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Woodacre
    West Goheldon
    SP4 3OG Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector31260040001
    CHAMPION, Mark Alistair
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Geschäftsführer
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritishDirector76512840002
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Geschäftsführer
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritishDirector87647990001
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Geschäftsführer
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritishCompany Director87647990001
    HUNT, Alan Edward
    37 Main Road
    Drayton Parslow
    MK17 0JR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    37 Main Road
    Drayton Parslow
    MK17 0JR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector74704080001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    EnglandBritishChairman46176700002
    SAMBROOK, Christiane Marie
    134 Kensington Drive
    Great Holm
    MK8 9BN Milton Keynes
    Bucks
    Geschäftsführer
    134 Kensington Drive
    Great Holm
    MK8 9BN Milton Keynes
    Bucks
    Anglo-FrenchProperty Management36197920001
    SANDERS, Karen Lesley
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    Geschäftsführer
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    BritishDirector15772130001
    SAUNDERS, Timothy
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    EnglandBritishCompany Director47952140001
    SELL, Karen Elizabeth
    2 Osterley Close
    MK16 0EZ Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Osterley Close
    MK16 0EZ Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    BritishAccounts Manager36197970001
    STAPLEFORD MANAGEMENT LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    Geschäftsführer
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    48564730001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Touchstone Corporate Property Services Limited
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    06. Apr. 2016
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England & Wales
    Registrierungsnummer4695692
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 13. Feb. 2008
    Geliefert am 21. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nvm Private Equity Limited
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Juni 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 13. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transaktionen
    • 13. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Juni 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Juni 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of intellectual property rights
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 11. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company assigned to the bank all the company's right title and interest in and to the intellectual property rights throughout the world excluding the third party rights and all applications and all the company's rights title and interest in and to the applications. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 11. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H - castle estates dawson road mount farm milton keynes t/no BM245239. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 11. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 30. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Venture Managers Limited
    Transaktionen
    • 30. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Juni 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 18. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land on the south side of dawson road mount farm industrial estate central milton keynes t/n BM245239. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Aug. 2002
    Geliefert am 20. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 21. Mai 2002
    Geliefert am 31. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property 8 aymer house new church rd hove. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit account agreement
    Erstellt am 11. Juni 1999
    Geliefert am 17. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the agreement
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of the rent deposit account including all interest.
    Berechtigte Personen
    • Joy Frances Gooding
    Transaktionen
    • 17. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 15. Aug. 1996
    Geliefert am 27. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Juni 1993
    Geliefert am 14. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or castle estates (milton keynes) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 21. Dez. 1992
    Geliefert am 05. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The whole or any part of the rents or other money due from the company to the chargee under a lease dated 21/12/92
    Kurze Angaben
    A separate designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society opened or to be opened in the name of the chargee having an initial balance of £1,482.50 together with all sums subsequently paid into this said account.
    Berechtigte Personen
    • Manteca Limited
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of rental deposit
    Erstellt am 25. März 1992
    Geliefert am 08. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The obligations of the company to manteca limited under a lease dated 25/03/92 and this deed
    Kurze Angaben
    All the interest of the company in the amount from time to time standing to the credit of a designated interest lending account.
    Berechtigte Personen
    • Manteca Limited
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Aug. 1989
    Geliefert am 17. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 1981
    Geliefert am 04. Feb. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H premises situate at and known as number 30 bridge street olney. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1981Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0