CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01471805 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 80 Cheapside EC2V 6EE London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HILLINGS INVESTMENTS LIMITED | 31. Dez. 1980 | 31. Dez. 1980 |
SLICKBOROUGH LIMITED | 08. Jan. 1980 | 08. Jan. 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Saunders als Geschäftsführer am 12. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse The White House 10 Clifton York YO30 6AE verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf The White House 10 Clifton York YO30 6AE geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Robin Leslie Phillips als Geschäftsführer am 14. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Robin Leslie Phillips am 16. Mai 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Christopher Paul Martin am 16. Mai 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Christopher Paul Martin am 16. Mai 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , 305 Grays Inn Road, London, WC1X 8QR, United Kingdom am 16. Mai 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Christopher Paul Martin als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN, Christopher Paul | Sekretär | Cheapside EC2V 6EE London 80 | British | 178775380001 | ||||||
COWANS, David | Geschäftsführer | Cheapside EC2V 6EE London 80 | England | British | Company Director | 108543490005 | ||||
BUSTIN, Desmond John | Sekretär | Church Farm House Stapleford SP3 4LN Salisbury Wiltshire | British | 31260040002 | ||||||
BUSTIN, Desmond John | Sekretär | Church Farm House Stapleford SP3 4LN Salisbury Wiltshire | British | 31260040002 | ||||||
REID, Christopher | Sekretär | Whitecrest Narrow Path Aspley Heath MK17 8TF Woburn Sands Buckinghamshire | British | Company Secretary | 157947720001 | |||||
SANDERS, Karen Lesley | Sekretär | 28 High Street LU7 Stewkley Beds | British | 15772130001 | ||||||
SAUNDERS, Timothy | Sekretär | Beckets Place Marksbury BA2 9HP Bath Avon | British | Company Director | 47952140001 | |||||
REID & CO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Witan Court 305 Upper Fourth Street MK9 1EH Central Milton Keynes Buckinghamshire | 41052090008 | |||||||
ROXBURGH MILKINS LLP | Sekretär | Merchants House North Wapping Road BS1 4RW Bristol | 114974370003 | |||||||
BUSTIN, Desmond John | Geschäftsführer | Woodacre West Goheldon SP4 3OG Salisbury Wiltshire | British | Director | 31260040001 | |||||
CHAMPION, Mark Alistair | Geschäftsführer | Crescent Office Park Clarks Way BA2 2AF Bath 2 | England | British | Director | 76512840002 | ||||
HOLLINGWORTH, Neil Gregory | Geschäftsführer | Bridge House Addington MK18 2JX Winslow Bucks | United Kingdom | British | Director | 87647990001 | ||||
HOLLINGWORTH, Neil Gregory | Geschäftsführer | Bridge House Addington MK18 2JX Winslow Bucks | United Kingdom | British | Company Director | 87647990001 | ||||
HUNT, Alan Edward | Geschäftsführer | 37 Main Road Drayton Parslow MK17 0JR Milton Keynes Buckinghamshire | British | Director | 74704080001 | |||||
PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Geschäftsführer | Cheapside EC2V 6EE London 80 | England | British | Chairman | 46176700002 | ||||
SAMBROOK, Christiane Marie | Geschäftsführer | 134 Kensington Drive Great Holm MK8 9BN Milton Keynes Bucks | Anglo-French | Property Management | 36197920001 | |||||
SANDERS, Karen Lesley | Geschäftsführer | 28 High Street LU7 Stewkley Beds | British | Director | 15772130001 | |||||
SAUNDERS, Timothy | Geschäftsführer | Cheapside EC2V 6EE London 80 | England | British | Company Director | 47952140001 | ||||
SELL, Karen Elizabeth | Geschäftsführer | 2 Osterley Close MK16 0EZ Newport Pagnell Buckinghamshire | British | Accounts Manager | 36197970001 | |||||
STAPLEFORD MANAGEMENT LIMITED | Geschäftsführer | Witan Court 305 Upper Fourth Street Central Milton Keynes MK9 1EH Milton Keynes | 48564730001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touchstone Corporate Property Services Limited | 06. Apr. 2016 | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 13. Feb. 2008 Geliefert am 21. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 13. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of intellectual property rights | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company assigned to the bank all the company's right title and interest in and to the intellectual property rights throughout the world excluding the third party rights and all applications and all the company's rights title and interest in and to the applications. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H - castle estates dawson road mount farm milton keynes t/no BM245239. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 30. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 13. Sept. 2002 Geliefert am 18. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold land on the south side of dawson road mount farm industrial estate central milton keynes t/n BM245239. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Aug. 2002 Geliefert am 20. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 21. Mai 2002 Geliefert am 31. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property 8 aymer house new church rd hove. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit account agreement | Erstellt am 11. Juni 1999 Geliefert am 17. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the agreement | |
Kurze Angaben All monies standing to the credit of the rent deposit account including all interest. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture deed | Erstellt am 15. Aug. 1996 Geliefert am 27. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 24. Juni 1993 Geliefert am 14. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or castle estates (milton keynes) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 21. Dez. 1992 Geliefert am 05. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The whole or any part of the rents or other money due from the company to the chargee under a lease dated 21/12/92 | |
Kurze Angaben A separate designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society opened or to be opened in the name of the chargee having an initial balance of £1,482.50 together with all sums subsequently paid into this said account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of rental deposit | Erstellt am 25. März 1992 Geliefert am 08. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The obligations of the company to manteca limited under a lease dated 25/03/92 and this deed | |
Kurze Angaben All the interest of the company in the amount from time to time standing to the credit of a designated interest lending account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Aug. 1989 Geliefert am 17. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Feb. 1981 Geliefert am 04. Feb. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H premises situate at and known as number 30 bridge street olney. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0