W.P. MALLINSON LIMITED
Überblick
Unternehmensname | W.P. MALLINSON LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01472234 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von W.P. MALLINSON LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich W.P. MALLINSON LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von W.P. MALLINSON LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für W.P. MALLINSON LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Smerdon als Geschäftsführer am 01. Aug. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr William Shepherd als Direktor am 01. Aug. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Jennifer Anne Brierley am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c |
Wer sind die Geschäftsführer von W.P. MALLINSON LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIERLEY, Jennifer Anne | Sekretär | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
SHEPHERD, William | Geschäftsführer | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | Solicitor | 162873980001 | ||||
WILLETTS, Andrew John | Geschäftsführer | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | Chartered Accountant | 120451550002 | ||||
BUCKELL, Stephen William | Sekretär | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | Director Company Secretary | 20341960001 | |||||
DAVIES, John Richard Bridge | Sekretär | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
HEATON, Janet Ruth | Sekretär | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | Company Secretary | 81228260001 | |||||
MALLINSON, William Priestley | Sekretär | 1 Ladywell Close Hempsted GL2 6XE Gloucester Gloucestershire | British | 22481160001 | ||||||
NASH, Andrew | Sekretär | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||
SADLER, John Michael | Sekretär | 12 Cransley Grove B91 3ZA Solihull West Midland | British | 44018260001 | ||||||
SMERDON, Peter | Sekretär | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
BREITHAUPT, Michael David | Geschäftsführer | 15 Alexander Gardens Conygor Park GL8 8YZ Tetbury Gloucestershire | British | Pharmacist | 46663820001 | |||||
BUCKELL, Stephen William | Geschäftsführer | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | Director Company Secretary | 20341960001 | |||||
FELLOWS, Jonathan | Geschäftsführer | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Finance Director | 118296490001 | ||||
HARDY, Martyn James | Geschäftsführer | The Corner House Preston Bagott B95 5EH Henley-In-Arden Warwickshire | British | Retail Director | 74148120001 | |||||
HOOD, John | Geschäftsführer | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | Finance Director | 39644740002 | |||||
KERSHAW, Graham Anthony | Geschäftsführer | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | Director | 8991780003 | ||||
LLOYD, Allen John | Geschäftsführer | Yew House Freasley B78 2EY Tamworth Staffordshire | British | Chairman Pharmacist | 2270630001 | |||||
LLOYD, Peter Edward | Geschäftsführer | Southfield Coventry Road CV8 2FT Kenilworth Warwickshire | British | Chief Executive | 35546210001 | |||||
MALLINSON, Betty | Geschäftsführer | 1 Ladywell Close Hempsted GL2 6XE Gloucester Gloucestershire | British | Shorthand Typist | 22481170001 | |||||
MALLINSON, William Priestley | Geschäftsführer | 1 Ladywell Close Hempsted GL2 6XE Gloucester Gloucestershire | British | Pharmacist | 22481160001 | |||||
MEISTER, Stefan Mario | Geschäftsführer | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | Company Director | 43550520003 | |||||
MISCHKE, Gerhard Viktor | Geschäftsführer | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | Chief Finance Officer | 62107000001 | |||||
MOORE, Dean | Geschäftsführer | Bleak House Oaks Road LE67 5UP Whitwick Leicestershire | British | Chartered Accountant | 94541520001 | |||||
SANDERS, David | Geschäftsführer | 27 Cherington Road Nailsea BS19 2TW Bristol Avon | British | Pharmacist | 47247100001 | |||||
SMERDON, Peter | Geschäftsführer | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | Company Secretary | 16898700002 | ||||
TURNER, Richard Gill | Geschäftsführer | The Old Coach House Mill Lane Sheepy Parva CV9 3RL Atherstone Warwickshire | British | Commercial Director | 51796560002 | |||||
VIZARD, Ronald Charles, Harold | Geschäftsführer | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | Chartered Accountant | 122881190001 | |||||
WARD, Michael Ashley | Geschäftsführer | Flat 603 Shad Thames SE1 2YL London | England | British | Group Finance Director | 114711020001 |
Hat W.P. MALLINSON LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 29. Dez. 1989 Geliefert am 08. Jan. 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 5 brookfield rd hucclecote gloucestershire together with all buildings the mortgagor hereby further charges by way of legal mortgage all moveable plant machinery, utensils implements implements furniture & equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 1982 Geliefert am 31. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, 5 brookfield road, hucclecote, gloucester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Juni 1980 Geliefert am 24. Juni 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts & uncalled capital all fixtures & fittings & fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Apr. 1980 Geliefert am 16. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the property known as 5, brookfields rd hucclecote, glos. Fixed & floating charge on - undertaking and all property and assets present and future including goodwill, all buildings & fixtures uncalled capital, fixed plant and machinery, book debts stock in trade work in progress prepayments investments cash. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0