C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01473087 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 2 Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| C.L.C. GROUP LTD. | 20. Dez. 1984 | 20. Dez. 1984 |
| C.L.C. DECORATORS LIMITED | 15. Jan. 1980 | 15. Jan. 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 4 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 014730870014 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Benjamin Thomas Armitage am 22. März 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Jan. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 014730870013 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Simon Armitage als Geschäftsführer am 29. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Reeve als Direktor am 30. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Paul Carter als Geschäftsführer am 07. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Paul Carter als Direktor am 10. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Malcolm John White als Geschäftsführer am 04. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMITAGE, Peter Benjamin Thomas | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 72943340002 | |||||
| ARMITAGE, Philip Iain | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 85173470003 | |||||
| HILTON, Nicholas Andrew | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 97484770001 | |||||
| REEVE, Simon | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 219644110001 | |||||
| CHILDERSTONE-PARRETT, Joanne | Sekretär | Blackstone House Upper Crabbick Lane Denmead PO7 6HQ Waterlooville Hampshire | British | 23304780001 | ||||||
| EAVES, Terence Joseph | Sekretär | 86 Spencer Road PO33 3AH Ryde Isle Of Wight | British | 125796830001 | ||||||
| ILES, Mark Willmott | Sekretär | 209 Cutbush Lane Townhill Park SO18 2GF Southampton Hampshire | British | 23509110002 | ||||||
| WHITE, Malcolm John | Sekretär | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | British | 110398690001 | ||||||
| ADAMS, Christopher John | Geschäftsführer | Vincent Avenue Shirley SO16 6PQ Southampton Unit 2 Hampshire | United Kingdom | British | 26614280003 | |||||
| AINSLEY, Stanley | Geschäftsführer | The Stables Haven Hill The Yews Firbeck S81 8JW Worksop Nottinghamshire | British | 62660370001 | ||||||
| ARMITAGE, Richard Simon | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 146747640001 | |||||
| BOWERS, Anthony Charles | Geschäftsführer | 30 Firs Drive Hedge End SO30 4QL Southampton Hampshire | British | 7004850002 | ||||||
| BOWERS, Anthony Charles | Geschäftsführer | 30 Firs Drive Hedge End SO30 4QL Southampton Hampshire | British | 7004850002 | ||||||
| CARTER, Ian Paul | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 79314210003 | |||||
| CHILDERSTONE, William James | Geschäftsführer | 53 Brampton Towers SO16 7FB Southampton Hampshire | British | 42598030001 | ||||||
| CHILDERSTONE-PARRETT, Joanne | Geschäftsführer | Blackstone House Upper Crabbick Lane Denmead PO7 6HQ Waterlooville Hampshire | British | 23304780001 | ||||||
| EAVES, Terence Joseph | Geschäftsführer | 86 Spencer Road PO33 3AH Ryde Isle Of Wight | England | British | 125796830001 | |||||
| ILES, Mark Willmott | Geschäftsführer | 209 Cutbush Lane Townhill Park SO18 2GF Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 23509110002 | |||||
| TAYLOR, Frank | Geschäftsführer | 18 Brook Road WA13 9AH Lymm Cheshire | British | 23318590001 | ||||||
| TAYLOR, Marcus John | Geschäftsführer | 44 Bursledon Road Bitterne SO19 7NH Southampton Hampshire | England | British | 85173370001 | |||||
| WHITE, Malcolm John | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | United Kingdom | British | 110398690002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clc Group Limited | 06. Apr. 2016 | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat C.L.C. ADMINISTRATION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 29. Apr. 2015 Geliefert am 12. Mai 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung For more details of land, ship, aircraft or ip charged. Please refer to the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 29. Apr. 2015 Geliefert am 12. Mai 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Okt. 2009 Geliefert am 05. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Dez. 2004 Geliefert am 21. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Dez. 1994 Geliefert am 13. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 9 northbrook industrial estate southampton hampshire t/n-HP302718. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Dez. 1994 Geliefert am 11. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property k/a unit 9 north brook industrial estate southampton t/no HP302718 with all buildings fixed plant fixtures and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Aug. 1992 Geliefert am 18. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the comapny to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 212/214 manchester road, warrington, cheshire. T/n-CH296552. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juli 1992 Geliefert am 05. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (For full details of property charged see form 395 and contd sheets). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture. | Erstellt am 24. Sept. 1991 Geliefert am 15. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (See doc M395-ref m 795 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Nov. 1987 Geliefert am 04. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 1A and 2A northbrook industrial estate, southampton title no hb 263573. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Nov. 1987 Geliefert am 04. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 2 northbrook industrial estate, southampton title no hb-240698. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 12. März 1987 Geliefert am 25. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Juni 1983 Geliefert am 20. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or robin bright decorations limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Dez. 1980 Geliefert am 23. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0