BRANCHAND LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BRANCHAND LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01473669 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRANCHAND LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BRANCHAND LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 80 Station Parade Harrogate HG1 1HQ North Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRANCHAND LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRANCHAND LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für BRANCHAND LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Mai 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von BRANCHAND LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALVERT, Mark Richard, Mr. | Sekretär | High Bond End HG5 9BT Knaresborough Kirkman Bank North Yorkshire | British | 44425360003 | ||||||
CALVERT, Mark Richard, Mr. | Geschäftsführer | High Bond End HG5 9BT Knaresborough Kirkman Bank North Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 44425360003 | ||||
HARCOURT, Peter James Rolston | Geschäftsführer | The Garth North Rigton LS17 0DJ Leeds North Yorkshire | England | British | Director | 72476310002 | ||||
WHISKERD, David Austen | Geschäftsführer | 121 Moffats Lane AL9 7RP Hatfield Hertfordshire | England | British | Director | 103890940001 | ||||
CALVERT, Hazel Anne | Sekretär | Quantum 73 Sheering Road CM17 0JN Old Harlow Essex | British | Director | 86884430001 | |||||
CALVERT, Mark Richard | Sekretär | Foxwood House 64 Kent Road HG1 2NL Harrogate North Yorkshire | British | 44425360002 | ||||||
COOPER, Joan Kyle | Sekretär | Micawber House White Elm Road Woolpit IP30 9SQ Bury St Edmunds Suffolk | British | Company Secretary | 10015030001 | |||||
PERKINS, Marion Ann | Sekretär | 12 Ketts Close NR18 0NB Wymondham Norfolk | British | 17300520001 | ||||||
SZCZEPANSKI, Jan | Sekretär | 16 Durkar Rise Crigglestone WF4 3QB Wakefield West Yorkshire | British | Director | 10925740001 | |||||
WILTON, David Charles | Sekretär | 27 Kent Road HG1 2LJ Harrogate North Yorkshire | British | Director | 99414270001 | |||||
CALVERT, Hazel Anne | Geschäftsführer | Quantum 73 Sheering Road CM17 0JN Old Harlow Essex | British | Director | 86884430001 | |||||
COOPER, Joan Kyle | Geschäftsführer | Micawber House White Elm Road Woolpit IP30 9SQ Bury St Edmunds Suffolk | British | Company Secretary | 10015030001 | |||||
COOPER, Kenneth Owen | Geschäftsführer | Micawber House White Elm Road Woolpit IP30 9SQ Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | Managing Director | 10015040001 | ||||
PERKINS, Anton Spencer | Geschäftsführer | 12 Ketts Close NR18 0NB Wymondham Norfolk | British | Operations Manager | 48341970001 | |||||
PERKINS, Marion Ann | Geschäftsführer | 12 Ketts Close NR18 0NB Wymondham Norfolk | British | Administrative Controller | 17300520001 | |||||
PERKINS, Stuart Melvyn | Geschäftsführer | 12 Ketts Close NR18 0NB Wymondham Norfolk | British | Industrial Cleaner | 17300530001 | |||||
PIRRIE, Michael | Geschäftsführer | Bosmere Cottage Duke Street Haughley IP14 3QS Stowmarket Suffolk | England | British | Manager | 124359150001 | ||||
SZCZEPANSKI, Jan | Geschäftsführer | 16 Durkar Rise Crigglestone WF4 3QB Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 10925740001 | ||||
WILTON, David Charles | Geschäftsführer | 27 Kent Road HG1 2LJ Harrogate North Yorkshire | England | British | Director | 99414270001 |
Hat BRANCHAND LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 10. Jan. 2003 Geliefert am 21. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 10. Jan. 2003 Geliefert am 21. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture deed | Erstellt am 19. Aug. 1999 Geliefert am 28. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 24. Juni 1993 Geliefert am 29. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 6 ashwell thorpe industrial estate ashwell thorpe norwich norfolk. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 02. Juni 1983 Geliefert am 07. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0