YAXLEY SPP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | YAXLEY SPP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01473781 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von YAXLEY SPP LIMITED?
- Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich YAXLEY SPP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 66 Clifton Street EC2A 4HB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von YAXLEY SPP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ELECO (SPP) LIMITED | 04. Juni 2013 | 04. Juni 2013 |
| STRAMIT PANEL PRODUCTS LIMITED | 03. Apr. 2012 | 03. Apr. 2012 |
| ELECO TIMBER FRAME LIMITED | 25. Jan. 2007 | 25. Jan. 2007 |
| ELECO BUILDING COMPONENTS LIMITED | 08. Aug. 2006 | 08. Aug. 2006 |
| STRAMIT INDUSTRIES LIMITED | 21. Juli 1987 | 21. Juli 1987 |
| STRAMIT INDUSTRIES (UK) LIMITED | 31. Dez. 1980 | 31. Dez. 1980 |
| KILCOTE LIMITED | 17. Jan. 1980 | 17. Jan. 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YAXLEY SPP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für YAXLEY SPP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Auflösungsaufschub | 1 Seiten | L64.04 | ||||||||||||||
Beendigung der Liquidation | 1 Seiten | L64.07 | ||||||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 3 Seiten | COCOMP | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed eleco (spp) LIMITED\certificate issued on 07/03/14 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Turner als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed stramit panel products LIMITED\certificate issued on 04/06/13 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Geänderte vollständige Konten erstellt bis 31. Dez. 2011 | 13 Seiten | AAMD | ||||||||||||||
Ernennung von Ivor Ashley Barton als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ivor Barton als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ivor Barton als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed eleco timber frame LIMITED\certificate issued on 03/04/12 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Matthew Lloyd Turner als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Slater als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Fugaccia als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Ivor Ashley Barton als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Graham Neil Spratling als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2011 bis 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von YAXLEY SPP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTON, Ivor Ashley | Sekretär | Bluebell Close HP1 2DH Hemel Hempstead 5 Herts | British | 174082530001 | ||||||
| SPRATLING, Graham Neil | Geschäftsführer | The Mall Park Street AL2 2HT St Albans 3c Hertfordshire England | England | British | 153162830001 | |||||
| BARTON, Ivor Ashley | Sekretär | 5 Bluebell Close HP1 2DH Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 15818320006 | ||||||
| CRAVEN, Timothy Asgill | Sekretär | Moatfields Hoxne IP21 5AL Eye Suffolk | British | 20737780001 | ||||||
| GRAVETT, Philip James | Sekretär | Ellerslie Crawley End Chrishall SG8 8QJ Royston Hertfordshire | British | 36746090001 | ||||||
| HOLDCROFT, Laurence Nigel | Sekretär | 71 Fanshawe Crescent SG12 0AR Ware Hertfordshire | British | 58539950002 | ||||||
| HOPKINS, Nigel Antony | Sekretär | 9 Norton Leys Wavendon Gate MK7 7TA Milton Keynes Buckinghamshire | British | 75324110002 | ||||||
| TSAPPIS, Neil John Alfred | Sekretär | Burfield 85 Church Green Road Bletchley MK3 6DA Milton Keynes | British | 49019640001 | ||||||
| AMOS, Robert | Geschäftsführer | Thirsville The Street IP21 5DX Horham Suffolk | British | 20737790001 | ||||||
| BARTON, Ivor Ashley | Geschäftsführer | Bluebell Close HP1 2DH Hemel Hempstead 5 Herts England | England | British | 15818320006 | |||||
| BROWN, Jack Henry | Geschäftsführer | 14 Bellrope Lane NR18 0QY Wymondham Norfolk | British | 31834290002 | ||||||
| CALLAGHAN, Peter William | Geschäftsführer | Emerys Bucks Lane Little Eversden CB3 7HL Cambridge Cambridgeshire | England | British | 8093260001 | |||||
| CRAMPHORN, Terence Henry | Geschäftsführer | White Oaks Moor Hall Lane Danbury CM3 4ER Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 47883780001 | |||||
| CRAVEN, Timothy Asgill | Geschäftsführer | Moatfields Hoxne IP21 5AL Eye Suffolk | British | 20737780001 | ||||||
| DANNHAUSER, David Stephen | Geschäftsführer | 8 Marsworth Avenue HA5 4UB Pinner Middlesex | England | British | 55176170003 | |||||
| FUGACCIA, Paul David | Geschäftsführer | 5 Churchfields WA8 9RP Widnes Cheshire | England | British | 123876350001 | |||||
| HADDON, Anthony | Geschäftsführer | Forest House Thornton Lane LE67 9RP Markfield Leicestershire | British | 72194430001 | ||||||
| HAYWOOD, Mark Royston | Geschäftsführer | 8 Abinger Way Eaton NR4 6NA Norwich Norfolk | England | British | 68960560002 | |||||
| HIGGINS, Geoffrey John | Geschäftsführer | Greentyles Common Road Bressingham IP22 2BB Diss Norfolk | British | 27573580001 | ||||||
| HOLMES, Granville | Geschäftsführer | 46 Fraser Close NN11 5HD Daventry Northamptonshire | British | 20737800001 | ||||||
| HOUSEMAN, Christopher | Geschäftsführer | 5 Reeves Pightle Great Chishill SG8 8SL Royston Hertfordshire | British | 70735110001 | ||||||
| KETTELEY, John Henry Beevor | Geschäftsführer | Keeway Ferry Road, Creeksea CM0 8PL Burnham On Crouch Essex | United Kingdom | British | 3514610001 | |||||
| LOWE, David Howard | Geschäftsführer | Willowdale The Street Redgrave IP22 1RY Diss Norfolk | England | British | 40112290001 | |||||
| NEWBY, Frederick Edward | Geschäftsführer | Farthingham Lane Ocklet Road Ewhurst GU6 7QN Cranleigh Hartley Surrey | United Kingdom | British | 28923840001 | |||||
| PETERS, Christopher John | Geschäftsführer | The Manor House Manor Road Roydon IP22 3QS Diss Norfolk | British | 40040990002 | ||||||
| SHACKELL, Martin Edward | Geschäftsführer | 9 Gilbey Close NN9 5YG Wellingborough Northamptonshire | British | 51840120001 | ||||||
| SLATER, Richard Craig Alan | Geschäftsführer | Stannage Lane Churton CH3 6LE Chester Westleigh | United Kingdom | British | 37111560008 | |||||
| TAYLOR, Paul James | Geschäftsführer | 40 Azalea Close LE17 4FR Lutterworth Leicestershire | England | British | 69909170003 | |||||
| TURNER, Matthew Lloyd | Geschäftsführer | Clifton Street EC2A 4HB London 66 England | England | British | 158037130001 | |||||
| WEBSTER, Michael John | Geschäftsführer | Coles Park House Cole Park Westmill SG9 9LT Buntingford Hertfordshire | British | 21651670001 | ||||||
| WHITE, David John | Geschäftsführer | 14 Lovat Close IP20 9HJ Harlestone Norfolk | British | 85510430001 | ||||||
| WOOLLEY, Eric Ryhs | Geschäftsführer | 17 Heron Close CM21 0BB Sawbridgeworth Hertfordshire | British | 22806550001 |
Hat YAXLEY SPP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 12TH september 2007 and | Erstellt am 05. Jan. 2009 Geliefert am 14. Jan. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus letter of set-off | Erstellt am 12. Sept. 2007 Geliefert am 14. Sept. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off dated 4 march 1999 and | Erstellt am 05. Dez. 2003 Geliefert am 09. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 26. Mai 1999 Geliefert am 02. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Eye airfield eye suffolk.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture deed | Erstellt am 05. März 1999 Geliefert am 26. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 04. März 1999 Geliefert am 08. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 26. Juni 1997 Geliefert am 27. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 used no.2 Speedeck machine plus tooling serial no; 10006 and any part thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge supplemental to a debenture dated 10/2/93 issued by the company | Erstellt am 21. Nov. 1996 Geliefert am 04. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture | |
Kurze Angaben All rights title and interest in or arising out of a factoring or invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 11/9/96; all book/other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Sept. 1996 Geliefert am 14. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1993 Geliefert am 09. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at yaxley,eye,suffolk. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Feb. 1993 Geliefert am 22. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 M290C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 14. März 1986 Geliefert am 01. Apr. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Please see doc M22 for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. März 1983 Geliefert am 09. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the security documents d/d 13/10/80 | |
Kurze Angaben Legal mortgage:- f/h land and comprising for parcels of land froming part of 0563 part 0564 part 0568 yaxley and part 05781 part 05782 note county of suffolk together with the buildings erected thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Okt. 1981 Geliefert am 20. Okt. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H yaxley, eye, suffolk. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Okt. 1980 Geliefert am 16. Okt. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 57 burkitt road, corby, northants. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat YAXLEY SPP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0