YAXLEY SPP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameYAXLEY SPP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01473781
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von YAXLEY SPP LIMITED?

    • Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe
    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich YAXLEY SPP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    66 Clifton Street
    EC2A 4HB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von YAXLEY SPP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ELECO (SPP) LIMITED04. Juni 201304. Juni 2013
    STRAMIT PANEL PRODUCTS LIMITED03. Apr. 201203. Apr. 2012
    ELECO TIMBER FRAME LIMITED25. Jan. 200725. Jan. 2007
    ELECO BUILDING COMPONENTS LIMITED08. Aug. 200608. Aug. 2006
    STRAMIT INDUSTRIES LIMITED21. Juli 198721. Juli 1987
    STRAMIT INDUSTRIES (UK) LIMITED 31. Dez. 198031. Dez. 1980
    KILCOTE LIMITED17. Jan. 198017. Jan. 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YAXLEY SPP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für YAXLEY SPP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Auflösungsaufschub

    1 SeitenL64.04

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed eleco (spp) LIMITED\certificate issued on 07/03/14
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name07. März 2014

    Beschluss zur Änderung der Firma am 06. März 2014

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 16. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 170,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Matthew Turner als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    12 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed stramit panel products LIMITED\certificate issued on 04/06/13
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name04. Juni 2013

    Beschluss zur Änderung der Firma am 31. Mai 2013

    RES15
    change-of-name04. Juni 2013

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Geänderte vollständige Konten erstellt bis 31. Dez. 2011

    13 SeitenAAMD

    Ernennung von Ivor Ashley Barton als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Ivor Barton als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ivor Barton als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed eleco timber frame LIMITED\certificate issued on 03/04/12
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name03. Apr. 2012

    Beschluss zur Änderung der Firma am 03. Apr. 2012

    RES15
    change-of-name03. Apr. 2012

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Ernennung von Matthew Lloyd Turner als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Richard Slater als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Fugaccia als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Ivor Ashley Barton als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Graham Neil Spratling als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    12 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2011 bis 31. Dez. 2011

    1 SeitenAA01

    Wer sind die Geschäftsführer von YAXLEY SPP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARTON, Ivor Ashley
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    Sekretär
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    British174082530001
    SPRATLING, Graham Neil
    The Mall
    Park Street
    AL2 2HT St Albans
    3c
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    The Mall
    Park Street
    AL2 2HT St Albans
    3c
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish153162830001
    BARTON, Ivor Ashley
    5 Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    5 Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British15818320006
    CRAVEN, Timothy Asgill
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    Sekretär
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    British20737780001
    GRAVETT, Philip James
    Ellerslie Crawley End
    Chrishall
    SG8 8QJ Royston
    Hertfordshire
    Sekretär
    Ellerslie Crawley End
    Chrishall
    SG8 8QJ Royston
    Hertfordshire
    British36746090001
    HOLDCROFT, Laurence Nigel
    71 Fanshawe Crescent
    SG12 0AR Ware
    Hertfordshire
    Sekretär
    71 Fanshawe Crescent
    SG12 0AR Ware
    Hertfordshire
    British58539950002
    HOPKINS, Nigel Antony
    9 Norton Leys
    Wavendon Gate
    MK7 7TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    9 Norton Leys
    Wavendon Gate
    MK7 7TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British75324110002
    TSAPPIS, Neil John Alfred
    Burfield 85 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DA Milton Keynes
    Sekretär
    Burfield 85 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DA Milton Keynes
    British49019640001
    AMOS, Robert
    Thirsville
    The Street
    IP21 5DX Horham
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Thirsville
    The Street
    IP21 5DX Horham
    Suffolk
    British20737790001
    BARTON, Ivor Ashley
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    England
    Geschäftsführer
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    England
    EnglandBritish15818320006
    BROWN, Jack Henry
    14 Bellrope Lane
    NR18 0QY Wymondham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    14 Bellrope Lane
    NR18 0QY Wymondham
    Norfolk
    British31834290002
    CALLAGHAN, Peter William
    Emerys Bucks Lane
    Little Eversden
    CB3 7HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Emerys Bucks Lane
    Little Eversden
    CB3 7HL Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish8093260001
    CRAMPHORN, Terence Henry
    White Oaks Moor Hall Lane
    Danbury
    CM3 4ER Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    White Oaks Moor Hall Lane
    Danbury
    CM3 4ER Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish47883780001
    CRAVEN, Timothy Asgill
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    British20737780001
    DANNHAUSER, David Stephen
    8 Marsworth Avenue
    HA5 4UB Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    8 Marsworth Avenue
    HA5 4UB Pinner
    Middlesex
    EnglandBritish55176170003
    FUGACCIA, Paul David
    5 Churchfields
    WA8 9RP Widnes
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Churchfields
    WA8 9RP Widnes
    Cheshire
    EnglandBritish123876350001
    HADDON, Anthony
    Forest House
    Thornton Lane
    LE67 9RP Markfield
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Forest House
    Thornton Lane
    LE67 9RP Markfield
    Leicestershire
    British72194430001
    HAYWOOD, Mark Royston
    8 Abinger Way
    Eaton
    NR4 6NA Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    8 Abinger Way
    Eaton
    NR4 6NA Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish68960560002
    HIGGINS, Geoffrey John
    Greentyles Common Road
    Bressingham
    IP22 2BB Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Greentyles Common Road
    Bressingham
    IP22 2BB Diss
    Norfolk
    British27573580001
    HOLMES, Granville
    46 Fraser Close
    NN11 5HD Daventry
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    46 Fraser Close
    NN11 5HD Daventry
    Northamptonshire
    British20737800001
    HOUSEMAN, Christopher
    5 Reeves Pightle
    Great Chishill
    SG8 8SL Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Reeves Pightle
    Great Chishill
    SG8 8SL Royston
    Hertfordshire
    British70735110001
    KETTELEY, John Henry Beevor
    Keeway
    Ferry Road, Creeksea
    CM0 8PL Burnham On Crouch
    Essex
    Geschäftsführer
    Keeway
    Ferry Road, Creeksea
    CM0 8PL Burnham On Crouch
    Essex
    United KingdomBritish3514610001
    LOWE, David Howard
    Willowdale The Street
    Redgrave
    IP22 1RY Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Willowdale The Street
    Redgrave
    IP22 1RY Diss
    Norfolk
    EnglandBritish40112290001
    NEWBY, Frederick Edward
    Farthingham Lane Ocklet Road
    Ewhurst
    GU6 7QN Cranleigh
    Hartley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Farthingham Lane Ocklet Road
    Ewhurst
    GU6 7QN Cranleigh
    Hartley
    Surrey
    United KingdomBritish28923840001
    PETERS, Christopher John
    The Manor House Manor Road
    Roydon
    IP22 3QS Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Manor House Manor Road
    Roydon
    IP22 3QS Diss
    Norfolk
    British40040990002
    SHACKELL, Martin Edward
    9 Gilbey Close
    NN9 5YG Wellingborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    9 Gilbey Close
    NN9 5YG Wellingborough
    Northamptonshire
    British51840120001
    SLATER, Richard Craig Alan
    Stannage Lane
    Churton
    CH3 6LE Chester
    Westleigh
    Geschäftsführer
    Stannage Lane
    Churton
    CH3 6LE Chester
    Westleigh
    United KingdomBritish37111560008
    TAYLOR, Paul James
    40 Azalea Close
    LE17 4FR Lutterworth
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    40 Azalea Close
    LE17 4FR Lutterworth
    Leicestershire
    EnglandBritish69909170003
    TURNER, Matthew Lloyd
    Clifton Street
    EC2A 4HB London
    66
    England
    Geschäftsführer
    Clifton Street
    EC2A 4HB London
    66
    England
    EnglandBritish158037130001
    WEBSTER, Michael John
    Coles Park House
    Cole Park Westmill
    SG9 9LT Buntingford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Coles Park House
    Cole Park Westmill
    SG9 9LT Buntingford
    Hertfordshire
    British21651670001
    WHITE, David John
    14 Lovat Close
    IP20 9HJ Harlestone
    Norfolk
    Geschäftsführer
    14 Lovat Close
    IP20 9HJ Harlestone
    Norfolk
    British85510430001
    WOOLLEY, Eric Ryhs
    17 Heron Close
    CM21 0BB Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    17 Heron Close
    CM21 0BB Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British22806550001

    Hat YAXLEY SPP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 12TH september 2007 and
    Erstellt am 05. Jan. 2009
    Geliefert am 14. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    An omnibus letter of set-off
    Erstellt am 12. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off dated 4 march 1999 and
    Erstellt am 05. Dez. 2003
    Geliefert am 09. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 26. Mai 1999
    Geliefert am 02. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Eye airfield eye suffolk.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture deed
    Erstellt am 05. März 1999
    Geliefert am 26. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 26. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 04. März 1999
    Geliefert am 08. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 26. Juni 1997
    Geliefert am 27. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 used no.2 Speedeck machine plus tooling serial no; 10006 and any part thereof.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Group Limited
    Transaktionen
    • 27. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 10/2/93 issued by the company
    Erstellt am 21. Nov. 1996
    Geliefert am 04. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in or arising out of a factoring or invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 11/9/96; all book/other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Sept. 1996
    Geliefert am 14. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transaktionen
    • 14. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 1993
    Geliefert am 09. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at yaxley,eye,suffolk.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Feb. 1993
    Geliefert am 22. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 M290C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 14. März 1986
    Geliefert am 01. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Please see doc M22 for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Australia and New Zealand Banking Group LTD
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 04. März 1983
    Geliefert am 09. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the security documents d/d 13/10/80
    Kurze Angaben
    Legal mortgage:- f/h land and comprising for parcels of land froming part of 0563 part 0564 part 0568 yaxley and part 05781 part 05782 note county of suffolk together with the buildings erected thereon.
    Berechtigte Personen
    • I.C.F.C. LTD
    Transaktionen
    • 09. März 1983Registrierung einer Belastung
    • 07. Feb. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 1981
    Geliefert am 20. Okt. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H yaxley, eye, suffolk.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1981Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 13. Okt. 1980
    Geliefert am 16. Okt. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    57 burkitt road, corby, northants. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Icfc LTD
    Transaktionen
    • 16. Okt. 1980Registrierung einer Belastung
    • 07. Feb. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat YAXLEY SPP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Nov. 2015Abschluss der Liquidation
    17. Apr. 2014Antragsdatum
    23. Sept. 2020Aufgelöst am
    09. Juni 2014Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praktiker
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0