NETWORK DISTRIBUTING LIMITED
Überblick
Unternehmensname | NETWORK DISTRIBUTING LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01476436 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?
- Nicht spezialisierter Großhandel (46900) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 31st Floor 40 Bank Street E14 5NR London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SOUND AND MEDIA LIMITED | 17. Aug. 1994 | 17. Aug. 1994 |
SOUND SOLUTIONS LIMITED | 28. Jan. 1992 | 28. Jan. 1992 |
MAINLINE RECTRACK LIMITED | 14. Feb. 1986 | 14. Feb. 1986 |
MAINLINE RECORD COMPANY LIMITED | 02. Aug. 1985 | 02. Aug. 1985 |
MAINLINE RECORD CO. LIMITED | 31. Jan. 1980 | 31. Jan. 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2023 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2023 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Juni 2023 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 15. Juni 2023 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Juni 2022 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Juni 2025 | 29 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Juni 2024 | 31 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 014764360009 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 014764360010 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 20 Berghem Mews Blythe Road London W14 0HN England zum 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR am 16. Juni 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 12 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2022 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Juan Veloza Vargas als Direktor am 25. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tim Alan Beddows als Geschäftsführer am 19. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2021 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Anthony James Lack als Direktor am 23. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 014764360010, erstellt am 02. Nov. 2021 | 24 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2020 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 014764360009, erstellt am 13. März 2020 | 55 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2019 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Tim Alan Beddows am 30. Juni 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LACK, Jonathan Anthony James | Geschäftsführer | 40 Bank Street E14 5NR London 31st Floor | United Kingdom | British | Director | 142626960003 | ||||
VELOZA VARGAS, Juan | Geschäftsführer | 40 Bank Street E14 5NR London 31st Floor | United Kingdom | British,Colombian | Director | 305274590001 | ||||
BAYLISS, Joshua | Sekretär | 15 Hopefield Avenue NW6 6LJ London | British | 114409340001 | ||||||
COLLINS, Peter Alan | Sekretär | Hightrees 8 Lakeside Drive KT10 9EZ Esher Surrey | British | Record Dealer | 29565390004 | |||||
GERRARD, Barry Alexander Ralph | Sekretär | 50 Brook Green Hammersmith W6 7RR London The School House United Kingdom | British | 188290005 | ||||||
GRAM, Peter Gerardus | Sekretär | 9 Lambyn Croft Langshott RH6 9XU Horley Surrey | British | 67245530001 | ||||||
LEGGE, Diana Patricia | Sekretär | 24a Enderby Street SE10 9PF London | British | 66675910001 | ||||||
ABBOTT, Trevor Michael | Geschäftsführer | Blendons Highcotts Lane West Clandon GU4 7XA Guildford Surrey | British | Company Director | 35278820001 | |||||
BEDDOWS, Tim Alan | Geschäftsführer | Berghem Mews Blythe Road W14 0HN London Unit 20 England | England | British | Producer | 97663340001 | ||||
COLLINS, Peter Alan | Geschäftsführer | 24 The Riverside Graburn Way Hampton Court KT8 9BF East Molesey Surrey | United Kingdom | British | Director | 29565390006 | ||||
DE ANTONI, Claudia | Geschäftsführer | 179 Harrow Road W2 6NB London The Battleship Building United Kingdom | United Kingdom | Italian | Finance Professional | 173947040001 | ||||
DEUGO, Hans De | Geschäftsführer | Tonannes Kortland 2a FOREIGN Lopik 3412-Kw Holland | Dutch | Salesman | 29565400001 | |||||
EMBLEY, Deborah Jayne | Geschäftsführer | Flat 1 64 Cromwell Avenue Highgate N6 5HQ London | England | British | Chartered Accountant | 75933680001 | ||||
FOYN, Philip Dennis | Geschäftsführer | Croydon Road CR3 6QD Caterham 98 Surrey United Kingdom | British | Finance Director | 133880950001 | |||||
GILBRIDE, Michael Bernard Jonathan | Geschäftsführer | 18 Broughton Road Ealing W13 8QW London | United Kingdom | British | Company Director | 32396280002 | ||||
HALL, Susannah Mary Louise | Geschäftsführer | 76 Sutton Court Chiswick W4 3JF London | British | Director Of Financial Control | 75930520004 | |||||
HINDLE, Alun Timothy | Geschäftsführer | Dulwich Village SE21 7BU London 9 England United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Manager | 122149060002 | ||||
JACKSON, John Ellis | Geschäftsführer | Avalon 26 Abbey Gardens Upper Woolhampton RG7 5TZ Reading Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 2219540003 | ||||
LEE, Andrew Shore | Geschäftsführer | Elmwood Avenue PO22 8DE Bognor Regis 21 West Sussex | United Kingdom | British | Accountant | 131320710001 | ||||
MAZOTTI, Gary Wheatley | Geschäftsführer | 96 Cleveland Gardens SW13 0AH London | British | Financial Director | 67852160002 | |||||
MITTRICH, Wilhelm | Geschäftsführer | Dorfstrasse 6 Stohl D 2301 Germany | German | Director | 44229430001 | |||||
MOUGIN, Mathilde Louise Marie | Geschäftsführer | 50 Brook Green W6 7RR London The School House United Kingdom | United Kingdom | French | Corporate Finance Analyst | 151182340001 | ||||
MURPHY, Stephen Thomas Matthew | Geschäftsführer | 23 The Crescent SW13 0NN London | British | Company Director | 70496800002 | |||||
RODIE, Kirsten Jane | Geschäftsführer | 50 Brook Green Hammersmith W6 7RR London The School House United Kingdom | United Kingdom | Australian | Investment Analyst | 146547110001 | ||||
ROHNER, Werner | Geschäftsführer | Klusenstrasse 28 Adligensnil Ch 6043 Switzerland | Swiss | Director | 33567260001 | |||||
STENT, Carla Rosaline | Geschäftsführer | 50 Brook Green W6 7RR London The School House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 152825570001 | ||||
WORSFOLD, Philip John Curtis | Geschäftsführer | 8 Essenden Road Sanderstead CR2 0BU Croydon Surrey | England | British | Director | 93496440001 | ||||
WORSFOLD, Robert William Curtis | Geschäftsführer | Copperfield 2 Monahan Avenue CR8 3BA Purley Surrey | United Kingdom | British | Operations Director | 114584490001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Tim Alan Beddows | 06. Apr. 2016 | 40 Bank Street E14 5NR London 31st Floor | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat NETWORK DISTRIBUTING LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 02. Nov. 2021 Geliefert am 03. Nov. 2021 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung I) all freehold and leasehold land and buildings of the company both present and future including any land and buildings specified in section 3 of the schedule and all trade fixtures and fittings and all plant and machinery from time to time in or on any such land or buildings; and. Ii) all intellectual property now owned or at any time hereafter to be owned by the company.". Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 13. März 2020 Geliefert am 30. März 2020 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17 feb 1998 and | Erstellt am 01. Sept. 2008 Geliefert am 11. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 17 february 1998 | Erstellt am 30. Sept. 2002 Geliefert am 16. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 10. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re sound and media limited and numbered 1420211 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 28. Sept. 1994 Geliefert am 05. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge supplemental to a debenture dated 19TH june 1987 issued by the company | Erstellt am 12. Nov. 1991 Geliefert am 29. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a receivables financing agreement dated 10TH july 1986 between h & h factors limited and the company. See form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Juni 1987 Geliefert am 26. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 10. Juli 1986 Geliefert am 12. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether under a factoring agreement or leasing agreement on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The ultimate balance due or owing to the company by h & h under any present or future factoring agreement (for full details see doc M23). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Okt. 1984 Geliefert am 08. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat NETWORK DISTRIBUTING LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0