PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01478556 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?
- Behandlung und Beschichtung von Metallen (25610) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Pipeline Centre Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 02. Apr. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 16. Apr. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 02. Apr. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 29 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Mauro Piasere als Direktor am 11. Aug. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Frederic Castrec als Geschäftsführer am 14. Aug. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Bjarne Christopher Petersen Sanne als Direktor am 20. Mai 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 27 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Duncan Holland als Sekretär am 31. Juli 2024 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Philip Nicholas Lanigan als Sekretär am 31. Juli 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mr Duncan Holland als Direktor am 31. Juli 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Philip Nicholas Lanigan als Geschäftsführer am 31. Juli 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 27 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Pih Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Beendigung der Bestellung von Adam Rhys Wynne Hughes als Geschäftsführer am 16. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Bruno Claudio Oliveira Teixeira als Geschäftsführer am 23. Mai 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 32 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift The Pipeline Centre Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate Burnley Lancashire BB11 5SW verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||
Ernennung von Mr James Innes Mackay als Direktor am 19. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Frederic Castrec als Direktor am 19. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Eintragung der Belastung 014785560004, erstellt am 19. Aug. 2022 | 8 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 014785560005, erstellt am 19. Aug. 2022 | 12 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 014785560006, erstellt am 19. Aug. 2022 | 79 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 014785560007, erstellt am 19. Aug. 2022 | 69 Seiten | MR01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLAND, Duncan | Sekretär | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | 325688150001 | |||||||
| HOLLAND, Duncan | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | Scotland | British | 325676520001 | |||||
| MACKAY, James Innes | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | Scotland | British | 108844510001 | |||||
| MCSHANE, Paul Joseph | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | England | Irish | 218498550002 | |||||
| PIASERE, Mauro | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | Italy | Italian | 339904950001 | |||||
| SANNE, Bjarne Christopher Petersen | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | Norway | Norwegian | 336626390001 | |||||
| COSTELLO, Steven John | Sekretär | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | 186116910001 | |||||||
| HAYHURST, Fred | Sekretär | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | 160014070001 | |||||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Sekretär | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | 299618700001 | |||||||
| ROBINSON, Paul James | Sekretär | 17 Moss Lane M33 6QD Sale Cheshire | British | 61464420001 | ||||||
| ALLEN, Caroline | Geschäftsführer | Rosendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Farrington Road England England | United Kingdom | British | 241814400001 | |||||
| BOND, Philip Michael | Geschäftsführer | 5 Brinklow Way HG2 9JW Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 70384280002 | |||||
| BOND, Philip Michael | Geschäftsführer | Stonebridge 8 Raines Road Giggleswick BD24 0AQ Settle North Yorkshire | British | 70384280001 | ||||||
| BURKE, James Richard | Geschäftsführer | 74 Sugarberry Circle Houston FOREIGN Texas 77024 Usa | Usa | Us Citizen | 179305440001 | |||||
| CAREY, Malcolm Timothy | Geschäftsführer | Indian Wells Drive 77069 Houston 14111 Texas United States | Usa | American | 135768760001 | |||||
| CAREY, Malcolm Timothy | Geschäftsführer | Indian Wells Drive 77069 Houston 14111 Texas United States | Usa | American | 135768760001 | |||||
| CASTREC, Frederic | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | France | French | 299627840001 | |||||
| COGZELL, Matthew James | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | England | British | 157755080001 | |||||
| COWLEY, John Mitchell | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | England | British | 153045530001 | |||||
| DAVISON, Thomas Patrick | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | England | British | 178471340001 | |||||
| EVANS, Calvin Paul | Geschäftsführer | 6622 Preston Trail Houston Texas 77069 Usa | Usa | American | 26160230004 | |||||
| EVANS, Calvin Paul | Geschäftsführer | 5634 South Delaware Tulsa Oklahoma 74105 Usa | American | 26160230002 | ||||||
| FRANCIS, Norman R | Geschäftsführer | 132 Waterford Way 77356 Montgomery Texas Usa | American | 47018220001 | ||||||
| GARDNER, Philip D | Geschäftsführer | 608 West 17th Street 77008 Houston Texas Usa | American | 53177340001 | ||||||
| GOFF, Brian Charles | Geschäftsführer | 3 Albany Drive Copster Green Salesbury BB1 9EH Blackburn Lancashire | British | 15440280002 | ||||||
| JUMPSEN, David Thomas | Geschäftsführer | 66 North Park SL9 8JR Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 13115920001 | |||||
| LAAKE, Gregory Duane | Geschäftsführer | 9410 Brentwood Lake Circle Spring Texas 77379 Usa | United States | United States | 104309910001 | |||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | England | British | 42734310002 | |||||
| MOKLAK, Paul Daniel | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | United Kingdom | British | 217770510001 | |||||
| NORRIS, Windell Derwood | Geschäftsführer | 806 West Forest Houston Texas 77079 Usa | American | 26160240001 | ||||||
| RAMSDEN, Albert | Geschäftsführer | The Old Rectory Grafton Flyford Upton Snodsbury WR7 4PG Worcester Hereford & Worcester | British | 15765370001 | ||||||
| RHODES, Fiona Elizabeth | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | United Kingdom | British | 200869110001 | |||||
| SMILEY, Mark Richard | Geschäftsführer | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | England | British | 194271890001 | |||||
| SMITH, Michael Peter | Geschäftsführer | Closes Hall Stump Cross Lane, Bolton By Bowland BB7 4LX Clitheroe Lancashire | British | 65426730001 | ||||||
| SOOD, Amit Kumar | Geschäftsführer | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre Lancashire | England | British | 153181250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P I H Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Rosendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Farrington Road England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0