PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED

PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01478556
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?

    • Behandlung und Beschichtung von Metallen (25610) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Pipeline Centre Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis02. Apr. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung16. Apr. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis02. Apr. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024

    29 SeitenAA

    Ernennung von Mr Mauro Piasere als Direktor am 11. Aug. 2025

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Frederic Castrec als Geschäftsführer am 14. Aug. 2025

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Bjarne Christopher Petersen Sanne als Direktor am 20. Mai 2025

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    27 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Duncan Holland als Sekretär am 31. Juli 2024

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Philip Nicholas Lanigan als Sekretär am 31. Juli 2024

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Duncan Holland als Direktor am 31. Juli 2024

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Philip Nicholas Lanigan als Geschäftsführer am 31. Juli 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    27 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. März 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Pih Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC05

    Beendigung der Bestellung von Adam Rhys Wynne Hughes als Geschäftsführer am 16. Juni 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Bruno Claudio Oliveira Teixeira als Geschäftsführer am 23. Mai 2023

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    32 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. März 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift The Pipeline Centre Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate Burnley Lancashire BB11 5SW verlegt

    1 SeitenAD04

    Ernennung von Mr James Innes Mackay als Direktor am 19. Aug. 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Frederic Castrec als Direktor am 19. Aug. 2022

    2 SeitenAP01

    Eintragung der Belastung 014785560004, erstellt am 19. Aug. 2022

    8 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 014785560005, erstellt am 19. Aug. 2022

    12 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 014785560006, erstellt am 19. Aug. 2022

    79 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 014785560007, erstellt am 19. Aug. 2022

    69 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOLLAND, Duncan
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Sekretär
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    325688150001
    HOLLAND, Duncan
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    ScotlandBritish325676520001
    MACKAY, James Innes
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    ScotlandBritish108844510001
    MCSHANE, Paul Joseph
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    EnglandIrish218498550002
    PIASERE, Mauro
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    ItalyItalian339904950001
    SANNE, Bjarne Christopher Petersen
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    NorwayNorwegian336626390001
    COSTELLO, Steven John
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    186116910001
    HAYHURST, Fred
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Sekretär
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    160014070001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Sekretär
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    299618700001
    ROBINSON, Paul James
    17 Moss Lane
    M33 6QD Sale
    Cheshire
    Sekretär
    17 Moss Lane
    M33 6QD Sale
    Cheshire
    British61464420001
    ALLEN, Caroline
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    Geschäftsführer
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    United KingdomBritish241814400001
    BOND, Philip Michael
    5 Brinklow Way
    HG2 9JW Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Brinklow Way
    HG2 9JW Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish70384280002
    BOND, Philip Michael
    Stonebridge 8 Raines Road
    Giggleswick
    BD24 0AQ Settle
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Stonebridge 8 Raines Road
    Giggleswick
    BD24 0AQ Settle
    North Yorkshire
    British70384280001
    BURKE, James Richard
    74 Sugarberry Circle
    Houston
    FOREIGN Texas 77024
    Usa
    Geschäftsführer
    74 Sugarberry Circle
    Houston
    FOREIGN Texas 77024
    Usa
    UsaUs Citizen179305440001
    CAREY, Malcolm Timothy
    Indian Wells Drive
    77069 Houston
    14111
    Texas
    United States
    Geschäftsführer
    Indian Wells Drive
    77069 Houston
    14111
    Texas
    United States
    UsaAmerican135768760001
    CAREY, Malcolm Timothy
    Indian Wells Drive
    77069 Houston
    14111
    Texas
    United States
    Geschäftsführer
    Indian Wells Drive
    77069 Houston
    14111
    Texas
    United States
    UsaAmerican135768760001
    CASTREC, Frederic
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    FranceFrench299627840001
    COGZELL, Matthew James
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    EnglandBritish157755080001
    COWLEY, John Mitchell
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    EnglandBritish153045530001
    DAVISON, Thomas Patrick
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    EnglandBritish178471340001
    EVANS, Calvin Paul
    6622 Preston Trail
    Houston
    Texas 77069
    Usa
    Geschäftsführer
    6622 Preston Trail
    Houston
    Texas 77069
    Usa
    UsaAmerican26160230004
    EVANS, Calvin Paul
    5634 South Delaware
    Tulsa
    Oklahoma 74105
    Usa
    Geschäftsführer
    5634 South Delaware
    Tulsa
    Oklahoma 74105
    Usa
    American26160230002
    FRANCIS, Norman R
    132 Waterford Way
    77356 Montgomery
    Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    132 Waterford Way
    77356 Montgomery
    Texas
    Usa
    American47018220001
    GARDNER, Philip D
    608 West 17th Street
    77008 Houston
    Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    608 West 17th Street
    77008 Houston
    Texas
    Usa
    American53177340001
    GOFF, Brian Charles
    3 Albany Drive Copster Green
    Salesbury
    BB1 9EH Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    3 Albany Drive Copster Green
    Salesbury
    BB1 9EH Blackburn
    Lancashire
    British15440280002
    JUMPSEN, David Thomas
    66 North Park
    SL9 8JR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    66 North Park
    SL9 8JR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish13115920001
    LAAKE, Gregory Duane
    9410 Brentwood Lake Circle
    Spring
    Texas 77379
    Usa
    Geschäftsführer
    9410 Brentwood Lake Circle
    Spring
    Texas 77379
    Usa
    United StatesUnited States104309910001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    EnglandBritish42734310002
    MOKLAK, Paul Daniel
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    United KingdomBritish217770510001
    NORRIS, Windell Derwood
    806 West Forest
    Houston
    Texas 77079
    Usa
    Geschäftsführer
    806 West Forest
    Houston
    Texas 77079
    Usa
    American26160240001
    RAMSDEN, Albert
    The Old Rectory Grafton Flyford
    Upton Snodsbury
    WR7 4PG Worcester
    Hereford & Worcester
    Geschäftsführer
    The Old Rectory Grafton Flyford
    Upton Snodsbury
    WR7 4PG Worcester
    Hereford & Worcester
    British15765370001
    RHODES, Fiona Elizabeth
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    United KingdomBritish200869110001
    SMILEY, Mark Richard
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    Geschäftsführer
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    EnglandBritish194271890001
    SMITH, Michael Peter
    Closes Hall
    Stump Cross Lane, Bolton By Bowland
    BB7 4LX Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Closes Hall
    Stump Cross Lane, Bolton By Bowland
    BB7 4LX Clitheroe
    Lancashire
    British65426730001
    SOOD, Amit Kumar
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    Lancashire
    EnglandBritish153181250001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PIPELINE INDUCTION HEAT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    06. Apr. 2016
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    Nein
    RechtsformLimited Liability Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03335609
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0