CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED

CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01483729
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VENTURE PRODUCTION (DMF) LIMITED01. Dez. 200601. Dez. 2006
    CH4 DMF LIMITED28. Mai 200428. Mai 2004
    ENI DMF LIMITED10. Apr. 200310. Apr. 2003
    LASMO (DMF) LIMITED23. Apr. 199623. Apr. 1996
    DNO OFFSHORE LIMITED10. Okt. 199010. Okt. 1990
    PEKO OIL NORTH SEA PLC04. Jan. 198804. Jan. 1988
    NORTH SEA & GENERAL OIL OPERATIONS PLC22. Jan. 198522. Jan. 1985
    DAWSEA PUBLIC LIMITED COMPANY07. März 198007. März 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Ernennung von Mr Andrew William Hodges als Direktor am 30. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nicola Margaret Carroll als Geschäftsführer am 30. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Apr. 2016

    LRESSP

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 13. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 0.40
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 22. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 6,440,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Nicola Margaret Carroll am 09. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 25. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 6,440,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 06. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 6,440,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Ernennung von Centrica Directors Limited als Direktor

    2 SeitenAP02

    Beendigung der Bestellung von Iain Bartholomew als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Hedley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Roger als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul De Leeuw als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Nicola Margaret Carroll als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Sekretär
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4049225
    146095800001
    HODGES, Andrew William
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary77527910004
    CENTRICA DIRECTORS LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3844287
    146695600001
    FAGAN, Daragh Patrick Feltrim
    17 Grena Road
    TW9 1XU Richmond
    Surrey
    Sekretär
    17 Grena Road
    TW9 1XU Richmond
    Surrey
    British56339340002
    HOBDEN, Brian
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    Sekretär
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    British81368370001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Sekretär
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    BritishDirector84103730001
    O'BRIEN, Alan
    21 Wethered Park
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    Sekretär
    21 Wethered Park
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    British62561440003
    WAITE, Simon Nicholas
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    Sekretär
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    British117008750002
    WALTERS, Sandra Gail
    9 Danvers Way
    CR3 5FJ Caterham
    Surrey
    Sekretär
    9 Danvers Way
    CR3 5FJ Caterham
    Surrey
    British64042250001
    WEDGWOOD, John Arthur Thomas
    32 Chantry Close
    CM23 2SN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    32 Chantry Close
    CM23 2SN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary3889150001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Sekretär
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    BARTHOLOMEW, Iain Douglas, Dr
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeologist, Subsurface Director192817250001
    BEGBIE, Roderick Mcintosh
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishOil Company Manager115205850001
    BIRD, Christopher Terence
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishTechnical Director187786850001
    CARROLL, Nicola
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary278861170001
    CLAYTON, Marie-Louise
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    Geschäftsführer
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    BritishFinance Director103782580001
    DAHLEN, John Magne
    Lillehagveien 116
    1310 Blommenholm
    Norway
    Geschäftsführer
    Lillehagveien 116
    1310 Blommenholm
    Norway
    NorwegianCompany Director71692830001
    DE LEEUW, Paul
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector Of Strategy160088460001
    FERRARA, Gianluigi
    33 Binghill Road
    AB13 0JA Milltimber
    Aberdeen
    Scotland
    Geschäftsführer
    33 Binghill Road
    AB13 0JA Milltimber
    Aberdeen
    Scotland
    ItalianCompany Director71548250001
    FRANKE, John Adrian
    6 Queensdale Place
    W11 4SQ London
    Geschäftsführer
    6 Queensdale Place
    W11 4SQ London
    United KingdomBritishCompany Director56128230002
    GIULIANELLI, Matilde
    2 Queensgate
    AB15 5XZ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    2 Queensgate
    AB15 5XZ Aberdeen
    Aberdeenshire
    ItalianFinance And Control Manager91951810001
    HAGEN, Torstein Olav
    2 Clockhouse Close
    Wimbledon
    SW19 5NT London
    Geschäftsführer
    2 Clockhouse Close
    Wimbledon
    SW19 5NT London
    NorwegianDirector53769600001
    HANAFIN, Vincent Mark
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritishChairman131999620002
    HANSLIEN, Sigmund
    Lindeveien 10
    FOREIGN 4025 Stavanger
    Norway
    Geschäftsführer
    Lindeveien 10
    FOREIGN 4025 Stavanger
    Norway
    NorwegianExploration Manager17533110001
    HARVEY, Russell Seth
    Hunters Croft
    Grayswood
    GU27 Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hunters Croft
    Grayswood
    GU27 Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritishOil Company Manager23757260001
    HEDLEY, Paul Ian, Mr.
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director241775400001
    HOGAN, John Anthony
    The Malthouse Heaverham Road
    Kemsing
    TN15 6NE Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    The Malthouse Heaverham Road
    Kemsing
    TN15 6NE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishGeologist94257040001
    HVIDE, Anders
    Bygody Alle 69
    0265 Oslo
    Norway
    Geschäftsführer
    Bygody Alle 69
    0265 Oslo
    Norway
    NorwegianCompany Director41786270001
    KING, Paul Anthony
    7 Queen Of Denmark Court
    Finland Street
    SE16 1TB London
    Geschäftsführer
    7 Queen Of Denmark Court
    Finland Street
    SE16 1TB London
    BritishOil Executive59371760001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    BritishDirector84103730001
    LORATO, Roberto
    56 Gladstone Place
    Queens Cross
    AB10 6XA Aberdeen
    Grampian
    Geschäftsführer
    56 Gladstone Place
    Queens Cross
    AB10 6XA Aberdeen
    Grampian
    BritishManaging Director Agip Uk73764210001
    LOUGH, Keith Geddes
    77 Mortlake Road
    TW9 4AA Kew
    Surrey
    Geschäftsführer
    77 Mortlake Road
    TW9 4AA Kew
    Surrey
    BritishOil Executive72453930001
    MADDOCK, Nicholas William
    62 Huntly Street
    AB10 1RS Aberdeen
    Kings Close
    Scotland
    Scotland
    Geschäftsführer
    62 Huntly Street
    AB10 1RS Aberdeen
    Kings Close
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishDirector138900170003
    MCALLISTER, Mark
    131 Parkside Drive
    WD17 3BA Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    131 Parkside Drive
    WD17 3BA Watford
    Hertfordshire
    BritishOil Executive67898480001
    MCKENNA, Gregory Craig
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCommercial Director184342170001

    Hat CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over accounts
    Erstellt am 15. Jan. 2007
    Geliefert am 30. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right title benefit and interest in and to the charged accounts and the balances from time to time standing to the credit of the charged accounts and the debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 15. Jan. 2007
    Geliefert am 30. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged property being all field interests of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juli 2006
    Geliefert am 28. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's rights to and title and interest from time to time in the relevant project accounts, all account proceeds, by way of first floating charge all the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property, assets, rights and revenues. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 28. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third supplemental deed of amendment to a note purchase agreement dated 23 december 2003 and
    Erstellt am 27. Jan. 2006
    Geliefert am 09. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    If any borrower or the issuer makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of all or any part of the junior liabilities or the subordianted liabilies or the junior lender or any subordianted lender recieves all or any amount in cash, the junior lender will hold any amount so received on trust for the collateral agent,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First supplemental deed of amendment to a guarantee and debenture dated 23 december 2003 and
    Erstellt am 27. Jan. 2006
    Geliefert am 09. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or CH4 energy limited to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An accession deed to intercreditor deed dated 23 december 2003
    Erstellt am 19. Mai 2004
    Geliefert am 03. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rights and remedies of the junior lender and the subordinated lenders in respect of the junior liabilities and the subordinated liabilities, respectively, and the junior security are subordinated to the rights and remedies of the senior finance parties in respect of the senior liabilities and the senior security. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag
    Transaktionen
    • 03. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed
    Erstellt am 19. Mai 2004
    Geliefert am 03. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent or any charging company to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag
    Transaktionen
    • 03. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge
    Erstellt am 20. Mai 1993
    Geliefert am 07. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the loan agreement the other security documents (or any of them) and this charge
    Kurze Angaben
    The markham field percentage interest,the assets,the receivables,the original rights.
    Berechtigte Personen
    • Christiania Bank Og Kreditkasse
    Transaktionen
    • 07. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Scottish assignation
    Erstellt am 22. Apr. 1993
    Geliefert am 10. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or by virtue of the loan agreement dated 31/07/92 or any security document (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title and interest under or by virtue of the licence to or in the facilities relating to the claymore field (please refer to form 395 M91 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Christiana Bank Og Kreditkasse
    Transaktionen
    • 10. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 12. Feb. 1993
    Geliefert am 26. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement dated 31/7/92 or any security document (as defined therein)
    Kurze Angaben
    (A) all rights claims assets benefits and interests of the company (I) under or by virtue of the licences (ii) to or in the facilities relating to the fields (iii) under or by virtue of the mua, block 49/5A joa claymore joa (the "joas") (iv) under or by virtue of the claymore transportation agreements (v) under or by virtue of the other project documents (vi) to or in the insurances and any amount received by the company under the insurances (vii) all monies standing to the credit of the compensation accounts and the proceeds accounts (viii) under or by virtue of all guarantees indemnities and securities etc. in connection with any of the documents listed above, either of the fields or the project and (ix) under or by virtue of any and all other agreements permits leases and consents etc. (for full details see ch microfiche).
    Berechtigte Personen
    • Christiania Bank Og Kreditkasse
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 31. Juli 1992
    Geliefert am 04. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 310792 (as defined)
    Kurze Angaben
    All property present and future by way of first floating charge but excluding the assets outlined on form 395.
    Berechtigte Personen
    • Christiania Bank Og Kreditkasse
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account agreement
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 15. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Certain obligations and liabilities in relation to the costs of carrying out operations in connection with the abandonment of the emerald field in favour of emerald field contracting limited.
    Kurze Angaben
    The two accounts designated "emerald field participants abandonment account and related assets (see form M395 ref M366 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Emerald Field Contracting Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 24. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account agreement
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 15. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The participants' (efpa) liabilities owed by the company to the section 10 creditor to the project lenders
    Kurze Angaben
    Peko's earnings account and its related assets. (See form M395 reg m 364 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 24. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 15. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the banks (as defined) and the law debenture trust corporation P.L.C (the trustee) under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    Under charge (a): all rights & benefits of peko under an agreement ("the neole by agreement") dated 30/9/87 (b) its trust assets after deduction of the first amount (please see continuation sheets on form 395 for full details.).
    Berechtigte Personen
    • The Banks (As Defined) and the Law Debenture Trust Corporation P.L.C.(the Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 29. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Scottish assignation in security
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 15. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to barclays bank PLC (as section 10 creditors agent as defined) under the terms of the emerald field participants agreements and this debenture
    Kurze Angaben
    Peko's whole right, title, interest & benefit in and to:- (I) the relevant agreements; (ii) the participants claims and (iii) (same to the extent falling within (I) or (ii) above any and all other contracts (including without limitation, leasingagreements) permits, licences, franchises, consents, easements, dervitudes, wayleaves and other rights now or hereafter existing. (See form 395 continuation sheet for full details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 10. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 15. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to barclays bank PLC (as section 10 creditor's agent - as defined) under the terms of the emerald field participants' agreements and this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed charges:- the charged assets (with the exception of peko's petroleum and peko's petroleum insurance proceeds). Floating charges:- the charged assets (including without limitation, peko's petroleum). Assignment by way of security:- peko's insurance proceeds (see continuation sheets of form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 24. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental scottish assignation intimated as stated in a certificate of intimation dated 11/11/86
    Erstellt am 02. Juli 1986
    Geliefert am 27. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or north sea & general oil investments PLC to the chargee under any of the financing documents
    Kurze Angaben
    The whole right title and interest of the company in and to the comprehensive utilisation agreement (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 24. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Scottish assignation intimated as stated in the certificate of intimation dated 8.10.86
    Erstellt am 02. Juli 1986
    Geliefert am 17. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreements dated 26 july 1984 and all or any other amounts owing or to become owing by the company or north sea & general oil investment pc
    Kurze Angaben
    The whole rights, title and interest of the company in and to the restated claymore joa. (See m 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 24. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental scottish assignation intimation as stated in the certificate of intimation dated 8.10.86
    Erstellt am 02. Juli 1986
    Geliefert am 17. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 26.7.84 and all or any other accounts owing or to become owing by the company or north sea & general oil investments PLC to the bank under any of the financing documents.
    Kurze Angaben
    The whole right title and interest of the company in and to the comprehensive unitsation agreement (see M395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 26. Aug. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Scottish assignation
    Erstellt am 02. Juli 1986
    Geliefert am 07. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company or north sea & general oil investments PLC to the chargee under the terms of the agreements and any of the financing documents.
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest of the company is and to the restated claymore joa (see doc M62).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    Supplemental scottish assignation
    Erstellt am 02. Juli 1986
    Geliefert am 07. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company or north sea & general oil investments PLC to the chargee under the terms of the agreement and any of the financing documents.
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest of the company is and to the comprehensive unitisation agreement. (See doc M61).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    Assignation dated 3/10/84 intimated as stated in the certificate of intimation data 17/10/86
    Erstellt am 03. Okt. 1984
    Geliefert am 24. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from north sea & general oil investments PLC under an agreement dated 26/7/84 and all monies due or to become due from the company and/or north sea & general oil investments PLC to the chargee under any of the financing documents as defined in the agreements.
    Kurze Angaben
    The whole right title and interest of the company in and to the licences (see form 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 24. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Scottish assignation intimated as stated in the certificate d/d 15/11/84
    Erstellt am 03. Okt. 1984
    Geliefert am 04. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 26/7/84 and all or any other amounts owing or to become owing by the company or north sea & general oil investments PLC to the bank under any of the fiancing documents.
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest of the company in and to the licences, the licence assignments and the principal operating agreements. (See doc M60 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    • 26. Aug. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 03. Okt. 1984
    Geliefert am 23. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 26/7/84.
    Kurze Angaben
    The whole right title & interest of the company in and to licences the licence agreements and the principal operating agrements. (See doc M58 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 1984Registrierung einer Belastung
    Assignation
    Erstellt am 03. Okt. 1984
    Geliefert am 23. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 26.7.84
    Kurze Angaben
    The whole right,title and interest of the company in and to licences and licence assignments and principal operating agreements. See doc 58.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 1984Registrierung einer Belastung
    • 26. Aug. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CENTRICA PRODUCTION (DMF) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Apr. 2016Beginn der Liquidation
    02. Feb. 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0