TIPHOOK FINANCIAL SERVICES

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTIPHOOK FINANCIAL SERVICES
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 01484609
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ANGLECROWN LIMITED12. März 198012. März 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Zweite Einreichung für die Ernennung von Neil Smith zum Geschäftsführer

    6 SeitenRP04AP01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT zum 1 More London Place London SE1 2AF am 25. Apr. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. März 2016

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beendigung der Bestellung von T I P Europe Limited als Geschäftsführer am 05. Feb. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Cakebread als Geschäftsführer am 01. Feb. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Neil Campbell Smith als Direktor am 05. Feb. 2016

    3 SeitenAP01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    06. Okt. 2016Clarification A second filed AP01 was registered on 06/10/2016

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014

    15 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 03. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 159,373,100
    SH01

    Rücktritt des Auditors

    3 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    3 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 15. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 6,463,100
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Ernennung von Joseph Preston Swithenbank als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Paul Beadle als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von David Cakebread als Direktor

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Webber House 26-28 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF United Kingdom* am 27. Nov. 2013

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer7038430
    146358090001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director183029170001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    Geschäftsführer
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    FranceUs CitizenFinance/Controllership183236480001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Sekretär
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Sekretär
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    SMITH, Nicholas Handran
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Sekretär
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Australian50914130001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Sekretär
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritishEuropean Operations Director100238650001
    BRAIDWOOD, Rodger Gordon
    Abbotsleigh Rosecroft Park
    Farnham Lane
    TN3 0DZ Langton Green
    Kent
    Geschäftsführer
    Abbotsleigh Rosecroft Park
    Farnham Lane
    TN3 0DZ Langton Green
    Kent
    EnglandBritishCompany Director1484600001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone183172770001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Geschäftsführer
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    BritishFinance Director53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Geschäftsführer
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    BritishSolicitor91783950001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Geschäftsführer
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    BritishTax Adviser65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    BritishDirector3485960001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Geschäftsführer
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritishSecretary/Solicitor61314280001
    GOODWIN, Eric
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    Geschäftsführer
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    EnglandBritishCompany Director45623310001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant109591300001
    MCENROE, Malachy
    1325
    Ln Almere
    Jean Gabinplatsoen 8
    Netherlands
    Geschäftsführer
    1325
    Ln Almere
    Jean Gabinplatsoen 8
    Netherlands
    IrishController139465450001
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    BritishCompany Director65130630002
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director4764800001
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director4764800001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    Geschäftsführer
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    BritishAccountant50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    DutchDirector57483360001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Geschäftsführer
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    DutchDirector54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    BritishAccountant75179060001
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    Hat TIPHOOK FINANCIAL SERVICES Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 1996
    Geliefert am 30. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The payment obligations due from the company to the chargees pursuant to the terms of the credit agreement and the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined
    Transaktionen
    • 30. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Proceeds account charge
    Erstellt am 26. Juli 1996
    Geliefert am 30. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to, all or any of: (a) the credit agreement; and (b) the company's guarantee and the account charge (the "secured obligations")
    Kurze Angaben
    The company, with full title guarantee assigned and agreed to assign absolutely to the agent all the company's right title benefit and interest in and to the charged account including without limitation the balances standing to the credit of the charged account from time to time and at any time as a continuing security in favour of the agent for the discharge on demand of the secured obligations.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 21. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined therein) or the banks (as defined in the credit agreement dated 13TH february 1994) on any account whatsoever under the terms of the said credit agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 21. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Proceeds account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 21. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) under the terms of the credit agreement dated 13TH february 1994, a guarantee of even date, this charge and any contract, agreement or other document (all as therein defined)
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest in and to the company's account numbered 76649229 held with the bank including the balances standing to the credit thereof.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 19. Okt. 1989
    Geliefert am 01. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due the company to commonwealth bank of australia under a loan agreement of even dated and under the terms of the mortgage.
    Kurze Angaben
    Containing and fixed or specific security:- 707 (seven hundred and seven) 40FT dry van containers having te serial number 460706 - 460712, 465913 - 466112, and 462313 - 463312 includsive. (See form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Commonwealth Bank of Australia
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    04
    Erstellt am 19. Mai 1989
    Geliefert am 06. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of a facility letter dated 27.2.89.
    Kurze Angaben
    All the company's interest in the containers (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • International Westminster Bank PLC
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1989
    Geliefert am 02. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of a ficility letter dated 27 february 1989
    Kurze Angaben
    2999 dry van containers (see form 395 for further details).
    Berechtigte Personen
    • International Westminster Bank PLC
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 13. März 1989
    Geliefert am 29. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights title and interests present and future in the containers listed on form 395 see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Nederlandsche Middenstands Bank Nv
    Transaktionen
    • 29. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 06. März 1989
    Geliefert am 10. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 16/9/88.
    Kurze Angaben
    All freight containers as described in the schedule attached to the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Copenhagen Handelsbank a/S
    Transaktionen
    • 10. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 10. Feb. 1989
    Geliefert am 13. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase contract taking offect from 31/3/88 as amended by a novation agreement dated 10/2/89
    Kurze Angaben
    The company's right, title interest & benefit in and to a sub-hire agreement relating to the trailers dated 31/3/88 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Citibank, Na.
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 10. Feb. 1989
    Geliefert am 13. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase contract taking effect from 31/1/89 as amended by a novation agreement dated 10/2/89
    Kurze Angaben
    The company's right, title interest & benefit in and to a sub-hire agreement relating to the containers dated 31/3/88 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Citibank, N. A.
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master thire purchase agreement
    Erstellt am 29. Nov. 1988
    Geliefert am 14. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The equipment (as the same in more particularly identified in the hiring schedule (s) to be delivered by the hirer to the bank pursuant to the master hp agreement) (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • State Bank of New South Wales
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 17. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 28. Sept. 1988
    Geliefert am 11. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility agreement dated 20/7/88 and under the terms of the chattel mortgage
    Kurze Angaben
    The goods or chattels specified in the schedule attached to form 395 all documents relating to the chattels. The benefit of all contracts & agreements (including all conditions and warranties) (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage and charge
    Erstellt am 03. Juni 1988
    Geliefert am 15. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 31/3/88 and/or the security documents as defined and under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    1972 dry van containers (see from 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Fennoscandia Bank Limited
    Transaktionen
    • 15. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurance
    Erstellt am 24. Mai 1988
    Geliefert am 06. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to novatin agreements dated 31-3-88.
    Kurze Angaben
    All of the insurance policies whatsoever in respect of certain equipment (as defined in the first novation agreement and the second novation agreement) ad all benefits thereof including all claims of whatsoever nature and returns of premises.
    Berechtigte Personen
    • Lefax a/S.
    Transaktionen
    • 06. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 18. Mai 1988
    Geliefert am 25. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,999,627.91
    Kurze Angaben
    (1) 224 40' x 8'6" dry van containers supplied by evergreen heavy industrial corporation. Serial nos: tphu 440921 - tphu 441144 inclusive (2) 400 40' x 8' x 8'6" dry van containers supplied by hyumdai corporation serial nos: tphu 443221 - tphu 443620 inclusive.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 25. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. März 1988
    Geliefert am 19. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 13/12/85 as amended by a novation and sale agreement dated 31/3/88 and the legal mortgage.
    Kurze Angaben
    Charge by way of assignment 330 twenty foot dry freight containers ("the equipment") together with all rental and other earnings derived from the utilisation thereof.
    Berechtigte Personen
    • Commonwealth Bank of Australia
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. März 1988
    Geliefert am 19. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under ther terms of a loan agreement dated 18/11/87 as a mended by a novation and sale agreement dated 31/3/88 and the legal mortgage
    Kurze Angaben
    Charge by way of assignment 224, forty foot dry van containers and 724 twenty foot dry van containers ("the equipment") together with all rental and other earnings derived from the utilisation thereof.
    Berechtigte Personen
    • Commonwealth Bank of Australia
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. März 1988
    Geliefert am 19. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 22 january 1978 as amended by a novation and sale agreement dated 31 march 1988 and the legal mortgage
    Kurze Angaben
    Charge by way of assignment 1,550 forty foot dry van containers and 340 twenty foot dry freight containers (the equipment) together with all rental and other earnings derived from teh utilisation thereof.
    Berechtigte Personen
    • Commonwealth Bank of Australian
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. März 1988
    Geliefert am 19. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 29/10/85 as amended by a novation and sale agreement dated 31/3/88 and the legal mortgage
    Kurze Angaben
    Charge by way of assignment 2,000 twenty foot dry freight containers together with all rental and other earnings derived from the utilisation thereof.
    Berechtigte Personen
    • Commonwealth Bank of Australia
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 31. März 1988
    Geliefert am 08. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 29/11/84 and a novation and sale agreement dated 31/3/88 and under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    All freight containers "(the equipment)" as described in the schedule attached to form 395 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Copenhagen Handels Bank a/S
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 31. März 1988
    Geliefert am 08. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 10/2/88 and a novation and sale agreement dated 31/3/88 and under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    All freight containers "(the equipment)" as described in the schedule attached to form 395 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Copenhagen Handels Bank a/S
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TIPHOOK FINANCIAL SERVICES Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. März 2016Beginn der Liquidation
    16. Apr. 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0