TIPHOOK FINANCIAL SERVICES
Überblick
Unternehmensname | TIPHOOK FINANCIAL SERVICES |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
Unternehmensnummer | 01484609 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ANGLECROWN LIMITED | 12. März 1980 | 12. März 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Zweite Einreichung für die Ernennung von Neil Smith zum Geschäftsführer | 6 Seiten | RP04AP01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT zum 1 More London Place London SE1 2AF am 25. Apr. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von T I P Europe Limited als Geschäftsführer am 05. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Cakebread als Geschäftsführer am 01. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Neil Campbell Smith als Direktor am 05. Feb. 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 3 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 3 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Joseph Preston Swithenbank als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Beadle als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von David Cakebread als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Webber House 26-28 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF United Kingdom* am 27. Nov. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TIPHOOK FINANCIAL SERVICES?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
SMITH, Neil Campbell | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road Hammersmith W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 183029170001 | ||||||||
SWITHENBANK, Joseph Preston | Geschäftsführer | Rue Pillet Will 75009 Paris 2-4 France | France | Us Citizen | Finance/Controllership | 183236480001 | ||||||||
ENOCH, Simon Jocelyn | Sekretär | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | British | 61314280001 | ||||||||||
PRICE, Philip Ian | Sekretär | 4 Queenswood Avenue Hutton CM13 1HR Brentwood Essex | British | 75578650002 | ||||||||||
SMITH, Nicholas Handran | Sekretär | Flat 2 19 Netherhall Gardens NW3 5RL Hampstead London | Australian | 50914130001 | ||||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||||||
TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED | Sekretär | Trafalgar House 29 Park Place LS1 2SP Leeds West Yorkshire | 50087010001 | |||||||||||
BEADLE, Paul Laurence | Geschäftsführer | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire | United Kingdom | British | European Operations Director | 100238650001 | ||||||||
BRAIDWOOD, Rodger Gordon | Geschäftsführer | Abbotsleigh Rosecroft Park Farnham Lane TN3 0DZ Langton Green Kent | England | British | Company Director | 1484600001 | ||||||||
CAKEBREAD, David | Geschäftsführer | The Quadrant Aztec West BS32 4GQ Bristol 2630 United Kingdom | United Kingdom | British | None | 183172770001 | ||||||||
CHANDLER, Andrew Philip | Geschäftsführer | 66 Baywell Leybourne ME19 5QQ West Malling Kent | British | Finance Director | 53832740001 | |||||||||
CITRON, Zachary Joseph | Geschäftsführer | 23 Holders Hill Crescent NW14 1NE London | British | Solicitor | 91783950001 | |||||||||
CLARK, Roy Graham | Geschäftsführer | 18 Rosary Gardens SW7 4NT London | British | Tax Adviser | 65257100001 | |||||||||
CLUBB, Ian Mcmaster | Geschäftsführer | Pond House EN5 4PS Hadley Green Hertfordshire | British | Director | 3485960001 | |||||||||
ENOCH, Simon Jocelyn | Geschäftsführer | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | England | British | Secretary/Solicitor | 61314280001 | ||||||||
GOODWIN, Eric | Geschäftsführer | Brewers Wood Pondfield Lane Shorne DA12 3LD Gravesend Kent | England | British | Company Director | 45623310001 | ||||||||
GREEN, Pamela Anne | Geschäftsführer | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
HOWELL, David | Geschäftsführer | Flat 10 The Isabella Hatchford Park Ockham Lane KT11 1LR Cobham Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 109591300001 | ||||||||
MCENROE, Malachy | Geschäftsführer | 1325 Ln Almere Jean Gabinplatsoen 8 Netherlands | Irish | Controller | 139465450001 | |||||||||
MONTAGUE, Robert Joel | Geschäftsführer | Pusey House SN7 8QB Pusey Oxfordshire | British | Company Director | 65130630002 | |||||||||
PALMER, Christopher Antony | Geschäftsführer | Church Farm East Woodhay RG20 0AL Newbury Berkshire | British | Company Director | 4764800001 | |||||||||
PALMER, Christopher Antony | Geschäftsführer | Church Farm East Woodhay RG20 0AL Newbury Berkshire | British | Company Director | 4764800001 | |||||||||
RAINE, Richard Denby | Geschäftsführer | 1 Acris Street SW18 2QT London | British | Accountant | 50519950001 | |||||||||
RIEDIJK, Hans Arie | Geschäftsführer | Trompenburo Straat 10m 1079 TX Amsterdam The Netherlands | Dutch | Director | 57483360001 | |||||||||
SMITS, Robert Anthony | Geschäftsführer | Heemraadschapslaan 2 1181 Vb Amstelveen | Dutch | Director | 54592350001 | |||||||||
STONE, Richard | Geschäftsführer | 6 Birchways WA4 5DQ Appleton Cheshire | British | Accountant | 75179060001 | |||||||||
T I P EUROPE LIMITED | Geschäftsführer | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | 65164760003 |
Hat TIPHOOK FINANCIAL SERVICES Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 26. Juli 1996 Geliefert am 30. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The payment obligations due from the company to the chargees pursuant to the terms of the credit agreement and the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Proceeds account charge | Erstellt am 26. Juli 1996 Geliefert am 30. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to, all or any of: (a) the credit agreement; and (b) the company's guarantee and the account charge (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben The company, with full title guarantee assigned and agreed to assign absolutely to the agent all the company's right title benefit and interest in and to the charged account including without limitation the balances standing to the credit of the charged account from time to time and at any time as a continuing security in favour of the agent for the discharge on demand of the secured obligations.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 21. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined therein) or the banks (as defined in the credit agreement dated 13TH february 1994) on any account whatsoever under the terms of the said credit agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Proceeds account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 21. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) under the terms of the credit agreement dated 13TH february 1994, a guarantee of even date, this charge and any contract, agreement or other document (all as therein defined) | |
Kurze Angaben All right title benefit and interest in and to the company's account numbered 76649229 held with the bank including the balances standing to the credit thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 19. Okt. 1989 Geliefert am 01. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due the company to commonwealth bank of australia under a loan agreement of even dated and under the terms of the mortgage. | |
Kurze Angaben Containing and fixed or specific security:- 707 (seven hundred and seven) 40FT dry van containers having te serial number 460706 - 460712, 465913 - 466112, and 462313 - 463312 includsive. (See form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
04 | Erstellt am 19. Mai 1989 Geliefert am 06. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of a facility letter dated 27.2.89. | |
Kurze Angaben All the company's interest in the containers (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1989 Geliefert am 02. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of a ficility letter dated 27 february 1989 | |
Kurze Angaben 2999 dry van containers (see form 395 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 13. März 1989 Geliefert am 29. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights title and interests present and future in the containers listed on form 395 see form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 06. März 1989 Geliefert am 10. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 16/9/88. | |
Kurze Angaben All freight containers as described in the schedule attached to the form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment | Erstellt am 10. Feb. 1989 Geliefert am 13. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase contract taking offect from 31/3/88 as amended by a novation agreement dated 10/2/89 | |
Kurze Angaben The company's right, title interest & benefit in and to a sub-hire agreement relating to the trailers dated 31/3/88 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment | Erstellt am 10. Feb. 1989 Geliefert am 13. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase contract taking effect from 31/1/89 as amended by a novation agreement dated 10/2/89 | |
Kurze Angaben The company's right, title interest & benefit in and to a sub-hire agreement relating to the containers dated 31/3/88 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Master thire purchase agreement | Erstellt am 29. Nov. 1988 Geliefert am 14. Dez. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The equipment (as the same in more particularly identified in the hiring schedule (s) to be delivered by the hirer to the bank pursuant to the master hp agreement) (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 28. Sept. 1988 Geliefert am 11. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility agreement dated 20/7/88 and under the terms of the chattel mortgage | |
Kurze Angaben The goods or chattels specified in the schedule attached to form 395 all documents relating to the chattels. The benefit of all contracts & agreements (including all conditions and warranties) (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage and charge | Erstellt am 03. Juni 1988 Geliefert am 15. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 31/3/88 and/or the security documents as defined and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben 1972 dry van containers (see from 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of insurance | Erstellt am 24. Mai 1988 Geliefert am 06. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to novatin agreements dated 31-3-88. | |
Kurze Angaben All of the insurance policies whatsoever in respect of certain equipment (as defined in the first novation agreement and the second novation agreement) ad all benefits thereof including all claims of whatsoever nature and returns of premises. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 18. Mai 1988 Geliefert am 25. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,999,627.91 | |
Kurze Angaben (1) 224 40' x 8'6" dry van containers supplied by evergreen heavy industrial corporation. Serial nos: tphu 440921 - tphu 441144 inclusive (2) 400 40' x 8' x 8'6" dry van containers supplied by hyumdai corporation serial nos: tphu 443221 - tphu 443620 inclusive. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. März 1988 Geliefert am 19. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 13/12/85 as amended by a novation and sale agreement dated 31/3/88 and the legal mortgage. | |
Kurze Angaben Charge by way of assignment 330 twenty foot dry freight containers ("the equipment") together with all rental and other earnings derived from the utilisation thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. März 1988 Geliefert am 19. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under ther terms of a loan agreement dated 18/11/87 as a mended by a novation and sale agreement dated 31/3/88 and the legal mortgage | |
Kurze Angaben Charge by way of assignment 224, forty foot dry van containers and 724 twenty foot dry van containers ("the equipment") together with all rental and other earnings derived from the utilisation thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. März 1988 Geliefert am 19. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 22 january 1978 as amended by a novation and sale agreement dated 31 march 1988 and the legal mortgage | |
Kurze Angaben Charge by way of assignment 1,550 forty foot dry van containers and 340 twenty foot dry freight containers (the equipment) together with all rental and other earnings derived from teh utilisation thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. März 1988 Geliefert am 19. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 29/10/85 as amended by a novation and sale agreement dated 31/3/88 and the legal mortgage | |
Kurze Angaben Charge by way of assignment 2,000 twenty foot dry freight containers together with all rental and other earnings derived from the utilisation thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 31. März 1988 Geliefert am 08. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 29/11/84 and a novation and sale agreement dated 31/3/88 and under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben All freight containers "(the equipment)" as described in the schedule attached to form 395 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 31. März 1988 Geliefert am 08. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 10/2/88 and a novation and sale agreement dated 31/3/88 and under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben All freight containers "(the equipment)" as described in the schedule attached to form 395 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat TIPHOOK FINANCIAL SERVICES Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0