MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED

MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01486046
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MURRAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980
    FOXDENE LIMITED18. März 198018. März 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Jan. 2017

    18 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order replacement liquidators 29/11/2016
    5 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Jan. 2016

    16 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Rücktritt eines Liquidators

    1 Seiten4.33

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Gateley Llp One Eleven Edmund Street Birmingham B3 2HJ zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 18. Feb. 2015

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 05. Jan. 2015

    LRESEX

    Vermögensübersicht

    4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 1,308,570.7
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012

    14 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Sir David Edward Murray am 17. Mai 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Brightgate House Cobra Court 1 Brightgate Way Trafford Park Manchester M32 0TB* am 17. Mai 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    20 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von James Wilson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HORNE, David William Murray
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Sekretär
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British41593900004
    MCGILL, Michael Scott
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    ScotlandBritish99070570001
    MURRAY, David Edward
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    ScotlandBritish34535230003
    TAHIR, Sarah
    13 Marchmont Street
    EH9 1EL Edinburgh
    Sekretär
    13 Marchmont Street
    EH9 1EL Edinburgh
    British38346270001
    TUDHOPE, Ian Barclay
    11a Grange Road
    EH9 1UQ Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    11a Grange Road
    EH9 1UQ Edinburgh
    Midlothian
    British714220002
    COCKBURN, Kenneth Andrew
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    Geschäftsführer
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    ScotlandBritish835820002
    FREELAND, George Keith
    18 Midmar Drive
    EH10 6BU Edinburgh
    Geschäftsführer
    18 Midmar Drive
    EH10 6BU Edinburgh
    British809960002
    GROSSART, Angus Mcfarlane Mcleod, Sir
    64 Northumberland Street
    EH3 6JE Edinburgh
    Geschäftsführer
    64 Northumberland Street
    EH3 6JE Edinburgh
    United KingdomBritish159850001
    HORNE, David William Murray
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    British41593900002
    MACDONALD, James
    175 Whitehouse Road
    Barnton
    EH4 6DD Edinburgh
    Geschäftsführer
    175 Whitehouse Road
    Barnton
    EH4 6DD Edinburgh
    ScotlandBritish159510002
    ROSE, Harvey
    31 Howberry Road
    HA8 6SS Edgware
    Middlesex
    Geschäftsführer
    31 Howberry Road
    HA8 6SS Edgware
    Middlesex
    British4582790001
    TUDHOPE, Ian Barclay
    Cobra Court 1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House
    Geschäftsführer
    Cobra Court 1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House
    ScotlandBritish714220006
    WILSON, James Donald Gilmour
    Cobra Court 1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House
    Geschäftsführer
    Cobra Court 1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House
    ScotlandBritish69298770001

    Hat MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 20. Apr. 2010
    Geliefert am 28. Apr. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 23RD january 2006 and
    Erstellt am 09. Jan. 2006
    Geliefert am 02. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    58A north castle street, edinburgh t/no MID47779.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 21ST october 1998
    Erstellt am 17. Sept. 1998
    Geliefert am 30. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee (a) in terms of the personal bond granted by the company dated 17TH september 1998 and (b) by NH1 limited in terms of the facility letter dated 24TH november 1992
    Kurze Angaben
    First floor premises at 100 edmiston drive ibrox glasgow with the lift shaft on the ground and first floor levels t/no GLA62016.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registrationin scotland on the 16 october 1998 and
    Erstellt am 17. Sept. 1998
    Geliefert am 20. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future sums of money (howsoever arising) due and that may become due to the chargee (a) in terms of the personal bond granted by the company in favour of the bank dated 17 september 1998 and (b) by NH1 limited (now named murray international holdings limited) in terms of the facility letter dated 24 november 1992 from the bank to NH1 limited as varied,amended or supplemented from time to time
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects comprising the first floor premises at 100 edminston drive,ibrox,glasgow with the lift shaft on the ground and first floor levels.t/no.gla 62016.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Minute of agreement
    Erstellt am 28. Feb. 1996
    Geliefert am 11. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 24TH november 1992
    Kurze Angaben
    10,000 ordinary £1 fully paid shares and 11,250,000 cumulative redeemable preference £1 fully paid shares in mim property developments limited and/or dividends and interest arising from the shareholding.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set-off
    Erstellt am 17. Apr. 1991
    Geliefert am 29. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from sunday scot limited and/or murray media limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of murray international holdings limited.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 29. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 14. Juni 1990
    Geliefert am 25. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under "the agreement" as defined
    Kurze Angaben
    Ground and buildings to south of queensferry road, edinburgh, and east or north-east of queensferry terrace, formerly queensway hotel, 1 queensferry terrce, edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • London & Metropolitan Scotland Limited
    Transaktionen
    • 25. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 21. Mai 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland 2 aug 88.
    Erstellt am 02. Aug. 1988
    Geliefert am 15. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    10.53 acres, 1.84 acres and 4.84 acres at south gyle industrial estate, edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 29. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set-off
    Erstellt am 11. Jan. 1988
    Geliefert am 19. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from murray international metals LTD and/or any of the other companies specified in the schedule to the charge to the chargee
    Kurze Angaben
    The balance at credit of any accounts held by the bank in name of murray international holdings limited.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 07. Nov. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set-off
    Erstellt am 07. Feb. 1986
    Geliefert am 28. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from murray international contracting limited and/or premier alloys limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    • 07. Nov. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of postponement
    Erstellt am 03. Apr. 1985
    Geliefert am 17. Apr. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A letter of postponement dated 3 & 4 april 1985 and created by murray international holdings limited for securing all monies due or to become due from murray pipework limited to the chargee was registered pursuant to section 95 of the companies act, 1948 on 17 april 1985.
    Kurze Angaben
    All sums advanced, together with any other sums which may hereafter be advanced by the company to murray pipeworks limited these sums not to be reduced below £125,000.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1985Registrierung einer Belastung
    • 07. Nov. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set-off
    Erstellt am 09. Okt. 1984
    Geliefert am 22. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from northern surplus steel stock limited &/or m s w (business systems) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All sums standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1984Registrierung einer Belastung
    • 07. Nov. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set-off
    Erstellt am 07. Okt. 1983
    Geliefert am 27. Okt. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from nuclear medical electronic systems & services limited and/or david herd (steel) limited and/or gibrant engineering limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All sums standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1983Registrierung einer Belastung
    • 29. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set-off
    Erstellt am 21. Juli 1982
    Geliefert am 11. Aug. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from murray international metals limited and/or multt metals (scotland) limited and/or murray steel sheets limited and/or metallurgical testing services (scotland) limited and/or forth steel limited and/or murray international norge limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All sums standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1982Registrierung einer Belastung
    • 05. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of setoff
    Erstellt am 01. Okt. 1981
    Geliefert am 20. Okt. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from ian ramsay (metals) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    At sums at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1981Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 05. Feb. 1981
    Geliefert am 19. Feb. 1981
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital & all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1981Registrierung einer Belastung
    Letter of set-off
    Erstellt am 05. Feb. 1981
    Geliefert am 19. Feb. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from murray fasteners (aberdeen) limited and/or murray seymour limited and/or murray steel sheets limited and/or metallurgical testing services (scotland) limited and/or ferrous metal trading limited and/or murray international metals limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All sums which now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1981Registrierung einer Belastung

    Hat MURRAY GROUP MANAGEMENT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Jan. 2015Beginn der Liquidation
    07. Dez. 2017Soll aufgelöst werden am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    William Kenneth Dawson
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    Praktiker
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    John Charles Reid
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Praktiker
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Christopher Mckay
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Praktiker
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0