SHEPPARDS WASTE RECOVERY SERVICES (ROCHDALE) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SHEPPARDS WASTE RECOVERY SERVICES (ROCHDALE) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01490038 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SHEPPARDS WASTE RECOVERY SERVICES (ROCHDALE) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich SHEPPARDS WASTE RECOVERY SERVICES (ROCHDALE) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sirius House, Delta Crescent Westbrook WA5 7NS Warrington Cheshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHEPPARDS WASTE RECOVERY SERVICES (ROCHDALE) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SHEPPARDS WASTE RECOVERY SERVICES (ROCHDALE) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Kevin Fairclough als Direktor am 30. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Trevor Sheppard als Geschäftsführer am 28. Feb. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Jan. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SHEPPARDS WASTE RECOVERY SERVICES (ROCHDALE) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINSLEY, Christopher John | Sekretär | Sirius House, Delta Crescent Westbrook WA5 7NS Warrington Cheshire | 163072890001 | |||||||
FAIRCLOUGH, Kevin | Geschäftsführer | Delta Crescent Westbrook WA5 7NS Warrington Sirius House Cheshire England | United Kingdom | British | Accountant | 299537900001 | ||||
SHEPPARD, Christopher Phillip | Geschäftsführer | Delta Crescent Westbrook WA5 7NS Warrington Sirius House Cheshire England | England | British | Company Director | 151399580001 | ||||
SHEPPARD, Robin | Geschäftsführer | Bagslate Moor Road OL11 5YH Rochdale 65 England England | United Kingdom | British | Director | 6443290002 | ||||
ARMER, Peter Thomas | Sekretär | 16 Heysham Avenue Heysham LA3 2DH Morecambe Lancashire | British | 71912780003 | ||||||
CALLAGHAN, Peter John | Sekretär | Penn Oast Manor Lane Hollingbourne ME17 1UN Maidstone Kent | British | 25043970001 | ||||||
HUGHES, Michael Blake | Sekretär | 209 Newcastle Road ST15 8LF Stone Staffordshire | British | Accountant | 77731090003 | |||||
INGALL, David James | Sekretär | 31 Marlborough Avenue SK8 7AP Cheadle Hulme Cheshire | British | Secretary | 50988810002 | |||||
MAHER, Michael John | Sekretär | 7 Cae Eithin Lixwm CH8 8NB Holywell Clwyd | British | Company Secretary | 110531730001 | |||||
SHEPPARD, Phillip Robert | Sekretär | 15 Broadhalgh Avenue Bamford OL11 5LW Rochdale Lancashire | British | 6443270001 | ||||||
STINSON, Neil Andrew | Sekretär | Delta Crescent Westbrook WA5 7NS Warrington Sirius House Cheshire England | British | 130992930001 | ||||||
WARREN, Nicholas | Sekretär | 15 Chaddock Lane Boothstown M28 1DB Worsley | British | 79704130002 | ||||||
WARREN, Nick | Sekretär | 88 Derbyshire Lane Stretford M32 8DR Manchester Lancashire | British | Accountant | 69209510001 | |||||
ILES, Colin David | Geschäftsführer | 75 1 Myrtle Ave Edgewater New Jersey 07020 Usa | British | Director | 48986000008 | |||||
SHEPPARD, Phillip Robert | Geschäftsführer | Delta Crescent Westbrook WA5 7NS Warrington Sirius House Cheshire England | England | British | Director | 6443270001 | ||||
SHEPPARD, Trevor | Geschäftsführer | Sirius House, Delta Crescent Westbrook WA5 7NS Warrington Cheshire | British | Director | 6452510001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SHEPPARDS WASTE RECOVERY SERVICES (ROCHDALE) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Metal Recycling (Dormant) Ltd | 06. Apr. 2016 | Delta Crescent Westbrook WA5 7NS Warrington Sirius House Cheshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SHEPPARDS WASTE RECOVERY SERVICES (ROCHDALE) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Erstellt am 29. Nov. 1994 Geliefert am 14. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See charge particulars form for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second fixed and floating charge | Erstellt am 29. Nov. 1994 Geliefert am 09. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from nobledrift limited to the chargee pursuant to clause 3.5.1. of a share sale agreement of even date | |
Kurze Angaben See charge particulars form for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 05. Juni 1992 Geliefert am 10. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company;and all patents patent applications inventions trade marks trade names registered designs copyrights know how and other intellectual property rights and all licences and ancillary rights and benefits including alll royalties fees and other income deriving from the same both present and future of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 05. Mai 1989 Geliefert am 18. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Charge by way of legal mortgage over 1ST floor offices unit b 50 brewery road london N7 9NH, 6TH floor 70-78 york way london N1 and the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage & charge. | Erstellt am 28. Apr. 1989 Geliefert am 18. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from sheppard group limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Kandirator metal processing machine (see form M395 - ref M320 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 18. Juni 1987 Geliefert am 24. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0