PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01494788 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PARK AVENUE PRODUCTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY | 31. Dez. 1980 | 31. Dez. 1980 |
| ENDOWN LIMITED | 01. Mai 1980 | 01. Mai 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Garth Jones als Direktor am 01. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rebecca Adele Horne als Geschäftsführer am 01. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY zum 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN am 04. Aug. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mrs Rebecca Adele Horne als Direktor am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alison Jane Clarke als Geschäftsführer am 14. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD zum 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY am 03. Juli 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Alison Jane Clarke als Direktor am 31. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sally-Ann Patricia Withey als Geschäftsführer am 30. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Kathryn Lees als Sekretär am 08. Aug. 2014 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Neil Garth | Geschäftsführer | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | England | British | 204774750001 | |||||
| MORROW, Andrew Martin | Geschäftsführer | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | United Kingdom | British | 167225950001 | |||||
| BUTTERWORTH, Michael Guy | Sekretär | The Woodman, Howe Street, Great Waltham CM3 1BA Chelmsford | British | 76600500002 | ||||||
| BUTTERWORTH, Tina Gillian | Sekretär | 33 Augustus Close TW8 8QE Brentford Middlesex | British | 31799060001 | ||||||
| HARIA, Jigna | Sekretär | 47 Briar Road Kenton HA3 0DP Harrow Middlesex | British | 24063500003 | ||||||
| LEES, Jennifer Kathryn | Sekretär | 15-17 Huntsworth Mews NW1 6DD London | British | 24587010002 | ||||||
| NICHOLS, Richard Stephen | Sekretär | 3a Devonshire Road AL5 4TJ Harpenden Hertfordshire | British | 54128690001 | ||||||
| ADAMS, Colin Raymond | Geschäftsführer | 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD | England | British | 39245820011 | |||||
| ATTERBURY THOMAS, David | Geschäftsführer | 47 St Johns Park Blackheath SE3 7JW London | England | British | 38008820001 | |||||
| BROADHEAD, Tymon Piers | Geschäftsführer | Huntsworth Mews NW1 6DD London 15-17 | England | British | 105342600002 | |||||
| BUTTERWORTH, Michael Guy | Geschäftsführer | The Woodman, Howe Street, Great Waltham CM3 1BA Chelmsford | England | British | 76600500002 | |||||
| BUTTERWORTH, Tina Gillian | Geschäftsführer | 33 Augustus Close TW8 8QE Brentford Middlesex | British | 31799060001 | ||||||
| CADMAN, Anthony | Geschäftsführer | 23 Criffel Avenue SW2 4AY London | British | 26272690001 | ||||||
| CARSWELL, Hugh Aidan | Geschäftsführer | Top Flat 39 Beresford Road N5 2HS London | United Kingdom | British | 46017340001 | |||||
| CLARKE, Alison Jane | Geschäftsführer | London Wall Buildings EC2M 5SY London 3 England | United Kingdom | British | 93418210001 | |||||
| DAWSON, Paul Timothy | Geschäftsführer | 28 Greenlands Road TW18 4LR Staines Middlesex | United Kingdom | British | 182444600001 | |||||
| GREEN, Graham James | Geschäftsführer | Kings Mill House South Nutfield RH1 5NG Redhill Surrey | United Kingdom | British | 10528660001 | |||||
| GREENING, Nigel Douglas | Geschäftsführer | Smallbrook Barn Thursley GU8 6QN Godalming Surrey | British | 64673590001 | ||||||
| HARIA, Jigna | Geschäftsführer | 47 Briar Road Kenton HA3 0DP Harrow Middlesex | British | 24063500003 | ||||||
| HORNE, Rebecca Adele | Geschäftsführer | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | United Kingdom | British | 188956200001 | |||||
| NICHOLS, Richard Stephen | Geschäftsführer | 15a Rothamsted Avenue AL5 2DD Harpenden Hertfordshire | England | British | 54128690003 | |||||
| PEPLOW, Henry | Geschäftsführer | The Barn Frieth RG9 6PR Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 101890460001 | |||||
| PERRY, Ian | Geschäftsführer | 15 Lion Gate Gardens TW9 2DW Richmond Surrey | British | 66616730001 | ||||||
| SELMAN, Roger Malcolm | Geschäftsführer | 5 Vineries Bank Milespit Hill Mill Hill NW7 2RP London | United Kingdom | British | 10691510002 | |||||
| TAPPING, Simon Mark | Geschäftsführer | 43 Archway Street Barnes SW13 0AS London | British | 47935050001 | ||||||
| TUKE-HASTINGS, Derrick Somerville | Geschäftsführer | Perrotts Brook House Perrotts Brook GL7 7BS Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | 31799070001 | |||||
| WEST, Paul William | Geschäftsführer | The Barton Neopardy EX17 5EP Crediton Devon | British | 109447350002 | ||||||
| WITHEY, Sally-Ann Patricia | Geschäftsführer | 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD | England | British | 109428260052 | |||||
| WRIGHT, David Ernest | Geschäftsführer | The Priory 23 Matham Road KT8 0SX East Molesey Surrey | British | 14119160001 | ||||||
| WROE, Denise | Geschäftsführer | 3 Avenue Cottages High Street Mill Hill Village NW7 1QY London | British | 80857550001 | ||||||
| YARDLEY, Daniel John | Geschäftsführer | Dingwall Road Earlsfield SW18 3AZ London 21a | United Kingdom | British | 147796180001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I G Communications Limited | 06. Apr. 2016 | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and | Erstellt am 24. Apr. 2007 Geliefert am 15. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 03. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 20. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and | Erstellt am 12. Aug. 2005 Geliefert am 26. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and | Erstellt am 27. Juli 2005 Geliefert am 04. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Okt. 1987 Geliefert am 22. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 20. März 1986 Geliefert am 26. März 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts. Uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. März 1981 Geliefert am 30. März 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,000 | |
Kurze Angaben Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0