SMARTWARDEN LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SMARTWARDEN LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01495213 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SMARTWARDEN LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich SMARTWARDEN LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 33 Cavendish Square W1G 0PW London London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SMARTWARDEN LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
COUNTRY HOUSE RETIREMENT HOMES LIMITED | 01. Aug. 1984 | 01. Aug. 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SMARTWARDEN LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SMARTWARDEN LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SMARTWARDEN LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Hill House 1 Little New Street London London EC4A 3TR geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2014 | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sunita Kaushal als Sekretär am 29. Juli 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2013 | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 33 Cavendish Square London London W1B 0PW England* am 28. Aug. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Caldecott als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* am 01. Juli 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Colin Elliot als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Gareth Caldecott am 18. Dez. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gareth Caldecott am 05. Nov. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gareth Caldecott am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* am 05. Sept. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Maxwell Coppel am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sunita Kaushal am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 1 West Garden Place Kendal Street London W2 2AQ England* am 05. Dez. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SMARTWARDEN LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPEL, Andrew Maxwell | Geschäftsführer | Portland Place W1B 1PU London 17 London United Kingdom | England | British | Director | 163106000001 | ||||
ELLIOT, Colin David | Geschäftsführer | Portland Place W1B 1PU London 17 London England | United Kingdom | British | Director | 178756480001 | ||||
ATKINSON, Colin | Sekretär | The Spinney Lewes Road RH19 3UQ East Grinstead West Sussex | British | 20115490002 | ||||||
COPELAND, Francis Charles Stuart | Sekretär | 29 West House Court Broken Cross SK10 3NZ Macclesfield Cheshire | British | Company Secretary | 15613380001 | |||||
EDWARDS, David Charles | Sekretär | Greenbanks Close Milford On Sea SO41 0SQ Lymington 7 Hampshire | British | Barrister | 123440090026 | |||||
FARQUHARSON, John Alan | Sekretär | Oak Lodge Windmill Lane Appleton WA4 5JN Warrington Cheshire | British | Solicitor | 15541980001 | |||||
HARRISON, Jonathan Charles | Sekretär | Brambletye New Mill Road RG40 4QT Finchampstead Berkshire | British | 51526360001 | ||||||
KAUSHAL, Sunita | Sekretär | Portland Place W1B 1PU London 17 London England | 158960220001 | |||||||
MARTLAND, David James | Sekretär | 73 Hall Lane Aspull WN2 2SF Wigan Greater Manchester | British | 35477380001 | ||||||
FILEX SERVICES LIMITED | Sekretär | 179 Great Portland Street W1W 5LS London | 3620420001 | |||||||
ATKINSON, Colin John | Geschäftsführer | The Spinney Lewes Road RH19 3UQ East Grinstead West Sussex | United Kingdom | British | Finance Director | 69291470001 | ||||
BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Geschäftsführer | 6 Connaught Square W2 2HG London | United Kingdom | British | Director | 34251500001 | ||||
BIBRING, Michael Albert | Geschäftsführer | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | Solicitor | 9320160002 | ||||
CALDECOTT, David Gareth | Geschäftsführer | Portland Place W1B 1PU London 17 London England | England | British | Director | 73603940004 | ||||
CAVE, Ian Bruce | Geschäftsführer | 392 Woodstock Road OX2 8AF Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 102741680001 | ||||
EDWARDS, David Charles | Geschäftsführer | Greenbanks Close Milford On Sea SO41 0SQ Lymington 7 Hampshire | United Kingdom | British | Barrister | 123440090026 | ||||
FARQUHARSON, John Alan | Geschäftsführer | Oak Lodge Windmill Lane Appleton WA4 5JN Warrington Cheshire | England | British | Solicitor | 15541980001 | ||||
FEARN, Matthew Robin Cyprian | Geschäftsführer | Brook House Brook Road CW6 9HH Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 109155280002 | ||||
HARRISON, Jonathan Charles | Geschäftsführer | Brambletye New Mill Road RG40 4QT Finchampstead Berkshire | British | Accountant | 51526360001 | |||||
LUDFORD, Peter Campbell | Geschäftsführer | 18 The Avenue Rowledge GU10 4BD Farnham Surrey | British | Company Director | 41484030002 | |||||
PALLANT, Anthea Joy | Geschäftsführer | Fox Cottage 1 Home Farm Close KT16 0PN Ottersham Surrey | British | Managing Director | 34385880004 | |||||
PETERS, David Charles | Geschäftsführer | 93 Percy Road TW12 2JS Hampton Middlesex | British | Managing Director | 44700870001 | |||||
REED, Stuart James | Geschäftsführer | 9 Elm Rise Prestbury SK10 4US Macclesfield Cheshire | British | Company Director | 2250490001 | |||||
REID, Hubert Valentine | Geschäftsführer | The Old Rectory Cocksmoss Lane Marton SK11 9HX Macclesfield Cheshire | British | Managing Director | 34122950001 | |||||
SINGH, Jagtar | Geschäftsführer | 6 Paines Lane HA5 3DQ Pinner Middlesex | United Kingdom | British | Director | 121710890001 | ||||
STOREY, Martin John | Geschäftsführer | Ysgubor Newydd Nannerch CH7 5RD Mold Clwyd | British | Company Director | 35968160001 | |||||
STUBBS, Roger Gordon | Geschäftsführer | Beech House 36 Parkgate Road, Neston CF64 6QG South Wirral Merseyside | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 4795660002 | ||||
WALKER, Jean | Geschäftsführer | Little Garth Lime Grove GU4 7UT West Clandon Surrey | England | British | Director Of Nursing | 47670830001 |
Hat SMARTWARDEN LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Third supplemental trust deed | Erstellt am 16. Sept. 1998 Geliefert am 01. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee the principal of and interest on the stock, being £99,650,450 11 1/2 per cent. Debenture stock 2014 of the greenalls group PLC and any further debenture stock of the greenalls group PLC created or issued pursuant to clause 3 of the principal trust deed, and all other monies intended to be secured by the principal trust deed dated 5 june 1991, any deed expressed to be supplemental thereto and any other deed or instrument conferring rights on the chargee executed or entered into pursuant to the principal trust deed or any deed supplemental thereto | |
Kurze Angaben The undertaking and all the property and assets present and future wherever situated (including any uncalled capital) of the company by way of first floating charge.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second supplemental trust deed | Erstellt am 16. Sept. 1998 Geliefert am 24. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The guarantee by the company to the trustee of the payment by the greenalls group PLC of all sums on account of the principal of or interest on the £30,000,000 10 1/2 per cent.(formerly 10 1/4 per cent) debenture stock 2017 (repayable on 23RD june 2017 or such earlier date as the security constituted by the trust deed the supplemental trust deed and the second supplemental trust deed becomes enforceable and the trustee determines or becomes bound to enforce the same) and of any moneys intended to be secured by the second supplemental trust deed | |
Kurze Angaben First floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. März 1988 Geliefert am 22. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Pirton hall shillinggton hitchin hertfordshire T.N. hd 223765. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. März 1988 Geliefert am 16. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Staplehurst manor friltenden road staplehurst kent T.N. K620250. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 1988 Geliefert am 05. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "sale and purchase agreement" of even date. | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a puttenham hill house puttenham hill, holloway hill nr guildford surrey GU3 1AH t/no sy 283524. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 1988 Geliefert am 18. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Puttenham hill house puttenham hm guildford surrey T.n sy 283524. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 15. Juni 1987 Geliefert am 24. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 03. Apr. 1987 Geliefert am 13. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. März 1987 Geliefert am 27. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a pirton hall pirton country of hertfordshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Dez. 1986 Geliefert am 22. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a iden old manor staplehurst kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Dez. 1986 Geliefert am 18. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Dez. 1986 Geliefert am 18. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a ashley park the street west clandon surrey T.N. sy 486270 and sy 486270. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 10. Sept. 1984 Geliefert am 27. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or pelmarcrest limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Sept. 1984 Geliefert am 27. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold dene place, ripley lane, west horsley, surrey, title no sy 524901. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Sept. 1984 Geliefert am 18. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold dene place, ripley lane, west horsley, surrey. Title no. Sy 524901. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Sept. 1984 Geliefert am 18. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Sept. 1984 Geliefert am 18. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold ashley parks, the street, west clandon, guildford, surrey. Title no. Sy 486270. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Sept. 1983 Geliefert am 06. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H ashley park, the street, west clandon, guildford, surrey. Title no sy 486270. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Nov. 1982 Geliefert am 01. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ashley park the street west clandon guildford surrey T.no sy 486270. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Juli 1982 Geliefert am 11. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H tanfield place west clandon, guildford surrey title no: sy 486270 together fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 26. Juli 1982 Geliefert am 05. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The company's undertaking and all it's property and assets whatsoever. Together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0