GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01509352 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TIFFANY FOODS LIMITED | 29. Juni 1988 | 29. Juni 1988 |
| NORMANCROWN LIMITED | 25. Juli 1980 | 25. Juli 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Aug. 2014 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE United Kingdom* am 30. Aug. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael John Hopster als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Elizabeth Honor Lewzey als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Thomas C. Reeve als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Rudkin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roger Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 20 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicolas Paul Wilkinson am 01. Juli 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicolas Paul Wilkinson am 15. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicolas Paul Wilkinson am 01. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * East Putney 84 Upper Richmond Road London SW15 2ST* am 07. Juli 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Denise Burton als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Michael John Hopster als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Geschäftsführer | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||
| REEVE, Thomas C. | Geschäftsführer | Wewatta Street 80202 Denver 1551 Colorado Usa | United States | American | 161822390001 | |||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Geschäftsführer | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 48808690001 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Sekretär | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||
| CRADDOCK, Martin Keith Robert | Sekretär | The Dairy House St Nicholas Farm RG10 0TA Hurst Berkshire | British | 2383560001 | ||||||
| HOPSTER, Michael John | Sekretär | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B | 157127850001 | |||||||
| MILLER, Roger Keith | Sekretär | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| THOMAS, Russell Leslie | Sekretär | 6 Grailands CM23 2RG Bishops Stortford Hertfordshire | British | 20898530001 | ||||||
| BURNELL, Ian William | Geschäftsführer | Bearswood 4 Orchard Croft Wales S26 5UA Sheffield | United Kingdom | British | 62806490001 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Geschäftsführer | 42 Windmill Rise Kingston Hill KT2 7TU Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570001 | ||||||
| CLARKE, Brian | Geschäftsführer | 19 Chestnut Grove Maltby S66 8DX Rotherham South Yorkshire | British | 53816930001 | ||||||
| CRADDOCK, Martin Keith Robert | Geschäftsführer | The Dairy House St Nicholas Farm RG10 0TA Hurst Berkshire | British | 2383560001 | ||||||
| DAVIES, Janet | Geschäftsführer | Little Waltham Hall Brook Hill CM3 3LJ Little Waltham Chelmsford Essex | British | 36045400002 | ||||||
| GUERRA, Fernando Jose Ferreira Marques | Geschäftsführer | 7 Wickham Place Lenham ME17 2PF Maidstone Kent | Portuguese | 29158440001 | ||||||
| HITCHIN, Tony Frederick | Geschäftsführer | 212 Stoneleigh Park Road KT19 0RQ Epsom Surrey | British | 66642540001 | ||||||
| IRVING, Patrick Haydn | Geschäftsführer | Hyeswood Guildford Road Rudgwick RH12 3BX Horsham West Sussex | British | 19988500001 | ||||||
| MANN, Howard | Geschäftsführer | 19 Rivermead Court SL7 1SJ Marlow Buckinghamshire | British | 23349820002 | ||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Geschäftsführer | Brew House 6 Main Street Wardley LE15 9AZ Oakham Rutland | United Kingdom | British | 26880002 | |||||
| MARSDEN, Robert Walter | Geschäftsführer | 4 Milford Close Pembroke Park L37 2FW Formby Merseyside | England | British | 237858920001 | |||||
| MILLS, Michael John | Geschäftsführer | Astenne Springhill Punnetts Town TN21 9PE Heathfield E Sussex | British | 21732340001 | ||||||
| RUDKIN, Brian | Geschäftsführer | 3 Laurel Avenue Bramley S66 2NE Rotherham South Yorkshire | British | 53816970001 | ||||||
| SMITH, Rogert Stewart | Geschäftsführer | 3 Arran Hill Thrybergh S65 4BH Rotherham South Yorkshire | England | British | 183060380001 | |||||
| SPRING, Bernard Liam Patrick | Geschäftsführer | Winchet Hall Goudhurst TN17 1JX Cranbrook | British | 102843330001 | ||||||
| THOMAS, Russell Leslie | Geschäftsführer | Longcroft 9 Bullfinch Lane Riverhead TN13 2DY Sevenoaks Kent | British | 20898530002 |
Hat GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 14. Nov. 1985 Geliefert am 19. Nov. 1985 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets presnt and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 27. März 1985 Geliefert am 16. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tiffany foods limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H gillingham park gillingham kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. März 1985 Geliefert am 28. März 1985 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tiffany foods limited company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land & buildings at gillingham business park gillingham kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 06. Nov. 1984 Geliefert am 07. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All the borrowers right title and interest under an agreement for lease made 18/7/84 between gecd (gillingham) limited (1) normancrown & (2) tiffany foods limited & (3) all the estate interest or rights whatsoever of the company in the land & buildings forming part of the gillingham industrial park gillingham, kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 21. Aug. 1984 Geliefert am 29. Aug. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tiffany foods LTD to the chargee on any account whatsoever supplemental to the original agreement dated 18.5.81 and deeds supplemental thereto the collateral debenture dated 18.5.81 and the collateral mortgage dated 3.9.82. | |
Kurze Angaben All interest of the company under a building agreement dated 18.7.84 relating to gillingham business park gillingham kent (for full details see doc M18). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 21. Aug. 1984 Geliefert am 29. Aug. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tiffany foods limited to the chargee supplemental to the original agreement dated 18.5.81 and deeds supplemental thereto the collateral debenture dated 18.5.81 the collateral mortgage dated 3.9.82 & the collateral charge dated 21.8.84 | |
Kurze Angaben Fixed charge over all bookdebts due and owing to the company present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Okt. 1982 Geliefert am 14. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tiffany foods limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and buildings forming part of gillingham industrial park gillingham kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 03. Sept. 1982 Geliefert am 13. Sept. 1982 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tiffany foods limited to the chargee | |
Kurze Angaben L/H premises situate at and forming part of the gillingham park industrial estate gillingham kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. März 1982 Geliefert am 30. März 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben An agreement for lease made 28.5.81 between G.E.C.D. (gillingham) limited (1) normancrown limited (2) tiffany foods limited (3) all the benefits thereof and all the estate interest or rights whatsoever of the company in or to the land & buildings forming part of gillingham industrial park gillingham kent & also the equitable interest of the company in the said property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of charge | Erstellt am 18. Mai 1981 Geliefert am 26. Mai 1981 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents | |
Kurze Angaben All the companys rights & benefit under an agreement for development & lease dated 18 may 81. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 18. Mai 1981 Geliefert am 26. Mai 1981 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tiffany foods limited to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital all buildings fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Apr. 1981 Geliefert am 08. Mai 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h land and buildings known as the bus depot terminus road bexhill E. sussex title no- esx 61562 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GUEST & CHRIMES PENSION TRUSTEES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0