E.C.T. CELLULAR LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | E.C.T. CELLULAR LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01509414 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von E.C.T. CELLULAR LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich E.C.T. CELLULAR LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von E.C.T. CELLULAR LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EXECUTIVE CAR TELEPHONES LIMITED | 06. Dez. 1984 | 06. Dez. 1984 |
| MARC ALBERT - EXECUTIVE CAR TELEPHONES LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| MATFIELD LIMITED | 28. Juli 1980 | 28. Juli 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von E.C.T. CELLULAR LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für E.C.T. CELLULAR LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ernennung von Joanne Sarah Finch als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Richard Wolfgang Henry Schäfer als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christian Allen als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Nowak als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Martin John Purkess am 01. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 33 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Thomas Nowak am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christian Philip Quentin Allen am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Martin Purkess am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von E.C.T. CELLULAR LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRIGHT, Garth Howard | Sekretär | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire England | British | 130769810001 | ||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||
| PURKESS, Martin John | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | 139360020001 | |||||
| SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158146600001 | |||||
| COX, Homersham Martin | Sekretär | Littlewood Park View Buxted TN22 4LS Uckfield East Sussex | British | 1058000001 | ||||||
| EMETULU, Lola | Sekretär | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||
| JEFFERSON, Karen | Sekretär | 8 Bailey Close SN9 5HU Pewsey Wiltshire | British | 79393480001 | ||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Sekretär | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 123612980001 | ||||||
| BREWER, Stephen | Geschäftsführer | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | 79186090002 | ||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Geschäftsführer | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||
| CHESWORTH, Paul | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||
| COX, Homersham Martin | Geschäftsführer | Littlewood Park View Buxted TN22 4LS Uckfield East Sussex | British | 1058000001 | ||||||
| DIPRE, Paul Vincent | Geschäftsführer | Junta Waterhouse Lane KT20 6HT Kingswood Surrey | British | 3747590001 | ||||||
| DIPRE, Remo | Geschäftsführer | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| EVANS, Mark | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||
| HALFORD, Andrew Nigel | Geschäftsführer | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | 33951180005 | ||||||
| HANFORD, Raymond Clifford | Geschäftsführer | Romney Cottage Park Horsley East Horsley KT24 5RZ Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 45868080001 | |||||
| JONES, David Leslie | Geschäftsführer | Three Oak Barn RH14 0PY Plaistow West Sussex | British | 83517310001 | ||||||
| LANGSTON, Edward | Geschäftsführer | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||
| LEE, Simon Christopher | Geschäftsführer | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | 174443800001 | |||||
| READ, Nicholas Jonathan | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 87149560001 | |||||
| SAMUEL, James Charles Marshall | Geschäftsführer | 1 Grove Place Tatsfield TN16 2BA Westerham Kent | British | 24141650001 | ||||||
| TOURNON, Emanuele | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | 103542080002 | |||||
| TOWNSEND, John Raymond | Geschäftsführer | Knowle House Chapel Corner Hamstead Marshall RG20 0HP Newbury Berkshire | British | 95223480001 | ||||||
| WEBB, Denys William | Geschäftsführer | Oakfield Stud Whitemoor Lane, Upper Basildon RG8 8SF Reading Berkshire | United Kingdom | British | 76074580001 |
Hat E.C.T. CELLULAR LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Erstellt am 28. Apr. 1992 Geliefert am 19. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 for full details- doc M75. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Juni 1989 Geliefert am 20. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 02. März 1988 Geliefert am 07. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies deposited with the bank to the credited of the account mod. 0182273 designated E.C.T. cellular PLC. (See doc. For full details.). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 04. Jan. 1988 Geliefert am 08. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Markheath house 1238-1248 high rd whetstao london M20 together with all buildings and fixtures thereon goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 13. Mai 1987 Geliefert am 15. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Stocks shares & other securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Sept. 1986 Geliefert am 01. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property known as units 1 and 2 findley industrial estate, 879 high road, north finfhley l/b of barnet title no. Ngl 456815. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 17. Juli 1985 Geliefert am 18. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a lease dated 17 july 1985. | |
Kurze Angaben The sum of £16,180 deposited with barclays bank PLC 1 pall mall east london SW1 in an account designated whittingham/ect re unit 1 finchley industrial centre. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0