WILSON PECK PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WILSON PECK PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01511332 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Britannia House 960 High Road N12 9RY London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt eines Auditors | 2 Seiten | AA03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Stuart Gyles am 23. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Howard Barraclough am 23. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 04. Jan. 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 15 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2012 bis 31. Dez. 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX, Bernadette | Sekretär | Britannia House 960 High Road N12 9RY London | British | 126339720002 | ||||||
| BARRACLOUGH, John Howard | Geschäftsführer | Britannia House 960 High Road N12 9RY London | England | English | 90172020002 | |||||
| GRADEL, David | Geschäftsführer | 13 High View Gardens Finchley N3 3EX London | United Kingdom | British | 1590720001 | |||||
| GYLES, Robert Stuart | Geschäftsführer | Britannia House 960 High Road N12 9RY London | United Kingdom | British | 104637790003 | |||||
| FULLALOVE, Deanna | Sekretär | 18 Springfields Somerset Road New Barnet EN5 1SG Barnet Hertfordshire | British | 65539830003 | ||||||
| JACOBS, Laurence Anthony | Sekretär | 29 The Heights IG10 1RN Loughton Essex | British | 67329390003 | ||||||
| RIDEHALGH, Frank | Sekretär | 38 Scarborough Road FY8 3ES St Annes On Sea Lancashire | British | 36400480001 | ||||||
| ROBINSON, Margaret | Sekretär | 8 Alpine Walk The Common HA7 3HU Stanmore Middlesex | Other | 109710630001 | ||||||
| DEAKIN, Michael David | Geschäftsführer | 33 Dalebrook Court Stumperlowe Crescent Road S10 3PQ Sheffield | United Kingdom | British | 2991220001 | |||||
| GRADEL, Jack | Geschäftsführer | 18 Old Hall Road Broughton Park M7 0JH Manchester | British | 2991230001 | ||||||
| JACOBS, Laurence Anthony | Geschäftsführer | 29 The Heights IG10 1RN Loughton Essex | British | 67329390003 | ||||||
| MATHIAS, Thomas Reginald Richard | Geschäftsführer | Park Head Farm Pines Lane ST8 7SR Biddulph Park Staffordshire | British | 3927120001 | ||||||
| ORMEROD, David Anthony | Geschäftsführer | 3 Wheatfield Avenue AL5 2NU Harpenden Hertfordshire | British | 8575320001 | ||||||
| RIDEHALGH, Frank | Geschäftsführer | 38 Scarborough Road FY8 3ES St Annes On Sea Lancashire | British | 36400480001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk Estates Limited | 13. Sept. 2016 | High Road N12 9RY London Britannia House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WILSON PECK PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge deed | Erstellt am 16. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 4/5/6 market street,cambridge fixed charge the goodwill, the benefit of all licences, book debts, stocks shares and other securities.floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 14. Juni 2004 Geliefert am 22. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property known as 7-8 market street cambridge and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery the goodwill of any trade or business or other commercial activity by way of first floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 12. Juli 2002 Geliefert am 25. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclay house, 242-254 banbury road, summertown, oxford t/no. ON18883 together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery..the benefit of all guarantees indemnities rent deposits..by way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights..assigns the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 24. Jan. 2002 Geliefert am 29. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property known as 1-7 blackett street and 2-8 pilgrim street newcastle upon tyne t/no. TY199570 fixed charge the goodwill, the benefit of all licences, book debts, stocks shares and other securities..floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 24. Mai 2001 Geliefert am 30. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property known as 200 and 201 high street lincoln title number LL99294 and LL97767 and secondly 27 bridge street stratford-upon-avon title number WK2944379 and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time thereon. By way of floating charge all its land goods undertakings equipment and other items now or hereafter belonging to the borrower. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 22. Feb. 1991 Geliefert am 28. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from sheafbank property trust PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H property being land & buildings on the south side of john street salford t/n:- la 308734 assigns goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of set off | Erstellt am 31. Juli 1985 Geliefert am 07. Aug. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Juli 1985 Geliefert am 12. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H old kingfield works cricket and road, sheffield, west yorkshire title no. Syk 49259. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Juli 1985 Geliefert am 12. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, 178 and 180 west street, sheffield, south yorkshire. Title no. Syk 125680. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Juli 1985 Geliefert am 12. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as canton works, 88 to 92 (even) west street, sheffield, south yorkshire. Title no syk 42612. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of set off | Erstellt am 17. Jan. 1985 Geliefert am 31. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sums standings to the credit of any present/future account of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Feb. 1983 Geliefert am 26. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/H kingfield works, cricket inn road, shefield south yorkshire t/n syk 49259. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Feb. 1983 Geliefert am 26. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H canton works 88-92 west street, sheffiled south yorkshire t/n syk 42612. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Feb. 1983 Geliefert am 26. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H 178 and 180 west street sheffield, south yorkshire t/n syk 125680. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Nov. 1981 Geliefert am 02. Dez. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 13/15 parliament street harrogate north yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0