CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01511847 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED?
- Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | KPMG LLP 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum 15 Canada Square London E14 5GL am 10. Apr. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Jan. 2015 | 4 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Verschiedenes Aud res 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 23 Great Winchester Street London EC2P 2AX* am 06. Feb. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Richard Moody als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Charles Hitchings als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Barkman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Dipesh Patel als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Pamela Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Faraday als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTHERFORD, Adam Paul | Sekretär | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 70451850004 | ||||||
| HITCHINGS, Charles | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | 175089420001 | |||||
| MOODY, Richard | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | Irish | 173822430001 | |||||
| PATEL, Dipesh | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | 173797130001 | |||||
| CLARK, Giles Sebastian | Sekretär | 37 Durnsford Avenue Wimbledon Park SW19 8BH London | British | 38517290002 | ||||||
| FLETCHER, Edward Michael | Sekretär | 3 Aldrich Terrace SW18 3PU Earlsfield | British | 78572640002 | ||||||
| GREEN, Helen Estelle | Sekretär | Flat 7 Antilles Bay Apt Lawn House Close Isle Of Dogs E14 9YG London | British | 66783210007 | ||||||
| PAGE, Stephen Richard | Sekretär | 21 Davenport Road Albany Park DA14 4PN Sidcup Kent | British | 38547590001 | ||||||
| WITHINGTON, Annabel Katherine Goddard | Sekretär | 133 Staines Road TW2 5BD Twickenham Middlesex | British | 7117350004 | ||||||
| BARKMAN, Scott Mckay | Geschäftsführer | Walden House Road CM9 8PJ Great Totham 1a Essex United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | 91404900001 | |||||
| BRADFORD, Valerie Ann | Geschäftsführer | Canfield Park Cottage Canfield Road, Takeley CM22 6ST Bishops Stortford Hertfordshire | British | 74285610001 | ||||||
| DEWDNEY, Andrew David | Geschäftsführer | Cranfield Broad Oak TN12 7NN Benchley Kent | British | 88480180001 | ||||||
| FARADAY, Ian Paul | Geschäftsführer | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | British | 117970910002 | ||||||
| HUTTON, Graham Stuart | Geschäftsführer | Spring Cottage Cranes Road RG24 9JG Sherborne St John Hampshire | England | British | 142062250001 | |||||
| LICKLEY, Gavin Alexander Fraser | Geschäftsführer | 6 Westmoreland Road SW13 9RY London | England | British | 6625070001 | |||||
| MICHIE, William Guthrie Mcgregor | Geschäftsführer | 57 Charterfield Avenue Putney SW15 6HW London | England | British | 10456220001 | |||||
| O'SULLIVAN, Lee Scott | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB Winchester House London United Kingdom | British | 120275570002 | ||||||
| OSBORNE, David Hase | Geschäftsführer | The Manor House Bishops Down Road TN4 8XL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 7602680004 | |||||
| RICHARDS, Christopher Murray | Geschäftsführer | 3 Kidbrooke Grove Blackheath SE3 0PG London | England | British | 92831120001 | |||||
| ROOS, Nicholas Andrew | Geschäftsführer | 2 Claremont Park N3 1TH London | British | 88479620001 | ||||||
| SHORT, John Mayow | Geschäftsführer | Northumberland House 134 New Kings Road SW6 4LZ London | England | United Kingdom | 7117360002 | |||||
| SMITH, Pamela Hindley | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB Winchester House London United Kingdom | British | 38994140002 | ||||||
| THOMAS, Duncan Patrick | Geschäftsführer | Beaumaris Longacre High Street SG17 5LZ Meppershall Bedfordshire | British | 27510460001 | ||||||
| TWIDALE, Peter Gordon | Geschäftsführer | 12 Baymans Wood Shenfield CM15 8BT Brentwood Essex | British | 73077810001 | ||||||
| WILLIAMS, Vaughan | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 33495830005 |
Hat CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| First priority aircraft mortgage | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 28. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become from the company to the security under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first priority legal mortgage all right, title and interest (present and future) in and to the aircraft. By way of first priority legal assignment, all of its right, title and interest (present and future) in and to the assigned property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority deposit charge | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 29. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the original owner and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the right title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority deposit charge | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 29. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the original owner and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the right title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority aircraft mortgage | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 21. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the original mortgagor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and interest (present and future) in and to the aircraft and the assigned property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority aircraft mortgage | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 21. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the original mortgagor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and interest (present and future) in and to the aircraft and the assigned property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority aircraft mortgage | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 18. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right,title and interest in and to the assigned property,as defined; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority aircraft mortgage | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 18. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right,title and interest in and to the assigned property,as defined; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenant | Erstellt am 25. Juli 1983 Geliefert am 27. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing sterling pounds 1,196, 000 and all other monies due or to become due from the company to the chargeon account credit under the terms of theterms of the secerity docs as described in the charge. | |
Kurze Angaben The mortgaged premises being the ship the owners insurances and earnings of the ship as respectively defined in the deed of covenant (see doc M11). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Statutory mortgage | Erstellt am 25. Juli 1983 Geliefert am 27. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a financial agreement dated 31/12/82 an agreement supplemental there to dated 18/2/83 and a deed of covenant dated 25/7/83. | |
Kurze Angaben 64/64 shares in M. V. "beamer" registered at the part of leith under official no 398732 and her boats and appurtenances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenant | Erstellt am 06. Juni 1983 Geliefert am 08. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing sterling pounds 1,196,00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financial agreement montioned in the mortgage dated 6/6/83 and this deed. | |
Kurze Angaben The mortgaged premises, being the ship, the owner's insurances and the earnings of the ship as respectively defined in the deed of covenant (see doc M11). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Statutary mortgage | Erstellt am 06. Juni 1983 Geliefert am 08. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of a financial agreement dated 31/12/82 an agreement supplemental thereto dated 18/2/8O (tog. Known as the financial agreement) and the deed of covenant dated 6/6/83. | |
Kurze Angaben 64/64 shares in m v "seal carr" registered at the port of leith under official no:- 398733. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0