GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED

GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01513465
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WELBECK MARKETING LIMITED11. Feb. 198711. Feb. 1987
    ERNEST JONES FINANCE LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980
    STARKTRAIL LIMITED20. Aug. 198020. Aug. 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2017

    9 SeitenLIQ03

    Beendigung der Bestellung von William James Pearson als Geschäftsführer am 09. Aug. 2017

    1 SeitenTM01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ zum 1 More London Place London SE1 2AF am 25. Juli 2016

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Juni 2016

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Kathryn Mary Coar als Sekretär am 03. Apr. 2016

    1 SeitenTM02

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 29. März 2016

    • Kapital: GBP 2
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account reduced 21/03/2016
    RES13

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MANCHANDA, Anupam
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomIndian196338510001
    BAMBER, Janine Margaret
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    Sekretär
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    British117898690002
    BEATTIE-JONES, Vanessa Avril
    31 Wyndham Road
    KT2 5JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    Sekretär
    31 Wyndham Road
    KT2 5JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    British59539540002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Sekretär
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    COAR, Kathryn Mary
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Sekretär
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    169799600001
    COLLINS, John Wilfred James
    The Barn
    Chithurst Lane Trotton
    GU31 5ET Petersfield
    Hampshire
    Sekretär
    The Barn
    Chithurst Lane Trotton
    GU31 5ET Petersfield
    Hampshire
    British2074480001
    ESSEX, Alicia
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Sekretär
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    154747270001
    EVANS, Fiona Maria
    85 Ravensmede Way
    Chiswick
    W4 1TQ London
    Sekretär
    85 Ravensmede Way
    Chiswick
    W4 1TQ London
    British49259690002
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Sekretär
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    LEE, Tony
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    Sekretär
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    British49293090003
    ODDY, Louise Margaret
    33 Tetcott Road
    SW10 0SB London
    Sekretär
    33 Tetcott Road
    SW10 0SB London
    British56158480001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    Berkeley Square
    W1J 6EW London
    30
    Sekretär
    Berkeley Square
    W1J 6EW London
    30
    British55097590003
    WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Sekretär
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    British85529340001
    ABRAMSON, Christoffer
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Geschäftsführer
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Swedish98463110005
    ALBA-OCHOA, Cristina
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomSpanish172521700001
    BEATTIE-JONES, Vanessa Avril
    31 Wyndham Road
    KT2 5JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    31 Wyndham Road
    KT2 5JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish59539540002
    BENISTY, Maurice
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish94704210003
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Geschäftsführer
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    BURGER, Alec
    3 Adelade Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Adelade Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    British And American83634080006
    CARNEY, Richard
    21 Grasleigh Avenue
    Allerton
    BD15 9AR Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    21 Grasleigh Avenue
    Allerton
    BD15 9AR Bradford
    West Yorkshire
    British3661240001
    COLAO, Daniel Oreste
    Flat 5
    45 Queensgate Gardens
    SW7 5ND London
    Geschäftsführer
    Flat 5
    45 Queensgate Gardens
    SW7 5ND London
    American52890580001
    COLLINS, Mark
    28 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AB London
    Geschäftsführer
    28 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AB London
    British56836220001
    CURTISS, Peter Hugh Bagot
    133 Haliburton Road
    St Margarets
    TW1 1PE Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    133 Haliburton Road
    St Margarets
    TW1 1PE Twickenham
    Middlesex
    British24931180001
    DE BIE, Janet
    70 Franche Court Road
    SW17 0JU London
    Geschäftsführer
    70 Franche Court Road
    SW17 0JU London
    British105858010001
    DE BIE, Janet
    70 Franche Court Road
    SW17 0JU London
    Geschäftsführer
    70 Franche Court Road
    SW17 0JU London
    British105858010001
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    Berkeley Square
    W1J 6EW London
    30
    Geschäftsführer
    Berkeley Square
    W1J 6EW London
    30
    United KingdomBritish93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Geschäftsführer
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    DYSON, Kevin Frederick
    Rose Cottage
    New Pond Hill
    TN21 0LY Cross In Hand
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Rose Cottage
    New Pond Hill
    TN21 0LY Cross In Hand
    East Sussex
    British73861450001
    GATISS, Ian William
    Berkeley Square
    W1J 6EW London
    30
    Geschäftsführer
    Berkeley Square
    W1J 6EW London
    30
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    HOWARD, Mervyn
    5 Park Avenue South
    N8 8LU London
    Geschäftsführer
    5 Park Avenue South
    N8 8LU London
    United KingdomBritish52891020001
    JEVNE, Anne
    26 Amner Road
    SW11 6AA London
    Geschäftsführer
    26 Amner Road
    SW11 6AA London
    Norwegian126577610001
    JOHNSON, Anthony Ian
    3 Cedar Close
    Kingston Vale
    SW15 3SD London
    Geschäftsführer
    3 Cedar Close
    Kingston Vale
    SW15 3SD London
    United KingdomBritish37178270001
    MARFLEET, Thomas
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish139855250001
    MORRISON, Graeme Sutherland Cowan, Mr.
    Thors
    Norrells Drive
    KT24 5DL East Horsley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Thors
    Norrells Drive
    KT24 5DL East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish6379770001

    Hat GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of variation to deed of accession dated 25TH september 1997
    Erstellt am 27. Jan. 1998
    Geliefert am 10. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities and obligations of the company covenanted to be paid or performed by the company or london and bristol securities limited under the security documents (as defined in the loan agreement)
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/a clarence house clarence road avon t/no AV219493 and land at zions road and 51 and 53 clarence road t/no AV184113 AV70380 f/h land and premises k/a 13-23 murray road workington cumbria t/no CU46678 f/h land and premises k/a 17-25 (odd inclusive) friar lane nottingham t/no NT176680 for further details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Second charge
    Erstellt am 26. Sept. 1997
    Geliefert am 09. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other chargors and/or other companies named therein to ge capital corporation (properties) limited on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 61-65 conduit street london t/n NGL698643 and the benefit of all insurances all plant and machinery tehreon the benefit of all licences etc and its rights under the agreement/s relating to the purchase of the property.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Properties) Limited(in Its Capacity as Trustees of the O & H Limited Partnership)
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 26. Sept. 1997
    Geliefert am 09. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other chargors and/or other companies named therein to ge capital corporation funding) limited (as agent and trustee for the finance parties (as defined)) on any account whatsoever under each finance document (as therein defined)
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 61-65 conduit street london t/n NGL698643 the benefit of all insurance all plant and machinery the benefit of all licences etc and all rights under any agreements relating to the purchase of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited(as Agent and Trustee for the Finance Parties (as Defined))
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 14TH october 1997
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 30. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Obligations and liabilities due or to become due from o & h properties limited as the principal debtor under the agreement to transfer £98 loan note of holaw (418) limited dated 25TH september 1997
    Kurze Angaben
    Interest under a lease in the land register of scotland under t/no: gla 71292 of subjects forming harmony court, helen street, govan glasgow.
    Berechtigte Personen
    • G E Capital Corporation (Properties) Limited
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of restatement
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 09. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the securities (as defined)
    Kurze Angaben
    The legal estate in the property the benefit of each and all personal covenants under the occupational leases the copyrights of any plans in connection with any development of the property the implied licence in any such plans the benefit of the contracts bonds and appointments the benefits of all guarantees and warranties all rents and by way of floating charge all assets property and undertaking present and future including goodwill and incalled capital see form 395 for full details of charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited(the Assignee)
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of restatement
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 09. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys which are now or shall at any time hereafter be due,owing or payable,or expressed to be due,owing or payable to the chargee from or by the depositor and/or the company,under or in respect of the securities together with all legal and other costs,charges and expenses which the chargee may incur in enforcing or obtaining,or attempting to enforce or obtain paymnet of any such monies
    Kurze Angaben
    All respective rights titles benefits and interest in and to the deposit please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited(the Assignee)
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Second legal charge created by the company in its capacity as trustee for the partners in the blythe limited partnership dated
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 08. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities and obligations of o & h properties limited (the principal debtor) covenanted to be paid or performed by the principal debtor to the chargee under the agreement to transfer a £98 loan note of holaw (418) limited dated 26TH september 1997
    Kurze Angaben
    L/H land and premises k/a 41-43 st james parade bath l/h land and premises k/a hilton house lord street stockport t/no GM338505 l/h property k/a 89-101 (odd) hampstead road london t/no NGL628766 and l/h property k/a 389-393 (odd) hoe street leyton walthamstow by way of fixed charge the copyright the implied licence the benefit of the contracts and a floating charge the undertaking and assets and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Trading LP) Limited
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First supplemental charge
    Erstellt am 06. März 1996
    Geliefert am 27. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured liabiities due to the chargee as defined in the credit agreement dated 15 march 1994 made between the halogic limited partnership acting by its general partner halogic (gp) limited and the chargee
    Kurze Angaben
    All that f/h land to be acquired by the borrower (as defined in the credit agreement) pursuant to the terms of the land swap agreement dated 6 march 1996. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Imry Property Holdings Limited
    Transaktionen
    • 27. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 06. März 1996
    Geliefert am 22. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the halogic limited partnership (the company as limited partner and halogic (gp) limited as general partner) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of the account with the bank. The halogic limited partnership gts bid deposit in the amount of £112,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First supplemental charge
    Erstellt am 06. März 1996
    Geliefert am 22. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the halogic limited partnership (the company as the limited partner and halogic (gp) limited as the general partner) to the chargee under the finance documents other than the guarantee
    Kurze Angaben
    All plant machinery and its interest in any plant or machinery all money in respect of any insurances and all sums standing to the credit of the insurance account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 06. März 1996
    Geliefert am 21. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to becoem due from the company and/or halogic (gp) limited to the chargee under the terms of the supplemental loan agreement dated 6 march 1996 or the charging instruments
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the new land; by way of legal mortgage the properties; fixed charge over all monies from time to time standing to the credit of the insurance account; first fixed equitable charge over all estates and interests in land or rights to acquire the same acquired by the borrower after the date of the charge; ......... see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 21. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security
    Erstellt am 12. Mai 1995
    Geliefert am 18. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from o & h properties limited as general partner and as such trustee for the o & h limited partnership to the chargee in terms of personal bond dated 5TH may 1994 or any variation or alteration thereof
    Kurze Angaben
    A lease between the city of glasgow district council and beazer developments limited in respect of harmony court,helen street,govan,glasgow title number gla 71292. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 18. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security
    Erstellt am 12. Mai 1995
    Geliefert am 18. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from o & h properties limited as general partner of and as trustee for the o & h limited partnership to the chargee in terms of clause 10 of the deed of limited partnership entered into on 3RD may 1994 (as amended from time to time)
    Kurze Angaben
    Lease between the city of glasgow district council and beazer developments limited in respect of harmony court,helen street,govan,glasgow title number gla 71292. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Properties) Limited
    Transaktionen
    • 18. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignation
    Erstellt am 25. Apr. 1995
    Geliefert am 29. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from o & h properties limited as general partner and trustee for the o & h limited partnership to the chargee in terms of a personal bond dated 5TH may 1994 or any variation or alteration thereof
    Kurze Angaben
    The rents income and any other payments of harmony court helen street glasgow (GLA71292) pursuant to the leases defined in the charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security
    Erstellt am 11. Jan. 1995
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become to ge capital corporation (funding) limited by o & h properties limited as general partner and as such trustees for the o & h limited partnership in terms of personal bond by o & h properties limited as general partner and trustees in favour of ge capital corporation (funding) limited dated 5TH may 1994 or any variation thereof
    Kurze Angaben
    Sub-lease by electrolux limited in favour of prudential pensions limited................in relation to westfield industrial estate,cumbernauld; t/no.dmb 31522. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security (as defined)
    Erstellt am 11. Jan. 1995
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities incumbent on o & h properties limited as general partner of and as such trustee for the o & h limited partnership in terms of clause 10 of the deed of limited partnership entered into on 3RD may 1994 (as defined)
    Kurze Angaben
    Sub-lease by electrolux limited in favour of prudential pensions limited..........................in respect of four deerykes place,westfield industrial estate,cumbernauld; t/no.dmb 31522. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Properties) Limited
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security (as defined)
    Erstellt am 29. Dez. 1994
    Geliefert am 05. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities incumbent on o & h properties limited as general partner of and as such trustee for the o & h limited partnership in terms of clause 10 of the deed of limited partnership entered into on 3RD may 1994 between o & h properties limited,ge capital corporation (properties) limited and o & h holdings limited (as amended from time to time)
    Kurze Angaben
    Four deerdykes place,westfield industrial estate,cumbernauld lying on the south side deerdykes place.............t/no.dmb 31523.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Properties) Limited
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security (as defined)
    Erstellt am 29. Dez. 1994
    Geliefert am 05. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due from o & h properties limited as general partner and as such trustee for the o & h limited partnership in terms of personal bond by o & h properties limited as general partner and trustee in favour of the chargee dated 5TH may 1994 or any variation thereof
    Kurze Angaben
    Four deerdykes place,westfield industrial estate,cumbernauld lying to the south side of deerdykes place.........t/no.dmb 31523.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed
    Erstellt am 05. Okt. 1994
    Geliefert am 26. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the chargor (or of any entity of which it is comprised, including the borrower) to the bank under each of the finance documents to which the chargor (or any such entity ) is or will be a party together with all costs charges expenses incurred by the bank in the protection, preservation and enforcement of its respective rights under the finance documents (other than under the guarantee) and excluding, in each case, any obligation or liability which, if it were included, would result in the charge or the supplemental deed contravening section 151 of the companies act 1985. the term "finance document" includes all amendments and supplements
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed
    Erstellt am 05. Okt. 1994
    Geliefert am 24. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    And amending the charge dated 25TH march 1994 as defined in the deed
    Kurze Angaben
    The property as defined in the charge dated 25TH march 1993.
    Berechtigte Personen
    • Imry Property Holdings Limited
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed of agreement (as defined)
    Erstellt am 05. Okt. 1994
    Geliefert am 19. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower (as defined in the deed) to the chargee under the loan agreement or the charging documents (as defined) and this deed (being supplemental to a charge dated 25TH march 1994) with ge capital corporation (properties) limited acting in its capacity as limited partner of the halogic limited partnership (a limited partnership formed under the limited partnerships act 1907)
    Kurze Angaben
    See under clause 3 of the deed being properties numbered 2 to 77 together with all buildings erections fixtures fittings and fixed plant and machinery for the time being belonging to the tenants and all improvements and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed (as defined)
    Erstellt am 05. Okt. 1994
    Geliefert am 14. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the assignor and the borrower (both as defined) to the chargee under the terms of the loan agreement dated 15TH march 1994 (as defined) and this deed
    Kurze Angaben
    Under clause 3 of the deed,all secured sums and all rights,title and interest in and to the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed (as defined)
    Erstellt am 05. Okt. 1994
    Geliefert am 14. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the assignor and the borrower (both as defined) to the chargee under the terms of any finance document (as defined) or this deed
    Kurze Angaben
    Under clause 3 of the deed,all secured sums and property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 07. Juni 1994
    Geliefert am 27. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and halogic (gp) limited to the chargee as defined in the £3,955,000 credit facility agreement dated 15 march 1994 and this charge
    Kurze Angaben
    All that l/h property shortly k/a quarry lane industrial estate chichester west sussex. All present and future estates or interests in any f/h or l/h property. Fixed charge on all monies standing to the credit of any account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Imry Property Holdings Limited
    Transaktionen
    • 27. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental charge
    Erstellt am 07. Juni 1994
    Geliefert am 16. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or halogic (gp) limited to the chargee under the terms of each of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    L/Hold land known as quarry lane industrial estate,chichester,west sussex with all buildings and fixtures; all proceeds of sale and the benefit of any covenants.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat GE CAPITAL CORPORATION (PROPERTIES) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Juni 2016Beginn der Liquidation
    17. Jan. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0