KINGSLEY CARDS LTD.
Überblick
| Unternehmensname | KINGSLEY CARDS LTD. |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01513540 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KINGSLEY CARDS LTD.?
- (2222) /
Wo befindet sich KINGSLEY CARDS LTD.?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg Llp 1 The Embankment LS1 4DW Neville Street Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KINGSLEY CARDS LTD.?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KINGSLEY CARDS (1980) LIMITED | 31. Dez. 1980 | 31. Dez. 1980 |
| TRAILPANE LIMITED | 21. Aug. 1980 | 21. Aug. 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KINGSLEY CARDS LTD.?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2006 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Jan. 2007 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 03. Okt. 2004 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für KINGSLEY CARDS LTD.?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 09. Mai 2017 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 23. Mai 2017 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KINGSLEY CARDS LTD.?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für KINGSLEY CARDS LTD.?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Andrew Robert Ferguson als Geschäftsführer am 03. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||
Adresse des Geschäftsführers Mr Andrew Robert Ferguson geändert auf 01513540 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH am 17. Okt. 2024 | 1 Seiten | RP09 | ||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 21 Seiten | 2.35B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Okt. 2008 | 21 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Apr. 2008 | 23 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 24 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator | 6 Seiten | 2.39B | ||
Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators | 1 Seiten | 2.40B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 24 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 22 Seiten | 2.24B | ||
Vorschlag des Verwalters | 41 Seiten | 2.17B | ||
Vermögensübersicht | 32 Seiten | 2.16B | ||
legacy | 7 Seiten | 395 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Wer sind die Geschäftsführer von KINGSLEY CARDS LTD.?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEEDHAM, Phillip Geoffrey | Geschäftsführer | Scatterford Farm Newland GL16 8NG Coleford Gloucestershire | British | 101206970001 | ||||||
| REEVES, William Thomas | Geschäftsführer | 3 The Coppins Wildwood ST17 4QB Stafford Staffordshire | British | 93316550001 | ||||||
| EDWARDS, John | Sekretär | Rectory View Pinfold Lane WF14 9JA Mirfield West Yorkshire | British | 3313700002 | ||||||
| MARTIN, Ben Andrew Douglas | Sekretär | 11 Lynton Grove Bradshaw HX2 9XN Halifax West Yorkshire | British | 97649410001 | ||||||
| MASON, Roger Malcolm | Sekretär | 1 Reddings Close Wendover HP22 6LG Aylesbury Buckinghamshire | British | 28112130001 | ||||||
| PARSLOE, Vivienne Dorothy | Sekretär | Twin Peaks 20 New Road Marlow Bottom SL7 3NG Marlow Buckinghamshire | British | 28112120002 | ||||||
| SWATTEN, John David | Sekretär | 32 The Quays Concordia Street LS1 4ES Leeds West Yorkshire | British | 71001660002 | ||||||
| BAKER, Robin Martin | Geschäftsführer | The Old Priory Priest Bank Road, Kildwick BD20 9AE Keighley Yorkshire | England | British | 89594350001 | |||||
| BOTTOMLEY, Jeffrey | Geschäftsführer | Le Roccabella Avenue Princess Grace Mc 9800 Monaco | British | 71282090002 | ||||||
| BUSZARD, Fiona Patricia | Geschäftsführer | 30 Wellington Street OX9 3BN Thame Oxfordshire | British | 75161960001 | ||||||
| CARTER, Alan Leslie | Geschäftsführer | 5 Gateway Harden BD16 1TG Bingley West Yorkshire | British | 68381900002 | ||||||
| CARTER, Nicholas Michael | Geschäftsführer | Laverton House Laverton WR12 7NA Broadway Worcs | England | British | 120830070001 | |||||
| EDWARDS, John | Geschäftsführer | Rectory View Pinfold Lane WF14 9JA Mirfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 3313700002 | |||||
| FERGUSON, Andrew Robert | Geschäftsführer | 4385 CF14 8LH Cardiff 01513540 - Companies House Default Address | England | British | 116262420001 | |||||
| FIELDING, Michael | Geschäftsführer | 6 Hanover Terrace Regents Park NW1 4RJ London | England | British | 35062150001 | |||||
| HOLMES, Christopher | Geschäftsführer | 2 George Harrison Close L6 9HU Liverpool Merseyside | British | 68381930001 | ||||||
| LEWIS, Glenn Ian | Geschäftsführer | 1 Ormond Place NN14 1JL Isham Northamptonshire | Great Britain | British | 45713490001 | |||||
| MARSHALL, Geoffrey Richard | Geschäftsführer | The Coach House 19 St Marys Road KT6 5EU Long Ditton Surrey | British | 96978850001 | ||||||
| MASON, Roger Malcolm | Geschäftsführer | 1 Reddings Close Wendover HP22 6LG Aylesbury Buckinghamshire | British | 28112130001 | ||||||
| MURGATROYD, Carl Richard | Geschäftsführer | 5 Stone Cottage Aireview Sandbeds BD20 5LH Keighley West Yorkshire | British | 71110540001 | ||||||
| NAYLOR, Ian | Geschäftsführer | 3 Penfold Court Hellifield BD23 4LW Skipton North Yorkshire | British | 113327610001 | ||||||
| NICHOLLS, Graham Edwin | Geschäftsführer | 17 Middlebeck Drive Arnold NG5 8AL Nottingham Nottinghamshire | England | British | 127794570001 | |||||
| ORMSTON, Julie Lawson | Geschäftsführer | Tamlynn 8 Overdale Grange BD23 6AG Skipton North Yorkshire | British | 28112160002 | ||||||
| ORR, David Malcolm | Geschäftsführer | Leeward 5 Townsend Reach Wharf Lane SL8 5RH Bourne End Buckinghamshire | England | British | 106181020001 | |||||
| PARSLOE, Vivienne Dorothy | Geschäftsführer | Twin Peaks 20 New Road Marlow Bottom SL7 3NG Marlow Buckinghamshire | British | 28112120002 | ||||||
| PHIPPS, Brian William | Geschäftsführer | Saintbury Grounds Farm Weston Road WR11 7QA Evesham Worcestershire | United Kingdom | British | 74725980004 | |||||
| SWATTEN, John David | Geschäftsführer | 32 The Quays Concordia Street LS1 4ES Leeds West Yorkshire | British | 71001660002 |
Hat KINGSLEY CARDS LTD. Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Erstellt am 27. Apr. 2006 Geliefert am 12. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The secured assets being the stock defined in a business and asset sale agreement,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 28. Sept. 2005 Geliefert am 30. Sept. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £500,000 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben The goods being 1 nsf thermo foil stamping press serial no 0008, 1 orwak model 5031 bailing machine serial no 8232756, 1 winkler and dunnebier type 81333 inserting machine serial no 12453 (1996) with compaq evo personal computer and associated equipment, for details of further goods charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Juli 2005 Geliefert am 26. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee and the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 16. Okt. 2003 Geliefert am 23. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £500,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 x winkler and dunnebier type 81333 inserting machine, serial no. 12453 6) with compaq evo personal computer, monitor, keyboard and mouse and associated equipment, 1 x longford model cf 200-5 folding machine, serial no. 1304-82, 1 x heidelberg type gtp creasing and foiling press, serial no. GTP67163E together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books, manuals, handbooks, technical data, drawings, schedules and other documentation (or any amendments to them). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Mai 2003 Geliefert am 07. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £453,222 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The kora packmat machine VRM25 (s/no 2661 & 2662) and kora packmat machine VFM102 (s/n 2654 & 2655) together with all accessories and component parts and all improvements and renewals books manuals and all other documentation. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 09. Mai 2000 Geliefert am 19. Mai 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property mortaged or charged including; schneider type senator model 155MCV paper guillotine serial no 60720 Õ1988! complete with air tables; schneider type senator model 155MC2 paper guillotine serial no 60640 Õ1985! complete with air tables; 2 x splek type SL32-500 pallet hoists serial no 930 Õ1988! & 931 Õ1988!. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 09. Mai 2000 Geliefert am 19. Mai 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property mortgaged or charged including; envetron damping roller washer; magnavac air systems selvedge extraction system Õ1994! comprising extraction fan & ducting; 4 x printing trade services bottom numbering units Õ1 each on assets 40,41,42 above plus 1 spare!. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 02. Okt. 1986 Geliefert am 03. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All & singular the chattels plant & machinery & items described in the schedule on reverse of form 395 dated 3/10/86. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Sept. 1986 Geliefert am 07. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £556,350.17 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben By way of floating charge over all the undertaking and property whatsoever and wheresoever of the company both present and future including its uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Okt. 1985 Geliefert am 07. Nov. 1985 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Dez. 1983 Geliefert am 07. Dez. 1983 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings at skipton, north yorkshire being or known as belle vue mills. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge was registered pursuant to an order of court dated 7/5/82 | Erstellt am 23. Dez. 1981 Geliefert am 08. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H catsbrain farm, oakley. Buckinghamshire. Title no. Bm 42113. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Apr. 1981 Geliefert am 15. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H fieth mills, fieth street, skipton north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Okt. 1980 Geliefert am 28. Okt. 1980 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat KINGSLEY CARDS LTD. Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0