CFK INSURANCE SERVICES LIMITED

CFK INSURANCE SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCFK INSURANCE SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01514532
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CFK INSURANCE SERVICES LIMITED?

    • (6603) /

    Wo befindet sich CFK INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CFK INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COLBURN, FRENCH & KNEEN (INSURANCE SERVICES) LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980
    C.F. & K. (INSURANCE SERVICES) LIMITED28. Aug. 198028. Aug. 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CFK INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für CFK INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 6 Crutched Friars London EC3N 2PH am 11. Okt. 2011

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Sept. 2011

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 31. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 152.5
    SH01

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    14 SeitenAA

    Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft

    1 SeitenDS02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Colla am 06. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    12 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von CFK INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HICKMAN, David James
    Prospect Cottage
    Well Hill
    BR6 7PR Old Chelsfield
    Kent
    Sekretär
    Prospect Cottage
    Well Hill
    BR6 7PR Old Chelsfield
    Kent
    British6838480003
    COLLA, Richard
    Crutched Friars
    EC3N 2PH London
    6
    England
    Geschäftsführer
    Crutched Friars
    EC3N 2PH London
    6
    England
    BritishInsurance Broker31320330001
    HICKMAN, David James
    Prospect Cottage
    Well Hill
    BR6 7PR Old Chelsfield
    Kent
    Geschäftsführer
    Prospect Cottage
    Well Hill
    BR6 7PR Old Chelsfield
    Kent
    United KingdomBritishCompany Secretary6838480003
    NEWELL, Mark Verity
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    Sekretär
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    British77855100001
    RAMSDALE, Anthony James
    Sweet Meadows Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    Sekretär
    Sweet Meadows Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    British4458710001
    BUCKLEY SHARP, Ian
    2 Gordon Place
    W8 4JD London
    Geschäftsführer
    2 Gordon Place
    W8 4JD London
    BritishInsurance Broker3745120001
    CARDOZA, Noel Adrian Frank
    133 Petersham Road
    TW10 7AA Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    133 Petersham Road
    TW10 7AA Richmond
    Surrey
    BritishInsurance Broker24170240001
    DONOVAN, Terence James
    Coppins The Retreat
    Hutton
    CM13 1AN Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Coppins The Retreat
    Hutton
    CM13 1AN Brentwood
    Essex
    BritishInsurance Broker5303780001
    FOX, Simon Nicholas
    19 Marine Avenue
    SS9 2JD Leigh On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    19 Marine Avenue
    SS9 2JD Leigh On Sea
    Essex
    BritishInsurance Broker24170260001
    HODGES, John Alfred
    48 Medway Crescent
    SS9 2UY Leigh-On-Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    48 Medway Crescent
    SS9 2UY Leigh-On-Sea
    Essex
    BritishDirector37979180001
    RAMSDALE, Anthony James
    Sweet Meadows Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Sweet Meadows Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    BritishInsurance Broker4458710001
    REEDS, Alfred Ernest
    3 Hampshire Close
    N18 2LG London
    Geschäftsführer
    3 Hampshire Close
    N18 2LG London
    BritishInsurance Broker3745130001
    WILLIAMS, Ralph Frederick Nelson
    150 Hillcrest
    Bar Hill
    CB3 8TH Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    150 Hillcrest
    Bar Hill
    CB3 8TH Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishInsurance Broker5303800001
    WILSON, Gordon
    69 Hyde Road
    Sanderstead
    CR2 9NS South Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    69 Hyde Road
    Sanderstead
    CR2 9NS South Croydon
    Surrey
    BritishInsurance Broker24170250001

    Hat CFK INSURANCE SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over credit balances
    Erstellt am 30. Nov. 1994
    Geliefert am 05. Dez. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to 5 guarantees all in favour of the society & council of lloyds for £25,000, £4,363, £12,936, £10,321 and £12,469
    Kurze Angaben
    The sum of £66,000 together with interest held by the bank on account no. 7640226 and designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 16. Apr. 1993
    Geliefert am 26. Apr. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £92,000 together with interest accrued now or to be held by the chargee on an account numbered 7640226 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Charge over credit balance
    Erstellt am 29. Okt. 1991
    Geliefert am 08. Nov. 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to guarantees to the society and council of lloyds in respect of membership deposit of:ralph frederick nelson williams for £22,500 dated 22/12/89 richard colla for £25,000 dated 25/10/91 simon nicholas fox for £15,000 dated 25/10/91 roger alan mills for £25,000 dated 25/10/91
    Kurze Angaben
    The sum of £88,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 7640226 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Charge over credit balance
    Erstellt am 29. Juni 1990
    Geliefert am 13. Juli 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee to the society and council of lloyds in respect of membership deposit of ralph williams
    Kurze Angaben
    The sums of £22,500 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account no 4910745 & earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 07. Sept. 1984
    Geliefert am 18. Sept. 1984
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee between national westminster bank PLC and the society and council of lloyds in respect of allan geoffrey powel.
    Kurze Angaben
    £15,000 together with interest accrued held by the bank on an account in the name of the bank earmarked re:- the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Charge over credit balance
    Erstellt am 07. Sept. 1984
    Geliefert am 18. Sept. 1984
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee between national westminster bank PLC and the council and society of lloyds in respect of ralph williams.
    Kurze Angaben
    £15,000 together with interest held by the bank on an account in the name of the bank and earmarked re:- the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Charge over credit balance
    Erstellt am 05. Jan. 1984
    Geliefert am 25. Jan. 1984
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to guarantee between national westminster bank PLC and the society and council of lloyds in respect of richad colla
    Kurze Angaben
    The sum of £15000 together with interest held by the bank on an account in the name of the bank and earmarked re the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)

    Hat CFK INSURANCE SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Sept. 2011Beginn der Liquidation
    28. Sept. 2012Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0