TLLC HOTELS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TLLC HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01526187 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TLLC HOTELS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich TLLC HOTELS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TLLC HOTELS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRAVELODGE LIMITED | 07. Mai 2002 | 07. Mai 2002 |
| GALLEON WORLD TRAVEL LIMITED | 31. Dez. 1980 | 31. Dez. 1980 |
| GALLEON WORLD TRAVEL ASSOCIATION LIMITED | 03. Nov. 1980 | 03. Nov. 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLLC HOTELS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TLLC HOTELS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 22. Apr. 2010
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 12. Mai 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 17 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Guy Paul Cuthbert Parsons am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Victor Harvey am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Jon William Mortimore am 03. Feb. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jon William Mortimore am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Grant David Hearn am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed travelodge LIMITED\certificate issued on 06/12/06 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TLLC HOTELS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTIMORE, Jon William | Sekretär | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | British | 93906210001 | ||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| HARVEY, Paul Victor | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 116809270002 | |||||
| HEARN, Grant David | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | England | British | 88628480002 | |||||
| MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 93906210001 | |||||
| PARSONS, Guy Paul Cuthbert | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 102187770002 | |||||
| EVANS, Fiona Maria | Sekretär | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| HICKS, Christopher Michael | Sekretär | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| JACKSON, Kevin David | Sekretär | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | British | 141586330001 | ||||||
| MASON, Timothy Charles | Sekretär | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
| MATHEWS, Benedict John Spurway | Sekretär | 39 Lower Teddington Road KT1 4HQ Hampton Wick Flat 3 Surrey | British | 42217530001 | ||||||
| OSBORNE, Sarah Louise | Sekretär | Flat 4 75 Madeley Road Ealing W5 2LT London | British | 45501330001 | ||||||
| SIMS, Roy John Peter | Sekretär | 6 Star Hill Drive Churt GU10 2HP Farnham Surrey | British | 12396130001 | ||||||
| SMALL, Jeremy Peter | Sekretär | Cherry Trees West Heath GU24 0JQ Pirbright Surrey | British | 67168210001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Sekretär | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||
| FORTE NOMINEES LIMITED | Sekretär | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42198970001 | |||||||
| CLAYTON, Peter Grattan | Geschäftsführer | 17 Coltbridge Gardens EH12 6AQ Edinburgh | Scotland | British | 82843350001 | |||||
| EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Geschäftsführer | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 49678170001 | |||||
| GIANNUZZI, Alfonso | Geschäftsführer | Apartment 68 New River Head 173 Rosebery Avenue EC1R 4UN London | British | 86128310001 | ||||||
| HEARN, Alan John | Geschäftsführer | Tylecroft 29 Woodchester Park Knotty Green HP9 2TU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 13648200003 | ||||||
| HEARN, Alan John | Geschäftsführer | Tylecroft 29 Woodchester Park Knotty Green HP9 2TU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 13648200003 | ||||||
| HEARN, Dennis | Geschäftsführer | Bishops Platt Norlands Lane TW20 8SS Thorpe Surrey | British | 51334350001 | ||||||
| HICKS, Christopher Michael | Geschäftsführer | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| JACKSON, Kevin David | Geschäftsführer | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | England | British | 141586330001 | |||||
| LOVETT, Norman | Geschäftsführer | 25 Balmoral Way Belmont Surrey | British | 49941610001 | ||||||
| MILLS, John Michael | Geschäftsführer | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
| STEVENS, David John | Geschäftsführer | 42 Burghley Road Wimbledon SW19 5HN London | British | 56704240001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Geschäftsführer | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | 37564540001 | |||||
| TURL, Simon Charles | Geschäftsführer | Arden House Eastwell Road LE14 4SS Scalford Leicestershire | British | 80261230001 | ||||||
| TURNER, Harry | Geschäftsführer | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | 166789700001 | |||||
| FORTE (UK) LIMITED | Geschäftsführer | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42204690001 | |||||||
| TRAVELREST SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park Rubery B45 9PZ Birmingham West Midlands | 42204690005 |
Hat TLLC HOTELS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security registered pursuant to an order of court dated 13/12/84 | Erstellt am 25. Juli 1984 Geliefert am 02. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 369/371 sauchiehall street, glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 1983 Geliefert am 10. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben And various property see doc m 33.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Juni 1983 Geliefert am 15. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold, office and shops, 17 nelson street, bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Registered pursuant to a statutory declaration dated 3/3/83 legal mortgage | Erstellt am 07. März 1983 Geliefert am 12. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H. 85 long street, maidstone kent. Title no. K401149. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. März 1983 Geliefert am 12. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H office & shop. 10, shambles square, manchester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. März 1983 Geliefert am 12. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H office & shop 45, cathedral place, london EC42 7PB title no. Ngl 161299. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 07. März 1983 Geliefert am 12. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H office & shop 148, high street, gillingham kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standared security present for registration at the register of sasines on 7TH may 1982. | Erstellt am 05. Apr. 1982 Geliefert am 15. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a bond dated 5TH april 1982 | |
Kurze Angaben Premises at dollar, clackmannan & kinross, scotland. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration at the register of sasines the 12 april 1982 | Erstellt am 05. Apr. 1982 Geliefert am 22. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 5TH april 1982. | |
Kurze Angaben Highland hotel, fort william, inverness-shire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 15. März 1982 Geliefert am 23. März 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Feb. 1982 Geliefert am 09. März 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. März 1981 Geliefert am 07. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H. gogarth abbey hotel, llandudno, gwynedd. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, st. Andrews, convalescent home, folkestone, kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, foxholes, bell vue crescent, southbourne, bournemouth, dorset. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, grand hotel, swanage, dorset. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, the priory of st. Helens, isle of wight. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, overmead hotel, daddyhole road, torquay. Devon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land adjoining church path, bude, cornwall. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, underscar, keswick, cumberland. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, efford down hotel, bude, cornwall. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land adjoining the priory st helens, isle of wight. Title no hp 5859. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 19. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, land on the south side of priory drive, st. Helens, isle of wight title no. Hp 5861. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0