FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED

FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01528153
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Cedars
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    Kent
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PSB PROPERTY LIMITED04. Feb. 198804. Feb. 1988
    PSB PROPERTY & HOLDINGS LIMITED 14. Nov. 198014. Nov. 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Matthew Parkinson am 17. Sept. 2022

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    4 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Wellington House Church Road Ashford Kent TN23 1RE zum The Cedars Church Road Ashford Kent TN23 1RQ am 05. Okt. 2021

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of Hr Go Plc as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    1 SeitenPSC02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARKINSON, John Matthew
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    The Cedars
    Kent
    England
    Sekretär
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    The Cedars
    Kent
    England
    191004000001
    PARKINSON, John Matthew
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    The Cedars
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    The Cedars
    Kent
    England
    EnglandBritish149699140014
    BARROW, Roderick Guy
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Sekretär
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    191001810001
    BILLOT, Hugh Edward, Dr
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Sekretär
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    176961960001
    BROWN, Pamela Joy
    4 Brownhill Close
    Walderslade
    ME5 0NN Chatham
    Kent
    Sekretär
    4 Brownhill Close
    Walderslade
    ME5 0NN Chatham
    Kent
    British11416970001
    HARRIS, Jeremy Paul
    3 Pine Grove
    ME14 2AJ Maidstone
    Kent
    Sekretär
    3 Pine Grove
    ME14 2AJ Maidstone
    Kent
    British53556560001
    KINGSTON, Mark Andrew
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Sekretär
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    British129202050001
    PRIOR, Anthony Edward
    The Cedars
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    Kent
    Sekretär
    The Cedars
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    Kent
    British79649720001
    BILLOT, Hugh Edward, Dr
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    United KingdomBritish39608830001
    HARRIS, Jeremy Paul
    3 Pine Grove
    ME14 2AJ Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    3 Pine Grove
    ME14 2AJ Maidstone
    Kent
    British53556560001
    HARVEY, Christopher Robert
    Dunn Street Road
    ME7 3LX Bredhurst
    Forge Cottage
    Kent
    Geschäftsführer
    Dunn Street Road
    ME7 3LX Bredhurst
    Forge Cottage
    Kent
    EnglandBritish22869490002
    PARKINSON, Betty
    23 The Lawns
    Uplands Roads
    CM14 5AW Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    23 The Lawns
    Uplands Roads
    CM14 5AW Brentwood
    Essex
    British11416500005
    PARKINSON, John Charles
    Foley Farm Barn
    Leeds
    ME17 1RR Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    Foley Farm Barn
    Leeds
    ME17 1RR Maidstone
    Kent
    EnglandBritish100175830001
    PRIOR, Anthony Edward
    The Cedars
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    The Cedars
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    Kent
    British79649720001
    VIDLER, Craig Gordon
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    EnglandBritish190948090001
    YOUNG, Paul James
    South Winchcombe Manor
    Crundale
    CT4 7EW Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    South Winchcombe Manor
    Crundale
    CT4 7EW Canterbury
    Kent
    British56375140001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Hr Go Plc
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Wellington House
    England
    06. Apr. 2016
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Wellington House
    England
    Nein
    RechtsformPlc Company
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat FOLEYBROOK PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2006
    Geliefert am 27. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 112 king street ramsgate kent t/n K167668. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 39 passey place eltham greenwich t/n 278816. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 41 passey place eltham greenwich t/n 280043. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 69 balmoral road gillingham kent t/n K611243. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 12 and 14 highfield road dartford kent t/nos K595651 & K598512. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 45 high street chatham kent t/n K472972. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 1 middle row maidstone kent t/n K170250. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Sept. 1991
    Geliefert am 03. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    69 balmoral road, gillingham, kent, title no k 611243.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 29. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Sept. 1991
    Geliefert am 03. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    112 king street, ramsgate, kent. Title no k 167668.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 29. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juli 1988
    Geliefert am 04. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    16 hythe street, dartford, kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 29. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Nov. 1987
    Geliefert am 12. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1987Registrierung einer Belastung
    • 08. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 24. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Nov. 1986
    Geliefert am 17. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4/6 london bridge street london SE1 title no. Ln 51432 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Nov. 1986
    Geliefert am 17. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    39/41 passey place eltham london SE9 title no's 278816 & 280043 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. März 1985
    Geliefert am 26. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/hold and l/hold propertes and/or the proceeds of sale fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts the benefit of any licences. And/or the proceeds of sale legal mortgage over various properties all situate in kent and listed on doc. M12.(please see doc. M12 for details).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1984
    Geliefert am 11. Juni 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold 15, castle street, dover, kent, title no. K2583509.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1984
    Geliefert am 11. Juni 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold 1 middle row, maidstone kent. Title no K170250.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 1983
    Geliefert am 07. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold the cedars, church road, ashford,kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 24. Feb. 1983
    Geliefert am 03. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold 2 parks street, ashford, kent title no. K487122.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. März 1983Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0