NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNM LIFE RESIDENTIAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01530074
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GE LIFE RESIDENTIAL LIMITED18. Okt. 199918. Okt. 1999
    STALWART RESIDENTIAL LIMITED22. Nov. 199422. Nov. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Windsor House Telford Centre Telford Shropshire TF3 4NB zum 30 Finsbury Square London EC2P 2YU am 22. Aug. 2014

    2 SeitenAD01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Windsor House Telford Centre Telford TF3 4NB geändert

    2 SeitenAD02

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 29. Mai 2014

    • Kapital: GBP 721,874
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    13 SeitenAA

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Beschlüsse

    Resolutions
    25 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Auth to allot shares & duty to avoid conflicts of interest 24/06/2013
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Minimum number of directors is one 24/06/2013
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    5 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Roger Craine als Geschäftsführer am 04. Okt. 2010

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Michael Charles Woodcock als Direktor am 04. Okt. 2012

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Roger Craine am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHAKESPEARE, Paul
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Sekretär
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    British135096740002
    WOODCOCK, Michael Charles
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Geschäftsführer
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritishAccountant102653720001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Sekretär
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    BritishLawyer150997870001
    CHAMBERS, Mark Richard
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    Sekretär
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    British69321020002
    DUGGAN, Helen
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    Sekretär
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    BritishSolicitor67744330001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Sekretär
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British14453100001
    HARDING, Barrington Howard
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    Sekretär
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    British11466730001
    OPPAL, Abdul Munem
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    Sekretär
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    British116338770001
    PEARSON, Michael Adrian
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    Sekretär
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    BritishSolicitor59751140001
    TEMPLETON, William James, Dr
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    Sekretär
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    New ZealanderChartered Accountant27024160001
    THOMAS, Derek John
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    Sekretär
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British2297010001
    WELCH, Gaynor Jill
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    Sekretär
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    BritishCompany Secretary87931760001
    ARTHUR, Richard
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    Geschäftsführer
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    BritishInvestment Director71058650001
    BARRETT, Peter
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    Geschäftsführer
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    BritishManager75515090001
    BARTLETT, John Leonard
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    BritishConsultant14120450001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishLawyer150997870001
    BOUSFIELD, Clare Jane
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Geschäftsführer
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    SwitzerlandBritishCompany Director106900580001
    CARROLL, Timothy Joseph
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Geschäftsführer
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkIrishDirector63716360005
    COWDERY, Clive Adam
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Geschäftsführer
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    BritishChief Executive88183990001
    CRAINE, Roger
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    United KingdomBritishAccountant89585440001
    DAVIES, Roger William
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    BritishActuary21933520001
    DICKINSON, Stephen
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director14120430001
    DOLFI, Douglas Scott
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    Geschäftsführer
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    AmericanDirector78292660001
    DOWNEY, Paul Martin
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    BritishActuary10360260002
    EVANS, David Thomas James
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector62761080001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    BritishActuary14453100001
    GIRLING, Michael
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    BritishSales Director63304110001
    HAMMOND, Anthony
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    BritishOperations Director52752380001
    HAYNES, Stephen Robert
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishDirector79961770002
    HOWE, Robert William Albert
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Geschäftsführer
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkBritishGroup Chief Actuary13105310003
    HUGHFF, Victor William
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    BritishActuary6622110001
    MCLAY, William Morrison
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    Geschäftsführer
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    BritishSales Manager54996780001
    MORGAN, Christopher
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    Geschäftsführer
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    United KingdomBritishCompany Director33875890001
    NARRAWAY, Nicholas William
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    BritishSolicitor72113010001
    RAAB, Dennis Lynn
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    AmericanFinance Director48186120003

    Hat NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 21. März 1997
    Geliefert am 09. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 24TH march 1995
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 5 wantage road, reading berkshire; f/h property k/a 3 wantage road, reading, berkshire t/nos: BK274399 and BK26127 floating charge over the whole of the company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Mai 1996
    Geliefert am 30. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (including this debenture)
    Kurze Angaben
    2 richard avenue brightlingsea essex including fixtures and fittings and f/h or l/h property all right title & interest in the real property the benefit of all rights and claims the insurance policies all book & other debts and a floating charge over .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transaktionen
    • 30. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Nov. 1995
    Geliefert am 30. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 3 madeley drive west kirby wirral merseyside t/no MS155589 with all fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 1995
    Geliefert am 05. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the finance documents (including this debenture)
    Kurze Angaben
    8 wellesley court west parade worthing t/n-WSX26301. Flat 3 castle court river park marlborough wiltshire west kennett t/n-WT101180. Gathorne 24 walmers avenue higham nr rochester kent t/n-K133345.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    Transaktionen
    • 05. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 1995
    Geliefert am 06. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the finance documents (as defined) and/or this debenture
    Kurze Angaben
    The company as beneficial owner hereby charges by fixed charge in favour of the trustee with the payment and discharge of the secured obligations by way of (a) first legal mortgage over the real property; and (b) first equitable charge over its right title and interest in the real property. And by way of first floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future other than any assets for the time being effectively charged to the trustee by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security account agreement
    Erstellt am 24. März 1995
    Geliefert am 04. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    All the companys interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence od the security account agreement standing to the credit of (a) the security account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the security account agreement.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Faciltiy Agreement))
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Collection account agreement
    Erstellt am 24. März 1995
    Geliefert am 04. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence of the collection account agreement standing to the credit of (a) the collection account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the collection account agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Juli 1981
    Geliefert am 13. Juli 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold & leasehold property fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including & goodwill bookdebts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 1981Registrierung einer Belastung

    Hat NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Aug. 2014Beginn der Liquidation
    26. Dez. 2014Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Graham White
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0