NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01530074 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GE LIFE RESIDENTIAL LIMITED | 18. Okt. 1999 | 18. Okt. 1999 |
STALWART RESIDENTIAL LIMITED | 22. Nov. 1994 | 22. Nov. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Windsor House Telford Centre Telford Shropshire TF3 4NB zum 30 Finsbury Square London EC2P 2YU am 22. Aug. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Windsor House Telford Centre Telford TF3 4NB geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 25 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roger Craine als Geschäftsführer am 04. Okt. 2010 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Michael Charles Woodcock als Direktor am 04. Okt. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Roger Craine am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAKESPEARE, Paul | Sekretär | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | British | 135096740002 | ||||||
WOODCOCK, Michael Charles | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | England | British | Accountant | 102653720001 | ||||
BASARAN, Sandra Judith | Sekretär | Silveroaks 101 Copsewood Way HA6 2TU Northwood Middlesex | British | Lawyer | 150997870001 | |||||
CHAMBERS, Mark Richard | Sekretär | 6 Southern Road N2 9LE London | British | 69321020002 | ||||||
DUGGAN, Helen | Sekretär | 115 Elms Crescent SW4 8QG London | British | Solicitor | 67744330001 | |||||
FULLER, Michael John | Sekretär | Tudor Lodge Birds Hill Road KT22 0NJ Oxshott Surrey | British | 14453100001 | ||||||
HARDING, Barrington Howard | Sekretär | 29 Mayford Road SW12 8SE London | British | 11466730001 | ||||||
OPPAL, Abdul Munem | Sekretär | 213 Wauluds Bank Drive LU3 3NE Luton Bedfordshire | British | 116338770001 | ||||||
PEARSON, Michael Adrian | Sekretär | 34 Lammas Gate ME13 7ND Faversham Kent | British | Solicitor | 59751140001 | |||||
TEMPLETON, William James, Dr | Sekretär | 3 Royal Crescent W11 4SL London | New Zealander | Chartered Accountant | 27024160001 | |||||
THOMAS, Derek John | Sekretär | Woodlands Chapel Lane SO43 7FG Lyndhurst Hampshire | British | 2297010001 | ||||||
WELCH, Gaynor Jill | Sekretär | Heronswood Eyhurst Close KT20 6NR Kingswood Surrey | British | Company Secretary | 87931760001 | |||||
ARTHUR, Richard | Geschäftsführer | 17d Highgate West Hill N6 6NP London | British | Investment Director | 71058650001 | |||||
BARRETT, Peter | Geschäftsführer | 24 Britts Farm Road TN22 4LZ Buxted East Sussex | British | Manager | 75515090001 | |||||
BARTLETT, John Leonard | Geschäftsführer | Chiphall Cottage Droxford Road Wickham PO17 5AZ Fareham Hampshire | British | Consultant | 14120450001 | |||||
BASARAN, Sandra Judith | Geschäftsführer | Silveroaks 101 Copsewood Way HA6 2TU Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Lawyer | 150997870001 | ||||
BOUSFIELD, Clare Jane | Geschäftsführer | 30 St Mary Axe EC3A 8EP London | Switzerland | British | Company Director | 106900580001 | ||||
CARROLL, Timothy Joseph | Geschäftsführer | 30 St Mary Axe EC3A 8EP London | Uk | Irish | Director | 63716360005 | ||||
COWDERY, Clive Adam | Geschäftsführer | 38 Bradbourne Street SW6 3TE London | British | Chief Executive | 88183990001 | |||||
CRAINE, Roger | Geschäftsführer | Telford Centre TF3 4NB Telford Windsor House Shropshire | United Kingdom | British | Accountant | 89585440001 | ||||
DAVIES, Roger William | Geschäftsführer | The Hollies 42 High Street Tarring BN14 7NR Worthing West Sussex | British | Actuary | 21933520001 | |||||
DICKINSON, Stephen | Geschäftsführer | Chaucer Buildings 57 Grainger Street NE1 5LE Newcastle Upon Tyne | British | Company Director | 14120430001 | |||||
DOLFI, Douglas Scott | Geschäftsführer | 5 Ladbroke Walk W11 3PW London | American | Director | 78292660001 | |||||
DOWNEY, Paul Martin | Geschäftsführer | 18 Rowan Grove St Ippolyts SG4 7SP Hitchin Hertfordshire | British | Actuary | 10360260002 | |||||
EVANS, David Thomas James | Geschäftsführer | Sandrock, Lower Street Fittleworth RH20 1JE Pulborough West Sussex | United Kingdom | British | Director | 62761080001 | ||||
FULLER, Michael John | Geschäftsführer | Tudor Lodge Birds Hill Road KT22 0NJ Oxshott Surrey | British | Actuary | 14453100001 | |||||
GIRLING, Michael | Geschäftsführer | Collingwood Mount Cottage Loddon Close GU15 1LJ Camberley Surrey | British | Sales Director | 63304110001 | |||||
HAMMOND, Anthony | Geschäftsführer | Berkeley Lodge Ashley Park Avenue KT12 1EU Walton On Thames Surrey | British | Operations Director | 52752380001 | |||||
HAYNES, Stephen Robert | Geschäftsführer | 27 West Road CB11 3DS Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | Director | 79961770002 | ||||
HOWE, Robert William Albert | Geschäftsführer | 30 St Mary Axe EC3A 8EP London | Uk | British | Group Chief Actuary | 13105310003 | ||||
HUGHFF, Victor William | Geschäftsführer | 18 Hilly Plantation NR7 0JN Norwich Norfolk | British | Actuary | 6622110001 | |||||
MCLAY, William Morrison | Geschäftsführer | 26 Sheppey Walk BN27 3BR Hailsham East Sussex | British | Sales Manager | 54996780001 | |||||
MORGAN, Christopher | Geschäftsführer | 13 Laurel Road Barnes SW13 0EE London | United Kingdom | British | Company Director | 33875890001 | ||||
NARRAWAY, Nicholas William | Geschäftsführer | Waverley Cottage Birtley Road Bramley GU5 0JA Guildford Surrey | British | Solicitor | 72113010001 | |||||
RAAB, Dennis Lynn | Geschäftsführer | Glendale House Woodlands Ride SL5 9HN South Ascot Berkshire | American | Finance Director | 48186120003 |
Hat NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 21. März 1997 Geliefert am 09. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 24TH march 1995 | |
Kurze Angaben L/H property k/a 5 wantage road, reading berkshire; f/h property k/a 3 wantage road, reading, berkshire t/nos: BK274399 and BK26127 floating charge over the whole of the company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Mai 1996 Geliefert am 30. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (including this debenture) | |
Kurze Angaben 2 richard avenue brightlingsea essex including fixtures and fittings and f/h or l/h property all right title & interest in the real property the benefit of all rights and claims the insurance policies all book & other debts and a floating charge over .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Nov. 1995 Geliefert am 30. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 3 madeley drive west kirby wirral merseyside t/no MS155589 with all fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Juni 1995 Geliefert am 05. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the finance documents (including this debenture) | |
Kurze Angaben 8 wellesley court west parade worthing t/n-WSX26301. Flat 3 castle court river park marlborough wiltshire west kennett t/n-WT101180. Gathorne 24 walmers avenue higham nr rochester kent t/n-K133345.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. März 1995 Geliefert am 06. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the finance documents (as defined) and/or this debenture | |
Kurze Angaben The company as beneficial owner hereby charges by fixed charge in favour of the trustee with the payment and discharge of the secured obligations by way of (a) first legal mortgage over the real property; and (b) first equitable charge over its right title and interest in the real property. And by way of first floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future other than any assets for the time being effectively charged to the trustee by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security account agreement | Erstellt am 24. März 1995 Geliefert am 04. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined) | |
Kurze Angaben All the companys interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence od the security account agreement standing to the credit of (a) the security account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the security account agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collection account agreement | Erstellt am 24. März 1995 Geliefert am 04. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined) | |
Kurze Angaben All the company's interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence of the collection account agreement standing to the credit of (a) the collection account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the collection account agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 07. Juli 1981 Geliefert am 13. Juli 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold & leasehold property fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including & goodwill bookdebts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0