AF REALISATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AF REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01531702 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AF REALISATIONS LIMITED?
- Herstellung von Befestigungselementen und Schraubmaschinenprodukten (25940) / Verarbeitendes Gewerbe
- Herstellung von anderen Metallwaren (25990) / Verarbeitendes Gewerbe
- Großhandel mit Eisenwaren, Sanitär- und Heizungsbedarf (46740) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich AF REALISATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Moorend House Snelsins Lane BD19 3UE Cleckheaton |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AF REALISATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ANDREWS FASTENERS LIMITED | 07. Nov. 1983 | 07. Nov. 1983 |
| ANDREWS TOOLS AND FASTENERS (LEEDS) LTD | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| DAYAWAY LIMITED | 02. Dez. 1980 | 02. Dez. 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AF REALISATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AF REALISATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 25 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 8 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Aug. 2019 | 26 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Aug. 2018 | 25 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 15 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 15 Seiten | AM22 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Denham als Sekretär am 01. März 2017 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Jan. 2017 | 9 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Juli 2016 | 9 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Jan. 2016 | 9 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Juli 2015 | 16 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 33 Seiten | 2.23B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 8 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 32 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 8 Latchmore Park Latchmore Road Leeds Yorkshire LS12 6DN zum Moorend House Snelsins Lane Cleckheaton BD19 3UE am 28. Jan. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed andrews fasteners LIMITED\certificate issued on 19/01/15 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AF REALISATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREY, Michael Robson | Geschäftsführer | Snelsins Lane BD19 3UE Cleckheaton Moorend House | England | British | 110593220002 | |||||
| CONNER, Eileen | Sekretär | 1 Kipling Drive SW19 1TJ Wimbledon | British | 89546940001 | ||||||
| DENHAM, Joanne | Sekretär | Camberley Way Pudsey LS28 8QX Leeds 19 West Yorkshire | British | 188654670001 | ||||||
| HAGUE, David Michael | Sekretär | Applecroft Spoonley Gate Rudge Pattingham WV6 7ED Wolverhampton | British | 45671950001 | ||||||
| HALL, Robert John | Sekretär | 52 West End Road Epworth DN9 1LB Doncaster South Yorkshire | British | 76827960001 | ||||||
| KRAUSE, Patricia | Sekretär | 42 King Ecgbert Road Dore S17 3QR Sheffield Yorkshire | British | 88921990001 | ||||||
| LAWTON, Kirsten | Sekretär | 31 Orchard Avenue KT7 0BB Thames Ditton Surrey | British | 50045660001 | ||||||
| RIDGEWAY, Kevin Stuart | Sekretär | 5 Newland Gardens Newbold S41 7BD Chesterfield Derbyshire | British | 73705320001 | ||||||
| SANDERSON, Gary | Sekretär | Cliffhurst 46 Rectory Road Duckmanton S44 5JP Chesterfield Derbyshire | British | 19581810003 | ||||||
| SPEDDING, Gary James | Sekretär | 3 Alderley Close SK12 1XA Poynton Cheshire | British | 76827940001 | ||||||
| BATTENSBY, Mark | Geschäftsführer | 36 Valley Road Bramley LS13 1EZ Leeds West Yorkshire | British | 76827890001 | ||||||
| BUDD, Jonathan William | Geschäftsführer | 1 Quayside Mews WA13 0HZ Lymm Cheshire | British | 14530230001 | ||||||
| GEARTY, Anthony John | Geschäftsführer | Long Acres Poole Lane LS25 5JU Burton Salmon West Yorkshire | England | Irish | 127463800002 | |||||
| GRINDY, Roger Sydney | Geschäftsführer | 2 Woodmancourt GU7 2BT Godalming Surrey | British | 8369140001 | ||||||
| HAGUE, David Michael | Geschäftsführer | Applecroft Spoonley Gate Rudge Pattingham WV6 7ED Wolverhampton | British | 45671950001 | ||||||
| HALL, Robert John | Geschäftsführer | 52 West End Road Epworth DN9 1LB Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | 76827960001 | |||||
| KRAUSE, Patricia | Geschäftsführer | 42 King Ecgbert Road Dore S17 3QR Sheffield Yorkshire | United Kingdom | British | 88921990001 | |||||
| LOVERIDGE, Keith | Geschäftsführer | 4 Swannington Close Whitehill Cantley DN4 6UA Doncaster South Yorkshire | British | 76827920001 | ||||||
| MCINNES, Bruce Gordon, Doctor | Geschäftsführer | 5 Paget Place Warren Road KT2 7HZ Coombe Hill Surrey | British | 2311870001 | ||||||
| PANTRY, Malcolm Swaine | Geschäftsführer | 33 Berwick Close Walton S40 3NY Chesterfield Derbyshire | British | 37363480001 | ||||||
| PERKINS, John Anthony | Geschäftsführer | Elangeni 20 Esher Place Avenue KT10 8PY Esher Surrey | Irish | 1809090001 | ||||||
| SANDERSON, Gary | Geschäftsführer | Cliffhurst 46 Rectory Road Duckmanton S44 5JP Chesterfield Derbyshire | British | 19581810003 | ||||||
| SMITH, David Dallas | Geschäftsführer | 44 Hotham Road Putney SW15 1QJ London | British | 36289330001 | ||||||
| SPEDDING, Gary James | Geschäftsführer | 3 Alderley Close SK12 1XA Poynton Cheshire | British | 76827940001 | ||||||
| SURR, Robin | Geschäftsführer | Manor Road S60 5HF Brinsworth 12 South Yorkshire | England | British | 133505110001 | |||||
| WILKINSON, Stephen Philip | Geschäftsführer | 8 Norton Mews Norton S8 8HN Sheffield | England | British | 35390660002 | |||||
| BAKER STREET CORPORATE SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Surrey | 50433100001 | |||||||
| COACH HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Surrey | 43767230002 |
Hat AF REALISATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 31. Dez. 2014 Geliefert am 06. Jan. 2015 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Lease | Erstellt am 13. Sept. 2006 Geliefert am 18. Sept. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £17,331.25 including a sum equal to vat. The amount from time to time held in the deposit account for the credit of the tenant ("the deposit balance"). The amount from time to time standing to the credit of the deposit balance. All interest credited to the deposit balance from time to time. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 05. Nov. 2004 Geliefert am 10. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from andrews fasteners limited and andfast trading company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Okt. 2004 Geliefert am 28. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 16. Nov. 2001 Geliefert am 21. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb re andrews fasteners limited and numbered 6311907 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 04. Juli 2001 Geliefert am 12. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the financing agreement | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of offset | Erstellt am 16. Sept. 1992 Geliefert am 05. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee. | |
Kurze Angaben The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of andrews fasteners limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of offset | Erstellt am 24. Jan. 1991 Geliefert am 31. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee. | |
Kurze Angaben The balances at credit of any accounts held by the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of offset | Erstellt am 02. Okt. 1990 Geliefert am 10. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of andrews fasteners limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Okt. 1990 Geliefert am 10. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 30. Sept. 1986 Geliefert am 08. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £164,744 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital. Fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Apr. 1984 Geliefert am 04. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £16,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. Uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat AF REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0