TROPICAL PLACES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TROPICAL PLACES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01537457 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TROPICAL PLACES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TROPICAL PLACES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Wigmore House Wigmore Lane LU2 9TN Luton Bedfordshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TROPICAL PLACES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CRYSTAL HOLIDAYS LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| SHAWS HOLIDAYS LIMITED | 07. Jan. 1981 | 07. Jan. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TROPICAL PLACES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TROPICAL PLACES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Change of details for Specialist Holidays Group Limited as a person with significant control on 02. Okt. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tui Travel House Crawley Business Quarter Fleming Way Crawley West Sussex RH10 9QL zum Wigmore House Wigmore Lane Luton Bedfordshire LU2 9TN am 02. Okt. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joyce Walter als Sekretär am 18. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joyce Walter als Geschäftsführer am 25. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Stephen John Brann als Direktor am 23. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Mai 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michelle Haddon als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Sharon Louise Barter als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TROPICAL PLACES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTER, Sharon Louise | Geschäftsführer | Wigmore Lane LU2 9TN Luton Wigmore House Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | English | 171494170001 | |||||
| BRANN, Stephen John | Geschäftsführer | Wigmore Lane LU2 9TN Luton Wigmore House Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 153081020001 | |||||
| APPLETON, Andy | Sekretär | Meadow View The Hydons GU8 4DD Hydestile Surrey | British | 83096860001 | ||||||
| CHURCHILL COLEMAN, Richard Paul | Sekretär | 4 St James Road AL5 4NY Harpenden Hertfordshire | British | 92560480002 | ||||||
| ITANI, Avril Dawn | Sekret är | 78 Burden Way Worplesdon GU2 9RD Guildford Surrey | British | 97394080001 | ||||||
| RUSSELL, Angela | Sekretär | 22 Bishops Close EN5 2QH Barnet Hertfordshire | British | 776080002 | ||||||
| WALTER, Joyce | Sekretär | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way Crawley West Sussex | British | 76169540002 | ||||||
| APPLETON, Andy | Geschäftsführer | Meadow View The Hydons GU8 4DD Hydestile Surrey | United Kingdom | British | 83096860001 | |||||
| BLAKEY, Ronald Edward | Geschäftsführer | 20 Chestnut Grove GU13 9BW Fleet Hampshire | British | 2278700002 | ||||||
| BRIGHAM, Clive Vivian | Geschäftsführer | Foresters Cottage Gillhams Lane GU27 3ND Haslemere Surrey | British | 13648720003 | ||||||
| CHURCHILL COLEMAN, Richard Paul | Geschäftsführer | 4 St James Road AL5 4NY Harpenden Hertfordshire | British | 92560480002 | ||||||
| DRAKE, David | Geschäftsführer | 25 York Close Southwater RH13 7XJ Horsham West Sussex | British | 15937400001 | ||||||
| DYER, Peter Raymond | Geschäftsführer | Sopers Barn Fernhurst GU27 3DY Haslemere Surrey | England | British | 152093610001 | |||||
| EMERSIC, Darko | Geschäftsführer | Hilldown Highfield Lane Thursley Godalming Surrey | British | 15413300001 | ||||||
| FARMER, Haydn Paul | Geschäftsführer | 34 Emmerson Avenue CV37 9DX Stratford Upon Avon | United Kingdom | British | 45423020003 | |||||
| HADDON, Michelle | Geschäftsführer | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 168129060001 | |||||
| JOHNSON, Martin | Geschäftsführer | Kent Cottage Barden Road Speldhurst TN3 0LE Tunbridge Wells Kent | British | 2278710001 | ||||||
| MALONEY, David Ossian | Geschäftsführer | 64 Ledborough Lane HP9 2DG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 69071800002 | |||||
| MATTISON, David Harris | Geschäftsführer | 6 Eastcote View HA5 1AT Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 8847140001 | |||||
| PERRIN, Andrew | Geschäftsführer | Barnwood Hogwood Road RH14 0UG Ifold West Sussex | United Kingdom | British | 152087300001 | |||||
| RAGO, Nicholas Anthony | Geschäftsführer | 4402 Monlight Way Paradise Valley Arizona 85253 Usa | American | 36639570001 | ||||||
| ROWE, David John | Geschäftsführer | 12 The Grange Wimbledon SW19 4PT London | England | British | 142613190001 | |||||
| RUSSELL, Angela | Geschäftsführer | 22 Bishops Close EN5 2QH Barnet Hertfordshire | British | 776080002 | ||||||
| SMART, Christopher David | Geschäftsführer | Nettlefolds Chelwood Vachery TN22 3HR Nutley East Sussex | British | 27386820003 | ||||||
| TEETS, John William | Geschäftsführer | 5303 Desert Park Lane Scottsdale Valley Arizona Usa | American | 33571380001 | ||||||
| TYMMS, Paul Robert | Geschäftsführer | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way Crawley West Sussex | British | 121957630001 | ||||||
| WALTER, Joyce | Geschäftsführer | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 76169540003 | |||||
| ZWICK, Gerald George | Geschäftsführer | 24243 North 82nd Place FOREIGN Scottsdale Arizona 85255 Usa | American | 27041440001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TROPICAL PLACES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialist Holidays Group Limited | 06. Apr. 2016 | Wigmore Lane LU2 9TN Luton Wigmore House Bedfordshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat TROPICAL PLACES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 20. März 1991 Geliefert am 03. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The courtyard, arlington road, surbiton, kingston upon thames t/n SGL248188. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Nov. 1989 Geliefert am 07. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The courtyard arlington road surbiton r/b kingston upon thames t/n SGL248188. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 17. Nov. 1989 Geliefert am 08. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re. Crystal holidays LTD. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 29. Sept. 1986 Geliefert am 03. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys from time to time held & the credit of the company by the bank on any current deposit and/or other account or accounts which the company may now and/or hereafter have with the bank or held by the bank on an account or accounts earmarked re the company under any depostireceipt. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 16. Juli 1986 Geliefert am 21. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys need to the credit of the company by national westminster bank & c or any current (s) which the company may with the bank or held by the bank on an account (s) earmarked re the company and/or under any deposit receipt. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Mai 1986 Geliefert am 20. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land 3 arlington road now known as the courtyard arlington road kingston-upon-thames surrey KT6 6BW t/n sgl 248188 & sy 296332 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 20. Sept. 1985 Geliefert am 25. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies from time to time held to the credit of the company by national westminster bank PLC on any current/deposit and/or other account. Full details see doc M27. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 20. Juni 1985 Geliefert am 05. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys from time to time held to the credit of the company by national westminster bank PLC on any current deposit/and or other account or accounts which the company may have with the bank or heldby the bank on an account or accounts carmarked re the company and/or under any deposit receipt. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 11. Sept. 1984 Geliefert am 18. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any moneys now at hereafter standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC & all interest of the company therein & all interest (if any) now due in respect thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 09. Mai 1984 Geliefert am 10. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Cash held at lloyds bank, 3, st georges rd wimbledon SW19 4DR on account no 0322799. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0